SALEHURST LIMITED

  • Panoramica
  • Riepilogo
  • Scopo
  • Indirizzo
  • Denominazioni precedenti
  • Bilanci
  • Deposizioni
  • Amministratori
  • Ipoteche
  • Fonte dati
  • Panoramica

    Nome della societàSALEHURST LIMITED
    Stato della societàSciolta
    Forma giuridicaSocietà a responsabilità limitata
    Numero di società 01761563
    GiurisdizioneInghilterra/Galles
    Data di costituzione
    Data di cessazione

    Qual è lo scopo di SALEHURST LIMITED?

    • (9999) /

    Dove si trova SALEHURST LIMITED?

    Indirizzo della sede legale
    Brunswick House Regent Park
    299 Kingston Road
    KT22 7LU Leatherhead
    Surrey
    Indirizzo della sede legale non recapitabileNo

    Quali erano i nomi precedenti di SALEHURST LIMITED?

    Denominazioni sociali precedenti
    Nome della societàDaA
    SALEHURST PAPER LIMITED11 lug 199411 lug 1994
    SALEHURST PAPER COMPANY LIMITED 31 gen 198431 gen 1984
    LEGIBUS 375 LIMITED14 ott 198314 ott 1983

    Quali sono gli ultimi bilanci di SALEHURST LIMITED?

    Ultimi bilanci
    Ultimi bilanci redatti al31 dic 2009

    Quali sono le ultime deposizioni per SALEHURST LIMITED?

    Deposizioni
    DataDescrizioneDocumentoTipo

    Gazzetta Ufficiale finale sciolta per scioglimento volontario

    1 pagineGAZ2(A)

    Prima Gazzetta Ufficiale per lo scioglimento volontario

    1 pagineGAZ1(A)

    Richiesta di cancellazione della società dal registro

    3 pagineDS01

    Bilancio redatto al 31 dic 2009

    9 pagineAA

    legacy

    2 pagine288c

    legacy

    4 pagine363a

    legacy

    1 pagine288c

    Bilancio redatto al 31 dic 2008

    10 pagineAA

    legacy

    4 pagine363a

    Bilancio redatto al 31 dic 2007

    8 pagineAA

    legacy

    3 pagine363a

    legacy

    1 pagine288c

    Bilancio redatto al 31 dic 2006

    9 pagineAA

    legacy

    2 pagine288a

    legacy

    1 pagine288b

    legacy

    2 pagine288a

    Bilancio redatto al 31 dic 2005

    12 pagineAA

    legacy

    3 pagine363a

    Bilancio modificato redatto al 31 dic 2004

    15 pagineAAMD

    legacy

    7 pagine363s

    legacy

    pagine363(288)

    Bilancio redatto al 31 dic 2004

    15 pagineAA

    Bilancio redatto al 31 gen 2004

    17 pagineAA

    legacy

    1 pagine288b

    legacy

    1 pagine244

    Chi sono gli amministratori di SALEHURST LIMITED?

    Amministratori
    NomeNominato ilDimissioni ilRuoloIndirizzoIdentificazione della societàPaese di residenzaNazionalitàData di nascitaProfessioneNumero
    MCCANN, Denise Helen
    29 Gordon Drive
    KT16 9PP Chertsey
    Surrey
    Segretario
    29 Gordon Drive
    KT16 9PP Chertsey
    Surrey
    British22407430001
    BLAKEY, Dominic Karl Kristian
    Albany Mansions
    Albert Bridge Road
    SW11 4PG London
    53
    Uk
    Amministratore
    Albany Mansions
    Albert Bridge Road
    SW11 4PG London
    53
    Uk
    United KingdomBritish65589710005
    CADOT, Daniel Geoffroy
    25 Rue De Tocqueville
    FOREIGN Paris
    75017
    Amministratore
    25 Rue De Tocqueville
    FOREIGN Paris
    75017
    French87983870001
    SPIKESMAN, Roger James
    9 The Copse
    CR3 6DU Caterham
    Surrey
    Amministratore
    9 The Copse
    CR3 6DU Caterham
    Surrey
    United KingdomBritish17563490003
    GOLD, Simon David
    11 Sandy Lodge
    Avenue Road
    N6 5DQ London
    Segretario
    11 Sandy Lodge
    Avenue Road
    N6 5DQ London
    British62560450001
    HODGSON, Philip Bruce
    24a Broadwater Down
    TN2 5NR Tunbridge Wells
    Kent
    Segretario
    24a Broadwater Down
    TN2 5NR Tunbridge Wells
    Kent
    British44559700001
    JACKSON, Michael Francis
    Higham House
    TN32 5PS Salehurst
    East Sussex
    Segretario
    Higham House
    TN32 5PS Salehurst
    East Sussex
    British25066620001
    MOYS, Peter John
    163 Orchard Row Cottages
    Quality Street
    RH1 3BD Merstham
    Surrey
    Segretario
    163 Orchard Row Cottages
    Quality Street
    RH1 3BD Merstham
    Surrey
    British11116340002
    WALSH, Andrew Jeffrey
    5 Thurlow Close
    SG1 4SD Stevenage
    Hertfordshire
    Segretario
    5 Thurlow Close
    SG1 4SD Stevenage
    Hertfordshire
    British42933190001
    BLYTH, Terence Edwin
    Rust En Vrede 4 The Laurels
    Potten End
    HP4 2SP Berkhamsted
    Hertfordshire
    Amministratore
    Rust En Vrede 4 The Laurels
    Potten End
    HP4 2SP Berkhamsted
    Hertfordshire
    EnglandBritish14403470001
    DODGE, Kenneth George
    68 Avondale Avenue
    Hinchley Wood
    KT10 0DA Esher
    Surrey
    Amministratore
    68 Avondale Avenue
    Hinchley Wood
    KT10 0DA Esher
    Surrey
    British36907830002
    FOAKES, David Arthur
    The Old Rectory
    New Church Road West Bergholt
    CO6 3JF Colchester
    Essex
    Amministratore
    The Old Rectory
    New Church Road West Bergholt
    CO6 3JF Colchester
    Essex
    EnglandBritish90351200001
    GOLD, Simon David
    11 Sandy Lodge
    Avenue Road
    N6 5DQ London
    Amministratore
    11 Sandy Lodge
    Avenue Road
    N6 5DQ London
    British62560450001
    HUIE, Joyce
    82 Darcy Road
    SW16 4UA London
    Amministratore
    82 Darcy Road
    SW16 4UA London
    British65589740001
    JACKSON, Michael Francis
    Higham House
    TN32 5PS Salehurst
    East Sussex
    Amministratore
    Higham House
    TN32 5PS Salehurst
    East Sussex
    British25066620001
    MOYS, Peter John
    163 Orchard Row Cottages
    Quality Street
    RH1 3BD Merstham
    Surrey
    Amministratore
    163 Orchard Row Cottages
    Quality Street
    RH1 3BD Merstham
    Surrey
    British11116340002
    MUNDAY, Steven Michael
    The Grange Town Road
    Cliffe
    ME3 7RL Rochester
    Kent
    Amministratore
    The Grange Town Road
    Cliffe
    ME3 7RL Rochester
    Kent
    EnglandBritish79673180001
    PALMER, Christopher Jon
    Cymbeline
    Ellesborough Road
    HP17 0XH Ellesborough
    Buckinghamshire
    Amministratore
    Cymbeline
    Ellesborough Road
    HP17 0XH Ellesborough
    Buckinghamshire
    United KingdomBritish109674220001
    VALENTINE, Matthew
    62 Hodford Road
    NW11 8NJ London
    Amministratore
    62 Hodford Road
    NW11 8NJ London
    United KingdomBritish114122120001
    WALSH, Andrew Jeffrey
    5 Thurlow Close
    SG1 4SD Stevenage
    Hertfordshire
    Amministratore
    5 Thurlow Close
    SG1 4SD Stevenage
    Hertfordshire
    British42933190001

    SALEHURST LIMITED ha ipoteche?

    Ipoteche
    ClassificazioneDateStatoDettagli
    Debenture
    Creato il 25 feb 2004
    Consegnato il 04 mar 2004
    In corso
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Gmac Commercial Finance PLC
    Transazioni
    • 04 mar 2004Registrazione di un'ipoteca (395)
    All assets debenture
    Creato il 05 apr 2001
    Consegnato il 06 apr 2001
    In corso
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Persone aventi diritto
    • Lloyds Tsb Commercial Finance Limited
    Transazioni
    • 06 apr 2001Registrazione di un'ipoteca (395)
    Composite guarantee and debenture
    Creato il 17 set 1999
    Consegnato il 23 set 1999
    Parzialmente soddisfatta
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company and/or all or any of the other companies named therein to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transazioni
    • 23 set 1999Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 20 feb 2004Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Composite guarantee and debenture
    Creato il 14 lug 1999
    Consegnato il 20 lug 1999
    Parzialmente soddisfatta
    Importo garantito
    All indebtedness liabilities and obligations due or to become due from any group company (as defined) to the chargee under the revolving credit facility (as defined) whether pursuant to the guarantee (as defined) or otherwise and on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Land and buildings on the northwest side of morley street l/b of lambeth t/no: tgl 13984 .. fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transazioni
    • 20 lug 1999Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 20 feb 2004Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Deed of charge
    Creato il 29 lug 1997
    Consegnato il 07 ago 1997
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    First fixed charge all book and other debts now and from time to time due or owing to the company and all monies in respect thereof. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Barclays Bank PLC
    Transazioni
    • 07 ago 1997Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 04 ago 1999Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Legal charge
    Creato il 20 dic 1996
    Consegnato il 08 gen 1997
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Property k/a land and buildings on the north west side of morley street london borough of lambeth t/n tgl 13984.
    Persone aventi diritto
    • Barclays Bank PLC
    Transazioni
    • 08 gen 1997Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 24 apr 1997Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Book debts debenture deed
    Creato il 08 ott 1996
    Consegnato il 09 ott 1996
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    First fixed charge all book and other debts of the company present and future (save for those sold by the company and purchased by the securityholder in accordance with the financing agreement). See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Tsb Commercial Finance Limited
    Transazioni
    • 09 ott 1996Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 04 ago 1999Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Debenture
    Creato il 05 mar 1992
    Consegnato il 07 mar 1992
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee
    Brevi particolari
    Fixed and floating charge over the including goodwill and bookdebts. Undertaking and all property and assets.
    Persone aventi diritto
    • Nita Christine Jacksongreat Marlborough Street Pension Trustees Limited
    • Michael Francis Jackson
    Transazioni
    • 07 mar 1992Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 20 nov 1993Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Mortgage debenture
    Creato il 13 feb 1987
    Consegnato il 18 feb 1987
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    A specific equitable charge over all freehold and leasehold properties and/or the proceeds of sale thereof fixed and floating charges over undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts and the benefits of any licences.
    Persone aventi diritto
    • National Westminster Bank PLC
    Transazioni
    • 18 feb 1987Registrazione di un'ipoteca
    • 24 apr 1997Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)

    Fonte dati

    • Companies House del Regno Unito
      Il registro ufficiale delle imprese nel Regno Unito, che fornisce l'accesso pubblico alle informazioni sulle imprese, come nomi, indirizzi, amministratori e depositi finanziari.
    • Licenza: CC0