A.N.C. (SCOTLAND) LIMITED

A.N.C. (SCOTLAND) LIMITED

  • Panoramica
  • Riepilogo
  • Scopo
  • Indirizzo
  • Bilanci
  • Bilancio annuale
  • Deposizioni
  • Amministratori
  • Ipoteche
  • Insolvenza
  • Fonte dati
  • Panoramica

    Nome della societàA.N.C. (SCOTLAND) LIMITED
    Stato della societàSciolta
    Forma giuridicaSocietà a responsabilità limitata
    Numero di società 01762078
    GiurisdizioneInghilterra/Galles
    Data di costituzione
    Data di cessazione

    Qual è lo scopo di A.N.C. (SCOTLAND) LIMITED?

    • Società non commerciali (74990) / Attività professionali, scientifiche e tecniche

    Dove si trova A.N.C. (SCOTLAND) LIMITED?

    Indirizzo della sede legale
    Parkhouse East Industrial Estate
    Newcastle Under Lyme
    ST5 7RB Staffordshire
    Indirizzo della sede legale non recapitabileNo

    Quali sono gli ultimi bilanci di A.N.C. (SCOTLAND) LIMITED?

    Ultimi bilanci
    Ultimi bilanci redatti al31 mag 2013

    Qual è lo stato dell'ultimo bilancio annuale per A.N.C. (SCOTLAND) LIMITED?

    Bilancio annuale
    Ultimo bilancio annuale

    Quali sono le ultime deposizioni per A.N.C. (SCOTLAND) LIMITED?

    Deposizioni
    DataDescrizioneDocumentoTipo

    Gazzetta ufficiale finale sciolta a seguito di liquidazione

    1 pagineGAZ2

    Ritorno della riunione finale in una liquidazione volontaria dei membri

    5 pagine4.71

    Nomina di un liquidatore volontario

    1 pagine600

    Nomina di un liquidatore volontario

    1 pagine600

    Risoluzioni

    Resolutions
    1 pagineRESOLUTIONS
    Risoluzioni
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    liquidation

    Risoluzione speciale per la liquidazione

    LRESSP

    Dichiarazione di solvibilità

    3 pagine4.70

    Bilancio redatto al 31 mag 2013

    6 pagineAA

    Dettagli del direttore cambiati per Mr Roel Jos Coleta Staes il 26 lug 2013

    3 pagineCH01

    Bilancio annuale redatto al 01 mag 2013 con elenco completo degli azionisti

    15 pagineAR01
    Deposizioni associate
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    capital21 mag 2013

    Stato del capitale al 21 mag 2013

    • Capitale: GBP 8,100
    SH01

    Bilancio redatto al 31 mag 2012

    6 pagineAA

    Nomina di Roel Jos Coleta Staes come amministratore in data 03 apr 2012

    3 pagineAP01

    Bilancio annuale redatto al 01 mag 2012 con elenco completo degli azionisti

    15 pagineAR01

    Cessazione della carica di Mark Russell Allen come amministratore in data 30 mar 2012

    2 pagineTM01

    Bilancio redatto al 31 mag 2011

    6 pagineAA

    Bilancio annuale redatto al 01 mag 2011 con elenco completo degli azionisti

    15 pagineAR01

    Bilancio redatto al 31 mag 2010

    6 pagineAA

    Dettagli del direttore cambiati per Mark Russell Allen il 04 set 2010

    3 pagineCH01

    Cessazione della carica di Robert Elliott come amministratore

    2 pagineTM01

    Cessazione della carica di Kenneth Koval come amministratore

    2 pagineTM01

    Bilancio annuale redatto al 01 mag 2010 con elenco completo degli azionisti

    17 pagineAR01

    I registri sono stati trasferiti al luogo di ispezione registrato

    2 pagineAD03

    L'indirizzo di ispezione del registro è stato modificato

    2 pagineAD02

    Bilancio redatto al 31 mag 2009

    6 pagineAA

    Dettagli del direttore cambiati per Robert William Elliott il 15 dic 2006

    1 pagineCH01

    legacy

    7 pagine363a

    Chi sono gli amministratori di A.N.C. (SCOTLAND) LIMITED?

    Amministratori
    NomeNominato ilDimissioni ilRuoloIndirizzoIdentificazione della societàPaese di residenzaNazionalitàData di nascitaProfessioneNumero
    HAWKINS, James Edmund
    Anc Group Head Office
    Parkhouse East Industrial Estate
    ST5 7RB Newcastle
    Staffordshire
    Segretario
    Anc Group Head Office
    Parkhouse East Industrial Estate
    ST5 7RB Newcastle
    Staffordshire
    British101387860002
    PARROTT, Stephen John
    Matlock Road
    CV1 4JQ Coventry
    Sutherland House
    West Midlands
    Segretario
    Matlock Road
    CV1 4JQ Coventry
    Sutherland House
    West Midlands
    British48941480002
    HOLT, Michael John
    Anc Group Head Office
    Parkhouse East Industrial Estate
    ST5 7RB Newcastle
    Staffordshire
    Amministratore
    Anc Group Head Office
    Parkhouse East Industrial Estate
    ST5 7RB Newcastle
    Staffordshire
    United KingdomBritish121123210001
    STAES, Roel Jos Coleta
    Kantersteen 47
    1000 Brussels
    Federal Express Europe, Inc
    Belgium
    Amministratore
    Kantersteen 47
    1000 Brussels
    Federal Express Europe, Inc
    Belgium
    BelgiumBelgian170094650001
    DURACK, Sean Patrick
    4 Churchston Avenue
    Bramhall
    SK7 3DA Stockport
    Cheshire
    Segretario
    4 Churchston Avenue
    Bramhall
    SK7 3DA Stockport
    Cheshire
    British87327210001
    RONALD, Paul
    15 Arran Close
    Holmes Chapel
    CW4 7QP Crewe
    Cheshire
    Segretario
    15 Arran Close
    Holmes Chapel
    CW4 7QP Crewe
    Cheshire
    British71473700001
    TAYLOR, Michael John
    6 Garratts Lane
    SM7 2DZ Banstead
    Surrey
    Segretario
    6 Garratts Lane
    SM7 2DZ Banstead
    Surrey
    British64380001
    ALLEN, Mark Russell
    St.Goedeleplein 14
    1000 Brussels
    Federal Express Europe Inc.
    Belgium
    Amministratore
    St.Goedeleplein 14
    1000 Brussels
    Federal Express Europe Inc.
    Belgium
    BelgiumUnited States77781820007
    CALLAGHAN, Andrew Michael
    Graybrook Farm
    Middlewich Road
    WA16 9JQ Allostock
    Cheshire
    Amministratore
    Graybrook Farm
    Middlewich Road
    WA16 9JQ Allostock
    Cheshire
    British76165950001
    CRANMER, Charles David
    Parkhouse East Industrial Estate
    ST5 7RB Newcastle
    Staffordshire
    Amministratore
    Parkhouse East Industrial Estate
    ST5 7RB Newcastle
    Staffordshire
    British60508750002
    ELLIOTT, Robert William
    B-1420 Braine L'Alleud
    Avenue Des Champs 2
    Belgium
    Amministratore
    B-1420 Braine L'Alleud
    Avenue Des Champs 2
    Belgium
    American77782020004
    GITTINS, Jonathan Mark
    Anc Group Head Office
    Parkhouse East Industrial Estate
    ST5 7RB Newcastle
    Staffordshire
    Amministratore
    Anc Group Head Office
    Parkhouse East Industrial Estate
    ST5 7RB Newcastle
    Staffordshire
    British75431680002
    HAY, James Brian
    Fairways
    81 Allington Road Newick
    BN8 4ND Lewes
    East Sussex
    Amministratore
    Fairways
    81 Allington Road Newick
    BN8 4ND Lewes
    East Sussex
    British11163140001
    HENDERSON, John Iain
    12 Dale Street
    W4 2BL London
    Amministratore
    12 Dale Street
    W4 2BL London
    British38376070001
    KOVAL, Kenneth Francis
    23 Rue Leon Lepage
    B1000 Brussels
    Belgium
    Amministratore
    23 Rue Leon Lepage
    B1000 Brussels
    Belgium
    American118262180001
    MCCANN, Anthony Joseph
    12 Phillimore Gardens
    W8 7QD London
    Amministratore
    12 Phillimore Gardens
    W8 7QD London
    British20509810002
    PYWELL, Christopher Graham
    Highfield Farm Cobbs Lane
    Hough
    CW2 5JL Crewe
    Cheshire
    Amministratore
    Highfield Farm Cobbs Lane
    Hough
    CW2 5JL Crewe
    Cheshire
    United KingdomBritish37719690005
    SUTTON, Timothy James
    Holly Bank
    Queensway
    Knutsford
    Cheshire
    Amministratore
    Holly Bank
    Queensway
    Knutsford
    Cheshire
    British1278170001

    A.N.C. (SCOTLAND) LIMITED ha ipoteche?

    Ipoteche
    ClassificazioneDateStatoDettagli
    Guarantee and fixed and floating security document
    Creato il 25 set 2001
    Consegnato il 04 ott 2001
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All present and future moneys debts and liabilities due (including the guaranteed liabilities) owing or incurred by a chargor to any finance party (including the chargee as security trustee for the finance parties) under or in connection with any finance document (all terms as defined)
    Brevi particolari
    Including premises at unit 6 marston gate development site station rd brogborough milton keynes beds, f/h interest in premises on the south side of parkhouse road east bradwell newcastle under lyme t/no.SF245317, premises at unit 3 watchmoor point camberley, the parkland buildings k/a tangent point central way park royal london NW10 and unit 41 parkhouse industrial estate rosevale road newcastle under lyme staffs. Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • The Royal Bank of Scotland PLC
    Transazioni
    • 04 ott 2001Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 29 mar 2006Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Composite guarantee and debenture
    Creato il 26 mag 1995
    Consegnato il 09 giu 1995
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company and/or all or any of the other companies named therein to the chargee on any account whatsoever under the deed
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • The Royal Bank of Scotland PLC("the Security Trustee")
    Transazioni
    • 09 giu 1995Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 29 mar 2006Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Composite guarantee and debenture
    Creato il 26 mag 1995
    Consegnato il 08 giu 1995
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company and/or all or any of the other companies named therein to the chargee pursuant to an instrument dated 26TH may 1995 constituting £19,000,000 8 per cent secured loan stock 2004 to be issued by broomco (910) limited
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Montagu Equity Limitedas Agent for the Holders from Time to Time of the Stock
    Transazioni
    • 08 giu 1995Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 18 set 2001Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Guarantee & debenture
    Creato il 01 lug 1988
    Consegnato il 08 lug 1988
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company and/or stuntbrand limited (the 'agent'-as defined) for itself and as agent and trustee for the banks set out in the attached schedule here to under the the terms of the charge and the documents referred to therein
    Brevi particolari
    Stocks shares see doc for full details.. Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Persone aventi diritto
    • Creditorstalt Bank Verein
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    • Standard Chartered Bank
    • Barclays Bank PLC
    • Credit Lyonnais the Royal Bank of Scotland Plcand Any Other Bank Which May Assume Participation for the Purposes of the Acquisition Facility and/or the Working Capital Facilities.
    Transazioni
    • 08 lug 1988Registrazione di un'ipoteca
    • 14 gen 1994Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Single debenture
    Creato il 19 mag 1986
    Consegnato il 22 mag 1986
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Persone aventi diritto
    • Lloyds Bank PLC
    Transazioni
    • 22 mag 1986Registrazione di un'ipoteca
    Omnibus letter of set-off
    Creato il 19 mag 1986
    Consegnato il 22 mag 1986
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company and/or all or any of the other companies named therein to the chargee
    Brevi particolari
    Any sum or sums for the time being standing to the credit of any present or future account of the company with lloyds bank PLC.
    Persone aventi diritto
    • Lloyds Bank PLC
    Transazioni
    • 22 mag 1986Registrazione di un'ipoteca

    A.N.C. (SCOTLAND) LIMITED ha procedimenti di insolvenza?

    Numero di praticaDateTipoProfessionistiAltro
    1
    DataTipo
    20 mar 2014Inizio della liquidazione
    12 feb 2015Data di scioglimento
    Liquidazione volontaria dei soci
    NomeRuoloIndirizzoNominato ilCessato il
    Peter James Greaves
    7 More London Riverside
    SE1 2RT London
    Praticante
    7 More London Riverside
    SE1 2RT London
    Timothy Gerard Walsh
    Cornwall Court 19 Cornwall Street
    B3 2DT Birmingham
    Praticante
    Cornwall Court 19 Cornwall Street
    B3 2DT Birmingham

    Fonte dati

    • Companies House del Regno Unito
      Il registro ufficiale delle imprese nel Regno Unito, che fornisce l'accesso pubblico alle informazioni sulle imprese, come nomi, indirizzi, amministratori e depositi finanziari.
    • Licenza: CC0