MITEL HOSPITALITY COMMUNICATIONS 2 LIMITED

MITEL HOSPITALITY COMMUNICATIONS 2 LIMITED

  • Panoramica
  • Riepilogo
  • Scopo
  • Indirizzo
  • Denominazioni precedenti
  • Bilanci
  • Deposizioni
  • Amministratori
  • Persone con controllo significativo
  • Ipoteche
  • Fonte dati
  • Panoramica

    Nome della societàMITEL HOSPITALITY COMMUNICATIONS 2 LIMITED
    Stato della societàSciolta
    Forma giuridicaSocietà a responsabilità limitata
    Numero di società 01763604
    GiurisdizioneInghilterra/Galles
    Data di costituzione
    Data di cessazione

    Qual è lo scopo di MITEL HOSPITALITY COMMUNICATIONS 2 LIMITED?

    • Altre attività di telecomunicazioni (61900) / Informazione e comunicazione

    Dove si trova MITEL HOSPITALITY COMMUNICATIONS 2 LIMITED?

    Indirizzo della sede legale
    2 London Wall Place, 4th Floor
    EC2Y 5AU London
    United Kingdom
    Indirizzo della sede legale non recapitabileNo

    Quali erano i nomi precedenti di MITEL HOSPITALITY COMMUNICATIONS 2 LIMITED?

    Denominazioni sociali precedenti
    Nome della societàDaA
    TIGERTMS LIMITED17 feb 201017 feb 2010
    TELEPHONE MANAGEMENT SYSTEMS LIMITED25 nov 198725 nov 1987
    TELEPHONE MANAGEMENT LIMITED09 set 198709 set 1987
    BURGUNDY SECURITIES LIMITED02 dic 198302 dic 1983
    AFRICOURT LIMITED21 ott 198321 ott 1983

    Quali sono gli ultimi bilanci di MITEL HOSPITALITY COMMUNICATIONS 2 LIMITED?

    Ultimi bilanci
    Ultimi bilanci redatti al31 dic 2020

    Quali sono le ultime deposizioni per MITEL HOSPITALITY COMMUNICATIONS 2 LIMITED?

    Deposizioni
    DataDescrizioneDocumentoTipo

    Gazzetta Ufficiale finale sciolta per scioglimento volontario

    1 pagineGAZ2(A)

    Prima Gazzetta Ufficiale per lo scioglimento volontario

    1 pagineGAZ1(A)

    Richiesta di cancellazione della società dal registro

    3 pagineDS01

    Dichiarazione di conformità presentata il 15 feb 2022 senza aggiornamenti

    3 pagineCS01

    Indirizzo della sede legale modificato da 77-79 Christchurch Road Ringwood Hampshire BH24 1DH a 2 London Wall Place, 4th Floor London EC2Y 5AU in data 08 dic 2021

    1 pagineAD01

    Modifica dei dettagli di Mitel Hospitality Communications 1 Limited come persona con controllo significativo il 08 dic 2021

    2 paginePSC05

    Conto per una società dormiente redatto al 31 dic 2020

    7 pagineAA

    Dichiarazione di conformità presentata il 15 feb 2021 con aggiornamenti

    4 pagineCS01

    Conto per una società dormiente redatto al 31 dic 2019

    7 pagineAA

    Modifica dei dettagli di Connected Guests Ltd come persona con controllo significativo il 03 mar 2020

    2 paginePSC05

    Risoluzioni

    Resolutions
    3 pagineRESOLUTIONS
    Deposizioni associate
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    change-of-name03 mar 2020

    Cambio di nome" per delibera

    NM01
    Risoluzioni
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    change-of-name

    Risoluzione di cambio di nome della società il 03 mar 2020

    RES15

    Dichiarazione di conformità presentata il 15 feb 2020 senza aggiornamenti

    3 pagineCS01

    Conto per una società dormiente redatto al 31 dic 2018

    7 pagineAA

    Dichiarazione di conformità presentata il 15 feb 2019 con aggiornamenti

    4 pagineCS01

    Bilancio consolidato redatto al 31 dic 2017

    23 pagineAA

    Dichiarazione di conformità presentata il 15 feb 2018 con aggiornamenti

    4 pagineCS01

    Notifica di Connected Guests Ltd come persona con controllo significativo il 26 feb 2018

    2 paginePSC02

    Cessazione di Mitel Europe Limited come persona con controllo significativo il 26 feb 2018

    1 paginePSC07

    Bilancio consolidato redatto al 31 dic 2016

    31 pagineAA

    Cessazione della carica di Simon Mark Udell come amministratore in data 01 nov 2017

    1 pagineTM01

    Cessazione della carica di Simon Skellon come amministratore in data 31 ago 2017

    1 pagineTM01

    Nomina di Mr Simon Skellon come amministratore in data 16 giu 2017

    2 pagineAP01

    Cessazione della carica di James Andrew Evans come amministratore in data 16 giu 2017

    1 pagineTM01

    Dichiarazione di conformità presentata il 15 feb 2017 con aggiornamenti

    5 pagineCS01

    Nomina di Gregory J. Hiscock come segretario in data 01 giu 2015

    2 pagineAP03

    Chi sono gli amministratori di MITEL HOSPITALITY COMMUNICATIONS 2 LIMITED?

    Amministratori
    NomeNominato ilDimissioni ilRuoloIndirizzoIdentificazione della societàPaese di residenzaNazionalitàData di nascitaProfessioneNumero
    HISCOCK, Gregory J.
    Legget Drive
    K2K 2W7 Kanata
    350
    Ontario
    Canada
    Segretario
    Legget Drive
    K2K 2W7 Kanata
    350
    Ontario
    Canada
    224968320001
    HISCOCK, Gregory James
    Legget Drive
    K2K 2W7 Kanata
    350
    Ontario
    Canada
    Amministratore
    Legget Drive
    K2K 2W7 Kanata
    350
    Ontario
    Canada
    CanadaCanadian131825230002
    ARORA, Suman
    22 Kings Mews
    31 Poole Road Westbourne
    BH4 9DJ Bournemouth
    Dorset
    Segretario
    22 Kings Mews
    31 Poole Road Westbourne
    BH4 9DJ Bournemouth
    Dorset
    British36541950004
    ARORA, Suman
    22 Kings Mews
    31 Poole Road Westbourne
    BH4 9DJ Bournemouth
    Dorset
    Segretario
    22 Kings Mews
    31 Poole Road Westbourne
    BH4 9DJ Bournemouth
    Dorset
    British36541950004
    COMBEN, Roy Dennis
    Glencoe Blandford Road
    Bere Regis
    BH20 7JH Wareham
    Dorset
    Segretario
    Glencoe Blandford Road
    Bere Regis
    BH20 7JH Wareham
    Dorset
    British31144600001
    SEARBY, Robert Anthony
    5 Spinfield Lane West
    SL7 2DB Marlow
    Buckinghamshire
    Segretario
    5 Spinfield Lane West
    SL7 2DB Marlow
    Buckinghamshire
    British1737470007
    STRANGE, Elizabeth Ann
    20 Hynesbury Road
    Friars Cliff
    BH23 4ER Christchurch
    Dorset
    Segretario
    20 Hynesbury Road
    Friars Cliff
    BH23 4ER Christchurch
    Dorset
    British27737610001
    UDELL, Simon Mark
    Christchurch Road
    BH24 1DH Ringwood
    77-79
    Hampshire
    United Kingdom
    Segretario
    Christchurch Road
    BH24 1DH Ringwood
    77-79
    Hampshire
    United Kingdom
    147820350001
    WANKLYN, Stephen Richard
    52 Montacute Way
    Merley
    BH21 1TZ Wimborne
    Dorset
    Segretario
    52 Montacute Way
    Merley
    BH21 1TZ Wimborne
    Dorset
    British109848670001
    WANKLYN, Stephen Richard
    52 Montacute Way
    Merley
    BH21 1TZ Wimborne
    Dorset
    Segretario
    52 Montacute Way
    Merley
    BH21 1TZ Wimborne
    Dorset
    British109848670001
    ARORA, Suman
    22 Kings Mews
    31 Poole Road Westbourne
    BH4 9DJ Bournemouth
    Dorset
    Amministratore
    22 Kings Mews
    31 Poole Road Westbourne
    BH4 9DJ Bournemouth
    Dorset
    EnglandBritish36541950004
    BARNARD, Henry
    13 Knole Wood
    Devenish Road
    SL5 9QR Sunningdale
    Berkshire
    Amministratore
    13 Knole Wood
    Devenish Road
    SL5 9QR Sunningdale
    Berkshire
    EnglandBritish79398170001
    BECHMANN, Ulrich
    March 10c
    Ellmall
    6352
    Austria
    Amministratore
    March 10c
    Ellmall
    6352
    Austria
    German105977490001
    BECKMANN, Ulrich
    Sonnsieine 225
    Going
    6353
    Austria
    Amministratore
    Sonnsieine 225
    Going
    6353
    Austria
    Germann84762580001
    CARTER, Michael Thomas
    1 The Hollows
    Little Lonnen
    BH21 7BB Wimborne
    Dorset
    Amministratore
    1 The Hollows
    Little Lonnen
    BH21 7BB Wimborne
    Dorset
    British72648550002
    CLARK, Susanne Christine
    6 Nutley Close
    BH11 8LF Bournemouth
    Dorset
    Amministratore
    6 Nutley Close
    BH11 8LF Bournemouth
    Dorset
    British72648560001
    COMBEN, Roy Dennis
    Glencoe
    Blandfield Road
    BH20 7JH Bere Regis
    Dorset
    Amministratore
    Glencoe
    Blandfield Road
    BH20 7JH Bere Regis
    Dorset
    British24875800001
    DEPAUW, Yoeri
    The Greens
    Alsidrin,
    NA Dubai
    Flat 308
    United Arab Emirates
    Amministratore
    The Greens
    Alsidrin,
    NA Dubai
    Flat 308
    United Arab Emirates
    UaeBelgian119362440001
    DUDHIA, Saeed Ahmed Gulam, Mr.
    Christchurch Road
    BH24 1DH Ringwood
    77-79
    Hampshire
    United Kingdom
    Amministratore
    Christchurch Road
    BH24 1DH Ringwood
    77-79
    Hampshire
    United Kingdom
    EnglandBritish115082000001
    EIBEL, Karl
    Abstallerstrasse
    Graz
    45
    8052
    Austria
    Amministratore
    Abstallerstrasse
    Graz
    45
    8052
    Austria
    Austria138909980001
    EVANS, James Andrew
    NP26 5YR Portskewett
    Castlegate Business Park
    United Kingdom
    Amministratore
    NP26 5YR Portskewett
    Castlegate Business Park
    United Kingdom
    WalesBritish188610900001
    EVETTS, Peter
    18 Braeside Road
    BH22 OJS West Moors
    Dorset
    Amministratore
    18 Braeside Road
    BH22 OJS West Moors
    Dorset
    United KingdomBritish81346870001
    HOADLEY, Brian Peter
    Broomrigg Road
    GU51 4LS Fleet
    Crossways
    Hampshire
    United Kingdom
    Amministratore
    Broomrigg Road
    GU51 4LS Fleet
    Crossways
    Hampshire
    United Kingdom
    United KingdomBritish34054910002
    KATES, Brian Trevor
    15 Keswick Road
    Boscombe
    BH5 1LP Bournemouth
    Dorset
    Amministratore
    15 Keswick Road
    Boscombe
    BH5 1LP Bournemouth
    Dorset
    British24875810001
    LOMAX, Mark Robert
    20 Westfield Road
    Regents Park
    SO15 4HR Southampton
    Hampshire
    Amministratore
    20 Westfield Road
    Regents Park
    SO15 4HR Southampton
    Hampshire
    British97367020001
    LOMAX, Mark Robert
    20 Westfield Road
    Regents Park
    SO15 4HR Southampton
    Hampshire
    Amministratore
    20 Westfield Road
    Regents Park
    SO15 4HR Southampton
    Hampshire
    British97367020001
    MCCALLUM, Stephen Reid
    Christchurch Road
    BH24 1DH Ringwood
    77-79
    Hampshire
    United Kingdom
    Amministratore
    Christchurch Road
    BH24 1DH Ringwood
    77-79
    Hampshire
    United Kingdom
    EnglandBritish89885340001
    MCCALLUM, Stephen Reid
    6 Hookwater Road
    SO53 5PR Chandlers Ford
    Hampshire
    Amministratore
    6 Hookwater Road
    SO53 5PR Chandlers Ford
    Hampshire
    EnglandBritish89885340001
    NUNN, Anne Veronica
    2 The Vineries
    Colehill
    BH21 2PU Wimborne
    Dorset
    Amministratore
    2 The Vineries
    Colehill
    BH21 2PU Wimborne
    Dorset
    British24875820001
    PONTIN, Alan
    Peel Fold
    Mill Lane
    RG9 4HB Henley On Thames
    Oxfordshire
    Amministratore
    Peel Fold
    Mill Lane
    RG9 4HB Henley On Thames
    Oxfordshire
    United KingdomBritish17148750003
    PRENTICE, Peter
    127 Porchester Road
    Woolston
    SO19 2JA Southampton
    Hampshire
    Amministratore
    127 Porchester Road
    Woolston
    SO19 2JA Southampton
    Hampshire
    British114312120001
    SCHAER, Andreas
    Berghofstr 20
    Herdern
    Switzerland
    Amministratore
    Berghofstr 20
    Herdern
    Switzerland
    Swiss139865300001
    SCHAER, Andreas
    Spitzackerstrasse 5
    FOREIGN Zurich
    8057
    Switzerland
    Amministratore
    Spitzackerstrasse 5
    FOREIGN Zurich
    8057
    Switzerland
    Swiss115072390001
    SEARBY, Robert Anthony
    5 Spinfield Lane West
    SL7 2DB Marlow
    Buckinghamshire
    Amministratore
    5 Spinfield Lane West
    SL7 2DB Marlow
    Buckinghamshire
    EnglandBritish1737470007
    SKELLON, Simon
    Christchurch Road
    BH24 1DH Ringwood
    77-79
    Hampshire
    Amministratore
    Christchurch Road
    BH24 1DH Ringwood
    77-79
    Hampshire
    EnglandBritish206579120001

    Chi sono le persone con controllo significativo di MITEL HOSPITALITY COMMUNICATIONS 2 LIMITED?

    Persone con controllo significativo
    NomeNotificato ilIndirizzoCessato
    London Wall Place, 4th Floor
    EC2Y 5AU London
    2
    United Kingdom
    26 feb 2018
    London Wall Place, 4th Floor
    EC2Y 5AU London
    2
    United Kingdom
    No
    Forma giuridicaLimited By Shares
    Paese di registrazioneEngland And Wales
    Autorità legaleUnited Kingdom (England And Wales)
    Luogo di registrazioneCompanies House
    Numero di registrazione9106445
    Natura del controllo
    • La persona possiede, direttamente o indirettamente, più del 75% delle azioni della società.
    • La persona detiene, direttamente o indirettamente, più del 75% dei diritti di voto nella società.
    • La persona ha il diritto, direttamente o indirettamente, di nominare o rimuovere la maggioranza del consiglio di amministrazione della società.
    Mitel Europe Limited
    New Street Square
    EC4A 3TW London
    5
    England
    06 apr 2016
    New Street Square
    EC4A 3TW London
    5
    England
    Forma giuridicaCompany
    Paese di registrazioneEngland
    Autorità legaleEnglish
    Luogo di registrazioneEngland
    Numero di registrazione09059484
    Natura del controllo
    • La persona possiede, direttamente o indirettamente, più del 75% delle azioni della società.

    MITEL HOSPITALITY COMMUNICATIONS 2 LIMITED ha ipoteche?

    Ipoteche
    ClassificazioneDateStatoDettagli
    A registered charge
    Creato il 31 lug 2014
    Consegnato il 11 ago 2014
    Soddisfatta integralmente
    Breve descrizione
    1000 shares of stock issued by innovation technologies worldwide, inc.
    Contiene un'ipotesi negativa:
    Contiene un'ipoteca fissa:
    Persone aventi diritto
    • Santander UK PLC
    Transazioni
    • 11 ago 2014Registrazione di un'ipoteca (MR01)
    • 01 giu 2015Soddisfazione di un'ipoteca (MR04)
    A registered charge
    Creato il 31 lug 2014
    Consegnato il 04 ago 2014
    Soddisfatta integralmente
    L'ipoteca flottante copre tutto:
    Contiene un'ipotesi negativa:
    Contiene un'ipoteca flottante:
    Contiene un'ipoteca fissa:
    Persone aventi diritto
    • Santander UK PLC
    Transazioni
    • 04 ago 2014Registrazione di un'ipoteca (MR01)
    • 01 giu 2015Soddisfazione di un'ipoteca (MR04)
    Debenture
    Creato il 07 set 2010
    Consegnato il 08 set 2010
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery.
    Persone aventi diritto
    • Lloyds Tsb Bank PLC
    Transazioni
    • 08 set 2010Registrazione di un'ipoteca (MG01)
    • 04 feb 2015Soddisfazione di un'ipoteca (MR04)
    Deed of admission to an omnibus guarantee and set-off agreement
    Creato il 29 mar 2010
    Consegnato il 30 mar 2010
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company and/or all or any of the companies named therein to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Any sum or sums for the time being standing to the credit of any one or more of any present or future accounts of the companies or any of them with the bank (including any accounts held in the bank's name with any designation which includes the name(s) of the companies or any of them) whether such accounts be denominated in sterling or in a currency or currencies other than sterling.
    Persone aventi diritto
    • Lloyds Tsb Bank PLC
    Transazioni
    • 30 mar 2010Registrazione di un'ipoteca (MG01)
    • 04 feb 2015Soddisfazione di un'ipoteca (MR04)
    Debenture
    Creato il 14 giu 2005
    Consegnato il 24 giu 2005
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Persone aventi diritto
    • Barclays Bank PLC
    Transazioni
    • 24 giu 2005Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 08 set 2010Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (MG02)
    Debenture
    Creato il 05 feb 1988
    Consegnato il 12 feb 1988
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    (Including trade fixtures). Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Persone aventi diritto
    • Barclays Bank PLC
    Transazioni
    • 12 feb 1988Registrazione di un'ipoteca
    • 05 feb 2000Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)

    Fonte dati

    • Companies House del Regno Unito
      Il registro ufficiale delle imprese nel Regno Unito, che fornisce l'accesso pubblico alle informazioni sulle imprese, come nomi, indirizzi, amministratori e depositi finanziari.
    • Licenza: CC0