CRP LINED EQUIPMENT LIMITED

CRP LINED EQUIPMENT LIMITED

  • Panoramica
  • Riepilogo
  • Scopo
  • Indirizzo
  • Denominazioni precedenti
  • Bilanci
  • Bilancio annuale
  • Deposizioni
  • Amministratori
  • Ipoteche
  • Fonte dati
  • Panoramica

    Nome della societàCRP LINED EQUIPMENT LIMITED
    Stato della societàSciolta
    Forma giuridicaSocietà a responsabilità limitata
    Numero di società 01767023
    GiurisdizioneInghilterra/Galles
    Data di costituzione
    Data di cessazione

    Qual è lo scopo di CRP LINED EQUIPMENT LIMITED?

    • Altre industrie manifatturiere n.c.a. (32990) / Industrie manifatturiere

    Dove si trova CRP LINED EQUIPMENT LIMITED?

    Indirizzo della sede legale
    Todmorden Road
    Littleborough
    OL15 9EG Lancashire
    Indirizzo della sede legale non recapitabileNo

    Quali erano i nomi precedenti di CRP LINED EQUIPMENT LIMITED?

    Denominazioni sociali precedenti
    Nome della societàDaA
    CORROSION RESISTANT PRODUCTS LIMITED19 mag 200319 mag 2003
    CRP PRODUCTS & SERVICES LIMITED 15 nov 199915 nov 1999
    CORROSION RESISTANT PRODUCTS LIMITED27 feb 198527 feb 1985

    Quali sono gli ultimi bilanci di CRP LINED EQUIPMENT LIMITED?

    Ultimi bilanci
    Ultimi bilanci redatti al31 dic 2013

    Qual è lo stato dell'ultimo bilancio annuale per CRP LINED EQUIPMENT LIMITED?

    Bilancio annuale
    Ultimo bilancio annuale

    Quali sono le ultime deposizioni per CRP LINED EQUIPMENT LIMITED?

    Deposizioni
    DataDescrizioneDocumentoTipo

    Gazzetta Ufficiale finale sciolta per scioglimento volontario

    1 pagineGAZ2(A)

    Prima Gazzetta Ufficiale per lo scioglimento volontario

    1 pagineGAZ1(A)

    Richiesta di cancellazione della società dal registro

    4 pagineDS01

    legacy

    2 pagineSH20

    Stato del capitale al 14 ott 2014

    • Capitale: GBP 1
    4 pagineSH19

    legacy

    2 pagineCAP-SS

    Risoluzioni

    Resolutions
    1 pagineRESOLUTIONS
    Risoluzioni
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    capital

    Risoluzione di riduzione del capitale sociale emesso

    RES06

    Bilancio annuale redatto al 01 giu 2014 con elenco completo degli azionisti

    7 pagineAR01

    Nomina di Mr Jan Olof Peter Eriksson come amministratore in data 13 mag 2014

    2 pagineAP01

    Nomina di Mr Leif Johnny Alvarsson come amministratore in data 13 mag 2014

    2 pagineAP01

    Nomina di Mr Claes Harald Hjalmar Hjalmarson come amministratore in data 13 mag 2014

    2 pagineAP01

    Bilancio redatto al 31 dic 2013

    7 pagineAA

    Bilancio annuale redatto al 01 giu 2013 con elenco completo degli azionisti

    4 pagineAR01

    Bilancio redatto al 31 dic 2012

    3 pagineAA

    Nomina di Miss Rebecca Louise Barlow come segretario in data 14 ago 2012

    1 pagineAP03

    Cessazione della carica di Andrew John Sheard come segretario in data 14 ago 2012

    1 pagineTM02

    Bilancio annuale redatto al 01 giu 2012 con elenco completo degli azionisti

    3 pagineAR01

    Bilancio redatto al 31 dic 2011

    3 pagineAA

    Bilancio redatto al 31 dic 2010

    3 pagineAA

    Bilancio annuale redatto al 01 giu 2011 con elenco completo degli azionisti

    3 pagineAR01

    Cessazione della carica di John Quilter come amministratore

    2 pagineTM01

    Cessazione della carica di Paul Pateman come amministratore

    2 pagineTM01

    Cessazione della carica di Stephen Gregory come amministratore

    2 pagineTM01

    legacy

    8 pagineMG01

    Nomina di Mr Michael Bruemmer come amministratore

    2 pagineAP01

    Chi sono gli amministratori di CRP LINED EQUIPMENT LIMITED?

    Amministratori
    NomeNominato ilDimissioni ilRuoloIndirizzoIdentificazione della societàPaese di residenzaNazionalitàData di nascitaProfessioneNumero
    BARLOW, Rebecca Louise
    Todmorden Road
    Littleborough
    OL15 9EG Lancashire
    Segretario
    Todmorden Road
    Littleborough
    OL15 9EG Lancashire
    171368910001
    ALVARSSON, Leif Johnny
    Edelcrantzv 12
    129 28
    Hagersten
    12
    Sweden
    Amministratore
    Edelcrantzv 12
    129 28
    Hagersten
    12
    Sweden
    SwedenSwedishCeo162570860001
    BRUEMMER, Michael Werner
    Todmorden Road
    Littleborough
    OL15 9EG Lancashire
    Amministratore
    Todmorden Road
    Littleborough
    OL15 9EG Lancashire
    GermanyGermanCompany Director151981850001
    ERIKSSON, Jan Olof Peter
    Formskararegatan 4 B
    Gothenburg
    4 B
    Sweden
    Amministratore
    Formskararegatan 4 B
    Gothenburg
    4 B
    Sweden
    SwedenSwedishBusiness Manager189131610001
    HJALMARSON, Claes Harald Hjalmar
    Fogdevagen 14
    128 38 Skarpnack
    14
    Sweden
    Amministratore
    Fogdevagen 14
    128 38 Skarpnack
    14
    Sweden
    SwedenSwedishGroup Controller189034130001
    PRICE, Nigel William
    Todmorden Road
    Littleborough
    OL15 9EG Lancashire
    Amministratore
    Todmorden Road
    Littleborough
    OL15 9EG Lancashire
    EnglandBritishCompany Director59064950002
    EDWARDS, Jayne
    50 The Campions
    WD6 5QD Borehamwood
    Hertfordshire
    Segretario
    50 The Campions
    WD6 5QD Borehamwood
    Hertfordshire
    British52962710001
    GREGORY, Stephen Robert
    27 Broomwood Road
    SW11 6HU London
    Segretario
    27 Broomwood Road
    SW11 6HU London
    BritishChartered Accountant58535180002
    SHEARD, Andrew John
    Todmorden Road
    Littleborough
    OL15 9EG Lancashire
    Segretario
    Todmorden Road
    Littleborough
    OL15 9EG Lancashire
    British107484840001
    WEIR, James
    2 Smythe Close
    CM11 1SF Billericay
    Essex
    Segretario
    2 Smythe Close
    CM11 1SF Billericay
    Essex
    British35164560001
    CUNNINGHAM, Robert Diebel
    15 Shedding Dean Close
    RH15 8JQ Burgess Hill
    West Sussex
    Amministratore
    15 Shedding Dean Close
    RH15 8JQ Burgess Hill
    West Sussex
    BritishSales Manager28276370001
    DAILEY, Graham Charles
    15 Woodley Fold
    Penketh
    WA5 2JB Warrington
    Cheshire
    Amministratore
    15 Woodley Fold
    Penketh
    WA5 2JB Warrington
    Cheshire
    BritishOperations Director28276380001
    EDWARDS, Jayne
    50 The Campions
    WD6 5QD Borehamwood
    Hertfordshire
    Amministratore
    50 The Campions
    WD6 5QD Borehamwood
    Hertfordshire
    BritishAccountant52962710001
    FRASER, Angus Simon James
    Applecote
    Pilgrims Way Boughton Aluph
    TN25 4EX Ashford
    Kent
    Amministratore
    Applecote
    Pilgrims Way Boughton Aluph
    TN25 4EX Ashford
    Kent
    EnglandBritishChief Executive18685120002
    GARDINER-HILL, Richard Temple
    104 St Georges Square Mews
    SW1V 3RZ London
    Amministratore
    104 St Georges Square Mews
    SW1V 3RZ London
    BritishCompany Director36434330001
    GLADWYN, Max James
    1 Deepdale
    SW19 5EZ London
    Amministratore
    1 Deepdale
    SW19 5EZ London
    EnglandBritishDirector14033250001
    GREGORY, Stephen Robert
    Todmorden Road
    Littleborough
    OL15 9EG Lancashire
    Amministratore
    Todmorden Road
    Littleborough
    OL15 9EG Lancashire
    United KingdomBritishChartered Accountant58535180003
    GREGORY, Stephen Robert
    28 Morella Road
    SW12 8UH London
    Amministratore
    28 Morella Road
    SW12 8UH London
    BritishChartered Accountant58535180001
    KIMBER, Robert
    New Bois Windsor Lane
    Little Kingshill
    HP16 0DP Great Missenden
    Buckinghamshire
    Amministratore
    New Bois Windsor Lane
    Little Kingshill
    HP16 0DP Great Missenden
    Buckinghamshire
    BritishCompany Director13898490001
    PARKER, Peter, Sir
    20 Bassett Road
    W10 6JJ London
    Amministratore
    20 Bassett Road
    W10 6JJ London
    BritishDirector76398790001
    PATEMAN, Paul Robert
    Todmorden Road
    Littleborough
    OL15 9EG Lancashire
    Amministratore
    Todmorden Road
    Littleborough
    OL15 9EG Lancashire
    United KingdomBritishManaging Director2375290002
    QUILTER, John Arnold
    Todmorden Road
    Littleborough
    OL15 9EG Lancashire
    Amministratore
    Todmorden Road
    Littleborough
    OL15 9EG Lancashire
    EnglandBritishChartered Chemical Engineer24240380004
    WEIR, James
    2 Smythe Close
    CM11 1SF Billericay
    Essex
    Amministratore
    2 Smythe Close
    CM11 1SF Billericay
    Essex
    BritishFinancial Director35164560001
    WILMOT, Geoffrey Tristan Descarriers
    33 Elms Crescent
    SW4 8QE London
    Amministratore
    33 Elms Crescent
    SW4 8QE London
    BritishDirector46123680001

    CRP LINED EQUIPMENT LIMITED ha ipoteche?

    Ipoteche
    ClassificazioneDateStatoDettagli
    Debenture
    Creato il 03 mar 2011
    Consegnato il 05 mar 2011
    In corso
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery.
    Persone aventi diritto
    • Clydesdale Bank PLC
    Transazioni
    • 05 mar 2011Registrazione di un'ipoteca (MG01)
    Legal charge
    Creato il 21 mag 1998
    Consegnato il 02 giu 1998
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    The f/h land and buildings on the south east side of todmorden road littleborough t/n GM326893. Fixed charge all buildings and other structures fixed to the property fixed charge any goodwill relating to the property fixed charge all plant machinery and other items affixed to the property assignment of the rental sums together with the benefit of all rights and remedies fixed charge the proceeds of any claim made under insurance policy relating to the property floating charge all unattached plant machinery chattels and goods on or in or used in connection with the property or the business or undertaking at the property.
    Persone aventi diritto
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transazioni
    • 02 giu 1998Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 27 gen 2011Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (MG02)
    Debenture
    Creato il 21 mag 1998
    Consegnato il 27 mag 1998
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transazioni
    • 27 mag 1998Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 25 nov 2005Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Mortgage debenture
    Creato il 06 mag 1986
    Consegnato il 13 mag 1986
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    A specific equitable charge over all f/hold and l/hold property and/or the proceeds of sale thereof fixed and floating charges over undertaking and all property and assets present and future including bookdebts, goodwill and the benefits of any licences.
    Persone aventi diritto
    • Coutts & Company
    Transazioni
    • 13 mag 1986Registrazione di un'ipoteca
    • 16 mag 2002Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)

    Fonte dati

    • Companies House del Regno Unito
      Il registro ufficiale delle imprese nel Regno Unito, che fornisce l'accesso pubblico alle informazioni sulle imprese, come nomi, indirizzi, amministratori e depositi finanziari.
    • Licenza: CC0