CONTROL EQUIPMENT LIMITED
Panoramica
| Nome della società | CONTROL EQUIPMENT LIMITED |
|---|---|
| Stato della società | Sciolta |
| Forma giuridica | Società a responsabilità limitata |
| Numero di società | 01769524 |
| Giurisdizione | Inghilterra/Galles |
| Data di costituzione | |
| Data di cessazione |
Riepilogo
| Ha PSCs super sicuri | No |
|---|---|
| Ha ipoteche | Sì |
| Ha una storia di insolvenza | No |
| La sede legale è in contestazione | No |
Qual è lo scopo di CONTROL EQUIPMENT LIMITED?
- Altre industrie manifatturiere n.c.a. (32990) / Industrie manifatturiere
Dove si trova CONTROL EQUIPMENT LIMITED?
| Indirizzo della sede legale | Tyco Park Grimshaw Lane M40 2WL Newton Heath Manchester |
|---|---|
| Indirizzo della sede legale non recapitabile | No |
Quali erano i nomi precedenti di CONTROL EQUIPMENT LIMITED?
| Nome della società | Da | A |
|---|---|---|
| CONTROL EQUIPMENT SERVICES LIMITED | 31 gen 1984 | 31 gen 1984 |
| LOTUSROAD LIMITED | 14 nov 1983 | 14 nov 1983 |
Quali sono gli ultimi bilanci di CONTROL EQUIPMENT LIMITED?
| Ultimi bilanci | |
|---|---|
| Ultimi bilanci redatti al | 30 set 2018 |
Quali sono le ultime deposizioni per CONTROL EQUIPMENT LIMITED?
| Data | Descrizione | Documento | Tipo | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gazzetta Ufficiale finale sciolta per scioglimento volontario | 1 pagine | GAZ2(A) | ||||||||||
Prima Gazzetta Ufficiale per lo scioglimento volontario | 1 pagine | GAZ1(A) | ||||||||||
Richiesta di cancellazione della società dal registro | 3 pagine | DS01 | ||||||||||
legacy | 2 pagine | SH20 | ||||||||||
Stato del capitale al 05 feb 2020
| 3 pagine | SH19 | ||||||||||
legacy | 2 pagine | CAP-SS | ||||||||||
Risoluzioni Resolutions | 1 pagine | RESOLUTIONS | ||||||||||
| ||||||||||||
Esercizio contabile in corso prorogato dal 30 set 2019 al 31 mar 2020 | 1 pagine | AA01 | ||||||||||
Dichiarazione di conformità presentata il 02 ott 2019 senza aggiornamenti | 3 pagine | CS01 | ||||||||||
Conto per una società dormiente redatto al 30 set 2018 | 10 pagine | AA | ||||||||||
Dichiarazione di conformità presentata il 02 ott 2018 senza aggiornamenti | 3 pagine | CS01 | ||||||||||
Bilancio redatto al 30 set 2017 | 16 pagine | AA | ||||||||||
Dimissioni del revisore | 1 pagine | AUD | ||||||||||
Bilancio redatto al 30 set 2016 | 14 pagine | AA | ||||||||||
Dichiarazione di conformità presentata il 02 ott 2017 senza aggiornamenti | 3 pagine | CS01 | ||||||||||
Nomina di Mr Mark Ayre come amministratore in data 31 ago 2017 | 2 pagine | AP01 | ||||||||||
Cessazione della carica di Andrew Bowie come amministratore in data 31 ago 2017 | 1 pagine | TM01 | ||||||||||
Dettagli del direttore cambiati per Mr Andrew Bowie il 30 giu 2017 | 2 pagine | CH01 | ||||||||||
Dettagli del direttore cambiati per Peter Schieser il 30 giu 2017 | 2 pagine | CH01 | ||||||||||
Cessazione della carica di Anton Bernard Alphonsus come segretario in data 10 mar 2017 | 1 pagine | TM02 | ||||||||||
Dichiarazione di conformità presentata il 02 ott 2016 con aggiornamenti | 6 pagine | CS01 | ||||||||||
Bilancio redatto al 25 set 2015 | 17 pagine | AA | ||||||||||
Bilancio annuale redatto al 02 ott 2015 con elenco completo degli azionisti | 6 pagine | AR01 | ||||||||||
| ||||||||||||
Bilancio redatto al 26 set 2014 | 19 pagine | AA | ||||||||||
Bilancio annuale redatto al 02 ott 2014 con elenco completo degli azionisti | 6 pagine | AR01 | ||||||||||
| ||||||||||||
Chi sono gli amministratori di CONTROL EQUIPMENT LIMITED?
| Nome | Nominato il | Dimissioni il | Ruolo | Indirizzo | Identificazione della società | Paese di residenza | Nazionalità | Data di nascita | Professione | Numero |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AYRE, Mark | Amministratore | Tyco Park Grimshaw Lane M40 2WL Newton Heath Manchester | England | British | 129877500001 | |||||
| SCHIESER, Peter | Amministratore | Tyco Park Grimshaw Lane M40 2WL Newton Heath Manchester | Luxembourg | German | 179601330001 | |||||
| ALPHONSUS, Anton Bernard | Segretario | The Summit Hanworth Road TW16 5DB Sunbury-On-Thames Security House Middlesex | British | 158440940001 | ||||||
| BRADBURY, Trevor | Segretario | 16 Gingells Farm Road Charvil RG10 9DJ Reading Berkshire | British | 47884750002 | ||||||
| DEVEREUX, James William Robert | Segretario | 37 Broad Street CV37 6HN Stratford Upon Avon Warwickshire | British | 63979360001 | ||||||
| DIXON, Clive Sidney | Segretario | 159 Aston Cantlow Road Wilmcote CV37 9XW Stratford Upon Avon Warwickshire | British | 75060001 | ||||||
| HARRISON, Colin Lancaster | Segretario | Wormald Park Grimshaw Lane M40 2WL Newton Heath Manchester | British | 44394290002 | ||||||
| KEMMANN LANE, Peter James | Segretario | 62 Park Road SS0 7PQ Southend On Sea Essex | British | 105653330002 | ||||||
| NEALE, David | Segretario | Trafalgar Road Birkdale PR8 2EA Southport 9 United Kingdom | British | 121132860001 | ||||||
| OCHILTREE, Kim Lesley | Segretario | 25 Nesta Road IG8 9RG Woodford Green Essex | British | 80269530001 | ||||||
| BOGGESS, Jerry Reid | Amministratore | 671 South Ocean Boulevard Boca Raton Florida 33432 Usa | American | 68774400001 | ||||||
| BOWIE, Andrew | Amministratore | Tyco Park Grimshaw Lane M40 2WL Newton Heath Manchester | United Kingdom | British | 140054660001 | |||||
| BUCKLEY, John Clifford | Amministratore | 5 Severn Close SK10 3DD Macclesfield Cheshire | Australian | 1436420001 | ||||||
| DEVEREUX, James William Robert | Amministratore | 37 Broad Street CV37 6HN Stratford Upon Avon Warwickshire | British | 63979360001 | ||||||
| GATELEY, Christopher | Amministratore | 29 Badger Way Hazlemere HP15 7LJ High Wycombe Buckinghamshire | British | 60152530001 | ||||||
| JENNINGS, Norman Anthony | Amministratore | One B Newey Street DY1 2SB Dudley West Midlands | British | 54095120001 | ||||||
| JONES, James Brian | Amministratore | 3 Talbot Street WS15 2EQ Rugeley Staffordshire | British | 57880370001 | ||||||
| LANT, David | Amministratore | 39 Wyle Cop SY1 1XF Shrewsbury Salop | British | 19160690001 | ||||||
| LEONARD, Peter Charles | Amministratore | Tyco Park Grimshaw Lane, Newton Heath M40 2WL Manchester | British | 119805430001 | ||||||
| LUDLOW, Grahame George Robert | Amministratore | Compton House Oakfield Hawkhurst TN18 4JR Cranbrook Kent | British | 51059130001 | ||||||
| OLIVER, Raymond | Amministratore | 39 Garth Road TN13 1RU Sevenoaks Kent | British | 61367290001 | ||||||
| STEAD, Terence Keith Parsons | Amministratore | Derry Close 1 The Derry Ashton Keynes SN6 6PW Swindon | England | British | 62519500001 | |||||
| SUMMERFIELD, David | Amministratore | 18 Knowle Wood Road Dorridge B93 8JJ Solihull West Midlands | British | 16677830001 | ||||||
| WALTERS, Kenneth John | Amministratore | 69 Kiddemore Green Road Brewood ST19 9BQ Stafford Staffordshire | British | 19160680002 | ||||||
| WILLIAMS, John Stanley | Amministratore | Norton Green House Norton Green Lane Knowle B93 8PJ Solihull West Midlands | British | 12946360001 |
Chi sono le persone con controllo significativo di CONTROL EQUIPMENT LIMITED?
| Nome | Notificato il | Indirizzo | Cessato | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Thorn Security Limited | 06 apr 2016 | The Summit Hanworth Road TW16 5DB Sunbury On Thames Security House Middlesex United Kingdom | No | ||||||||||
| |||||||||||||
Natura del controllo
| |||||||||||||
CONTROL EQUIPMENT LIMITED ha ipoteche?
| Classificazione | Date | Stato | Dettagli | |
|---|---|---|---|---|
| Fixed and floating charge | Creato il 06 set 1995 Consegnato il 07 set 1995 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Brevi particolari Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including uncalled capital goodwill bookdebts and patents. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
| Charge over all book debts | Creato il 13 giu 1986 Consegnato il 20 giu 1986 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Brevi particolari All book debts & other debts now and from time to time hereafter due owing or incurred to the company. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
| Charge | Creato il 27 mar 1984 Consegnato il 02 apr 1984 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Brevi particolari Floating charge over. Undertaking and all property and assets present and future including uncalled capital. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
Fonte dati
- Companies House del Regno Unito
Il registro ufficiale delle imprese nel Regno Unito, che fornisce l'accesso pubblico alle informazioni sulle imprese, come nomi, indirizzi, amministratori e depositi finanziari. - Licenza: CC0