HOLMES ENGINEERING COMPANY (ROTHERHAM) LIMITED

HOLMES ENGINEERING COMPANY (ROTHERHAM) LIMITED

  • Panoramica
  • Riepilogo
  • Scopo
  • Indirizzo
  • Bilanci
  • Deposizioni
  • Amministratori
  • Persone con controllo significativo
  • Ipoteche
  • Fonte dati
  • Panoramica

    Nome della societàHOLMES ENGINEERING COMPANY (ROTHERHAM) LIMITED
    Stato della societàSciolta
    Forma giuridicaSocietà a responsabilità limitata
    Numero di società 01773561
    GiurisdizioneInghilterra/Galles
    Data di costituzione
    Data di cessazione

    Qual è lo scopo di HOLMES ENGINEERING COMPANY (ROTHERHAM) LIMITED?

    • Attività di consulenza gestionale diverse dalla gestione finanziaria (70229) / Attività professionali, scientifiche e tecniche

    Dove si trova HOLMES ENGINEERING COMPANY (ROTHERHAM) LIMITED?

    Indirizzo della sede legale
    91-97 Saltergate
    S40 1LA Chesterfield
    England
    Indirizzo della sede legale non recapitabileNo

    Quali sono gli ultimi bilanci di HOLMES ENGINEERING COMPANY (ROTHERHAM) LIMITED?

    Ultimi bilanci
    Ultimi bilanci redatti al30 giu 2020

    Quali sono le ultime deposizioni per HOLMES ENGINEERING COMPANY (ROTHERHAM) LIMITED?

    Deposizioni
    DataDescrizioneDocumentoTipo

    Gazzetta Ufficiale finale sciolta per scioglimento volontario

    1 pagineGAZ2(A)

    Prima Gazzetta Ufficiale per lo scioglimento volontario

    1 pagineGAZ1(A)

    Richiesta di cancellazione della società dal registro

    1 pagineDS01

    Soddisfazione dell'onere 017735610008 in pieno

    1 pagineMR04

    Bilancio abbreviato redatto al 30 giu 2020, non revisionato

    8 pagineAA

    Modifica dei dettagli di Clamark Engineering Limited come persona con controllo significativo il 13 lug 2021

    2 paginePSC05

    Dichiarazione di conformità presentata il 29 giu 2021 senza aggiornamenti

    3 pagineCS01

    Modifica dei dettagli di Clamark Engineering Limited come persona con controllo significativo il 13 lug 2021

    2 paginePSC05

    Indirizzo della sede legale modificato da 24-26 Mansfield Road Rotherham South Yorkshire S60 2DT England a 91-97 Saltergate Chesterfield S40 1LA in data 28 giu 2021

    1 pagineAD01

    Dichiarazione di conformità presentata il 29 giu 2020 con aggiornamenti

    4 pagineCS01

    Bilancio di esenzione totale redatto al 30 giu 2019

    10 pagineAA

    Dichiarazione di conformità presentata il 29 giu 2019 con aggiornamenti

    5 pagineCS01

    Cessazione della carica di Sharon Neal come segretario in data 21 giu 2019

    1 pagineTM02

    Bilancio di esenzione totale redatto al 30 giu 2018

    9 pagineAA

    Tutta la proprietà o attività è stata liberata dall'onere 017735610008

    1 pagineMR05

    Indirizzo della sede legale modificato da 18 Stalker Walk Sheffield S11 8NF England a 24-26 Mansfield Road Rotherham South Yorkshire S60 2DT in data 23 ago 2018

    1 pagineAD01

    Dichiarazione di conformità presentata il 29 giu 2018 con aggiornamenti

    5 pagineCS01

    Bilancio di esenzione totale redatto al 30 giu 2017

    11 pagineAA

    Cessazione della carica di Rupert John Jowitt come amministratore in data 10 ott 2017

    1 pagineTM01

    Cessazione della carica di Claire Jowitt come amministratore in data 10 ott 2017

    1 pagineTM01

    Soddisfazione dell'onere 1 in pieno

    2 pagineMR04

    Soddisfazione dell'onere 017735610006 in pieno

    1 pagineMR04

    Iscrizione dell'ipoteca 017735610008, creata il 02 ott 2017

    44 pagineMR01

    Dettagli del direttore cambiati per Miss Claire Miller il 20 set 2017

    2 pagineCH01

    Dichiarazione di conformità presentata il 29 giu 2017 con aggiornamenti

    5 pagineCS01

    Chi sono gli amministratori di HOLMES ENGINEERING COMPANY (ROTHERHAM) LIMITED?

    Amministratori
    NomeNominato ilDimissioni ilRuoloIndirizzoIdentificazione della societàPaese di residenzaNazionalitàData di nascitaProfessioneNumero
    MILLER, Mark Leslie
    Low Street
    Lastingham
    YO62 6TJ York
    Prospect House
    United Kingdom
    Amministratore
    Low Street
    Lastingham
    YO62 6TJ York
    Prospect House
    United Kingdom
    United KingdomBritishCompany Director56967150008
    MILLER, Eric Edward
    The Hall
    King Sterndale
    SK17 9SF Buxton
    Derbyshire
    Segretario
    The Hall
    King Sterndale
    SK17 9SF Buxton
    Derbyshire
    British4551870001
    NEAL, Sharon
    Fossdale Road
    S7 2DA Sheffield
    23
    South Yorkshire
    United Kingdom
    Segretario
    Fossdale Road
    S7 2DA Sheffield
    23
    South Yorkshire
    United Kingdom
    British74262400001
    RUMBLE, Peter
    21 St Thomass Close
    Warmsworth
    DN4 9LG Doncaster
    South Yorkshire
    Segretario
    21 St Thomass Close
    Warmsworth
    DN4 9LG Doncaster
    South Yorkshire
    British29517190001
    TAYLOR, Brian
    Leaberry Bessy Lane
    The Hills
    Bradwell
    Derbyshire
    Segretario
    Leaberry Bessy Lane
    The Hills
    Bradwell
    Derbyshire
    British13751160001
    JOWITT, Claire
    King Sterndale Hall Farm,King Sterndale
    SK17 9SF Buxton
    The Coach House
    Derbyshire
    United Kingdom
    Amministratore
    King Sterndale Hall Farm,King Sterndale
    SK17 9SF Buxton
    The Coach House
    Derbyshire
    United Kingdom
    United KingdomBritishCompany Director54026630004
    JOWITT, Rupert John
    S11 8NF Sheffield
    18 Stalker Walk
    England
    Amministratore
    S11 8NF Sheffield
    18 Stalker Walk
    England
    United KingdomBritishCompany Director198286400002
    MILLER, Eric Edward
    The Hall
    King Sterndale
    SK17 9SF Buxton
    Derbyshire
    Amministratore
    The Hall
    King Sterndale
    SK17 9SF Buxton
    Derbyshire
    United KingdomBritishCompany Director4551870001
    MILLER, Rita May
    The Hall
    King Sterndale
    SK17 9SF Buxton
    Derbyshire
    Amministratore
    The Hall
    King Sterndale
    SK17 9SF Buxton
    Derbyshire
    EnglandBritishCompany Director4551880001
    WINTER, Anthony Thomas
    East Ashling Grange Densworth Farm
    Funtington Road East Ashling
    PO18 9AP Chichester
    West Sussex
    Amministratore
    East Ashling Grange Densworth Farm
    Funtington Road East Ashling
    PO18 9AP Chichester
    West Sussex
    BritishCompany Director43197450001
    WINTER, Helen
    East Ashling Grange
    East Ashling
    PO18 9AP Chichester
    West Sussex
    Amministratore
    East Ashling Grange
    East Ashling
    PO18 9AP Chichester
    West Sussex
    BritishSecretary35560730002

    Chi sono le persone con controllo significativo di HOLMES ENGINEERING COMPANY (ROTHERHAM) LIMITED?

    Persone con controllo significativo
    NomeNotificato ilIndirizzoCessato
    Saltergate
    S40 1LA Chesterfield
    91-97
    England
    06 apr 2016
    Saltergate
    S40 1LA Chesterfield
    91-97
    England
    No
    Forma giuridicaLimited Company
    Paese di registrazioneEngland
    Autorità legaleEnglish
    Luogo di registrazioneCompanies House
    Numero di registrazione01319038
    Natura del controllo
    • La persona possiede, direttamente o indirettamente, più del 75% delle azioni della società.
    • La persona detiene, direttamente o indirettamente, più del 75% dei diritti di voto nella società.
    • La persona ha il diritto, direttamente o indirettamente, di nominare o rimuovere la maggioranza del consiglio di amministrazione della società.

    HOLMES ENGINEERING COMPANY (ROTHERHAM) LIMITED ha ipoteche?

    Ipoteche
    ClassificazioneDateStatoDettagli
    A registered charge
    Creato il 02 ott 2017
    Consegnato il 02 ott 2017
    Soddisfatta integralmente
    Breve descrizione
    All that property known as the land and buildings at harrison street, rotherham, S61 1EE.
    Contiene un'ipotesi negativa:
    Contiene un'ipoteca fissa:
    Persone aventi diritto
    • Julia Pauline Cobb
    • Simon John Maxwell Cobb
    Transazioni
    • 02 ott 2017Registrazione di un'ipoteca (MR01)
    • 03 gen 2019Tutta la proprietà o l'impresa è stata liberata dall'ipoteca (MR05)
    • 14 ott 2021Soddisfazione di un'ipoteca (MR04)
    A registered charge
    Creato il 12 feb 2014
    Consegnato il 05 mar 2014
    Soddisfatta integralmente
    Breve descrizione
    Land and buildings at harrison street, meadowbank, rotherham t/no SYK183055. Notification of addition to or amendment of charge.
    Contiene un'ipoteca fissa:
    Persone aventi diritto
    • National Westminster Bank PLC
    Transazioni
    • 05 mar 2014Registrazione di un'ipoteca (MR01)
    • 10 mag 2016Soddisfazione di un'ipoteca (MR04)
    A registered charge
    Creato il 12 feb 2014
    Consegnato il 13 feb 2014
    Soddisfatta integralmente
    Breve descrizione
    Notification of addition to or amendment of charge.
    L'ipoteca flottante copre tutto:
    Contiene un'ipoteca flottante:
    Contiene un'ipoteca fissa:
    Persone aventi diritto
    • National Westminster Bank PLC
    Transazioni
    • 13 feb 2014Registrazione di un'ipoteca (MR01)
    • 02 ott 2017Soddisfazione di un'ipoteca (MR04)
    Legal mortgage
    Creato il 27 feb 1998
    Consegnato il 28 feb 1998
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Property at f/h land and buildings lying to the south of harrison street holmes. With the benefit of all rights licences guarantees rent deposits contracts deeds undertakings and warranties relating. To the property any shares or membership rights in any management company for the property any goodwill of any business from time to time carried on at the property any rental and other money payable under any lease licence or other interest created in respect of the property and all other payments whatever in respect of the property.
    Persone aventi diritto
    • Midland Bank PLC
    Transazioni
    • 28 feb 1998Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 10 ott 2013Soddisfazione di un'ipoteca (MR04)
    Legal mortgage
    Creato il 09 feb 1998
    Consegnato il 10 feb 1998
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Property being land and buildings on the north side of southfield road north kelsey lincoln. With the benefit of all rights licences guarantees rent deposits contracts deeds undertakings and warranties relating. To the property any shares or membership rights in any management company for the property any goodwill of any business from time to time carried on at the property any rental and other money payable under any lease licence or other interest created in respect of the property and all other payments whatever in respect of the property.
    Persone aventi diritto
    • Midland Bank PLC
    Transazioni
    • 10 feb 1998Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 10 ott 2013Soddisfazione di un'ipoteca (MR04)
    Debenture
    Creato il 29 ago 1997
    Consegnato il 16 set 1997
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever including, without limitation the loan being £250,000
    Brevi particolari
    Harrison street meadowbank rotherham S61 1EG t/n SYK183055. Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Bce Business Funding Limited
    Transazioni
    • 16 set 1997Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 25 giu 1998Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Legal mortgage
    Creato il 07 giu 1996
    Consegnato il 13 giu 1996
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    F/H property k/a land and buildings to south of harrison street holmes rotherham south yorkshire t/n syk 183055 and the proceeds of sale thereof. Floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment and an assignment of the goodwill and connection of any business together with the full benefit of all licences.
    Persone aventi diritto
    • National Westminster Bank PLC
    Transazioni
    • 13 giu 1996Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 13 mar 2014Soddisfazione di un'ipoteca (MR04)
    Legal mortgage
    Creato il 14 lug 1995
    Consegnato il 31 lug 1995
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    F/H-inges farm north kelsey lincoln linconshire and/or the proceeds of sale thereof. Floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment and an assignment of the goodwill and connection of any business together with the full benefit of all licences.
    Persone aventi diritto
    • National Westminster Bank PLC
    Transazioni
    • 31 lug 1995Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 02 ott 2017Soddisfazione di un'ipoteca (MR04)

    Fonte dati

    • Companies House del Regno Unito
      Il registro ufficiale delle imprese nel Regno Unito, che fornisce l'accesso pubblico alle informazioni sulle imprese, come nomi, indirizzi, amministratori e depositi finanziari.
    • Licenza: CC0