EMBASSY INVESTMENTS LIMITED

EMBASSY INVESTMENTS LIMITED

  • Panoramica
  • Riepilogo
  • Scopo
  • Indirizzo
  • Denominazioni precedenti
  • Bilanci
  • Deposizioni
  • Amministratori
  • Persone con controllo significativo
  • Ipoteche
  • Fonte dati
  • Panoramica

    Nome della societàEMBASSY INVESTMENTS LIMITED
    Stato della societàSciolta
    Forma giuridicaSocietà a responsabilità limitata
    Numero di società 01779219
    GiurisdizioneInghilterra/Galles
    Data di costituzione
    Data di cessazione

    Qual è lo scopo di EMBASSY INVESTMENTS LIMITED?

    • Società inattiva (99999) / Attività di organizzazioni ed organismi extraterritoriali

    Dove si trova EMBASSY INVESTMENTS LIMITED?

    Indirizzo della sede legale
    The Handover Centre Appletree Trading Estate
    Chipping Warden
    OX17 1LL Banbury
    England
    Indirizzo della sede legale non recapitabileNo

    Quali erano i nomi precedenti di EMBASSY INVESTMENTS LIMITED?

    Denominazioni sociali precedenti
    Nome della societàDaA
    GRESWOLDE DEVELOPMENTS LIMITED19 dic 198319 dic 1983

    Quali sono gli ultimi bilanci di EMBASSY INVESTMENTS LIMITED?

    Ultimi bilanci
    Ultimi bilanci redatti al30 giu 2020

    Quali sono le ultime deposizioni per EMBASSY INVESTMENTS LIMITED?

    Deposizioni
    DataDescrizioneDocumentoTipo

    Gazzetta Ufficiale finale sciolta per scioglimento volontario

    1 pagineGAZ2(A)

    Prima Gazzetta Ufficiale per lo scioglimento volontario

    1 pagineGAZ1(A)

    Richiesta di cancellazione della società dal registro

    3 pagineDS01

    Memorandum e Statuto

    22 pagineMA

    Dichiarazione degli oggetti sociali

    2 pagineCC04

    Cessazione della carica di Paul Clement Scott come amministratore in data 07 giu 2021

    1 pagineTM01

    Cessazione della carica di Paul Clement Scott come segretario in data 07 giu 2021

    1 pagineTM02

    legacy

    1 pagineSH20

    Stato del capitale al 08 giu 2021

    • Capitale: GBP 1.00
    3 pagineSH19

    legacy

    1 pagineCAP-SS

    Risoluzioni

    Resolutions
    2 pagineRESOLUTIONS
    Risoluzioni
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    capital

    Risoluzioni

    Power to issue shares, conflicts of interest, reduction amount credited to distributable reserves 27/05/2021
    RES13
    capital

    Risoluzione di riduzione del capitale sociale emesso

    RES06
    incorporation

    Risoluzione di adozione degli Articoli di Associazione

    RES01

    Dichiarazione di conformità presentata il 15 nov 2020 senza aggiornamenti

    3 pagineCS01

    Conto per una società dormiente redatto al 30 giu 2020

    8 pagineAA

    Dettagli del segretario cambiati per Mr Paul Clement Scott il 15 nov 2019

    1 pagineCH03

    Dettagli del direttore cambiati per Mr Paul Clement Scott il 15 nov 2019

    2 pagineCH01

    Dichiarazione di conformità presentata il 15 nov 2019 senza aggiornamenti

    3 pagineCS01

    Indirizzo della sede legale modificato da Unit 2 Langley Park Waterside Drive Langley Slouth SL3 6AD a The Handover Centre Appletree Trading Estate Chipping Warden Banbury OX17 1LL in data 22 ott 2019

    1 pagineAD01

    Conto per una società dormiente redatto al 30 giu 2019

    8 pagineAA

    Dichiarazione di conformità presentata il 15 nov 2018 senza aggiornamenti

    3 pagineCS01

    Conto per una società dormiente redatto al 30 giu 2018

    8 pagineAA

    Dichiarazione di conformità presentata il 15 nov 2017 senza aggiornamenti

    3 pagineCS01

    Conto per una società dormiente redatto al 30 giu 2017

    8 pagineAA

    Dichiarazione di conformità presentata il 15 nov 2016 con aggiornamenti

    5 pagineCS01

    Conto per una società dormiente redatto al 30 giu 2016

    8 pagineAA

    Cessazione della carica di Stephen David Bender come amministratore in data 30 mag 2016

    1 pagineTM01

    Chi sono gli amministratori di EMBASSY INVESTMENTS LIMITED?

    Amministratori
    NomeNominato ilDimissioni ilRuoloIndirizzoIdentificazione della societàPaese di residenzaNazionalitàData di nascitaProfessioneNumero
    VARLEY, Alexandria
    Appletree Trading Estate
    Chipping Warden
    OX17 1LL Banbury
    The Handover Centre
    England
    Amministratore
    Appletree Trading Estate
    Chipping Warden
    OX17 1LL Banbury
    The Handover Centre
    England
    EnglandBritishAccountant114926980004
    PRIEST, Malcolm John
    197a Station Road
    Knowle
    B93 0PU Solihull
    West Midlands
    Segretario
    197a Station Road
    Knowle
    B93 0PU Solihull
    West Midlands
    British106610560001
    SCOTT, Paul Clement
    Appletree Trading Estate
    Chipping Warden
    OX17 1LL Banbury
    The Handover Centre
    England
    Segretario
    Appletree Trading Estate
    Chipping Warden
    OX17 1LL Banbury
    The Handover Centre
    England
    British22634560001
    WOODSIDE SECRETARIES LIMITED
    61 Woodside Road
    KT3 3AW New Malden
    Surrey
    Segretario
    61 Woodside Road
    KT3 3AW New Malden
    Surrey
    8879140001
    BENDER, Stephen David
    56 Casewick Lane
    Uffington
    PE9 4SX Stamford
    Lincolnshire
    Amministratore
    56 Casewick Lane
    Uffington
    PE9 4SX Stamford
    Lincolnshire
    United KingdomBritishAccountant80314720001
    BRIDGES, Stuart John
    Jasmine Cottage
    Nuptown
    RG42 6HS Warfield
    Berkshire
    Amministratore
    Jasmine Cottage
    Nuptown
    RG42 6HS Warfield
    Berkshire
    United KingdomBritishCorporate Financier42176090002
    CLEVELEY, Michael Richard
    75 Tiddington Road
    CV37 7AF Stratford Upon Avon
    Warwickshire
    Amministratore
    75 Tiddington Road
    CV37 7AF Stratford Upon Avon
    Warwickshire
    Great BritainBritishCompany Director116430680001
    HOLBECHE, Roger Malcolm
    Barnmoor House
    Kington Lane
    CV35 8PP Claverdon
    Warwickshire
    Amministratore
    Barnmoor House
    Kington Lane
    CV35 8PP Claverdon
    Warwickshire
    United KingdomBritishCompany Director16353130007
    KINGSHOTT, Michael James
    Church Farm House
    Brick Kiln Lane
    TN12 8EN Horsmonden
    Kent
    Amministratore
    Church Farm House
    Brick Kiln Lane
    TN12 8EN Horsmonden
    Kent
    United KingdomBritishDirector83713020001
    NUTTALL, Peter Donald
    41 Nags Head
    Avening
    GL8 8NZ Tetbury
    Gloucestershire
    Amministratore
    41 Nags Head
    Avening
    GL8 8NZ Tetbury
    Gloucestershire
    BritishChartered Accountant29476820001
    PASCAN, Paul Michael
    38 Hillcroft
    LU6 1TU Dunstable
    Bedfordshire
    Amministratore
    38 Hillcroft
    LU6 1TU Dunstable
    Bedfordshire
    BritishAccountant52572380001
    PRIEST, Malcolm John
    197a Station Road
    Knowle
    B93 0PU Solihull
    West Midlands
    Amministratore
    197a Station Road
    Knowle
    B93 0PU Solihull
    West Midlands
    United KingdomBritishChartered Accountant106610560001
    RUSSELL, Barry Charles
    21 The Albany
    67 Woodcote Road
    SM6 0PS Wallington
    Surrey
    Amministratore
    21 The Albany
    67 Woodcote Road
    SM6 0PS Wallington
    Surrey
    BritishProperty Manager38094780002
    SCOTT, Paul Clement
    Appletree Trading Estate
    Chipping Warden
    OX17 1LL Banbury
    The Handover Centre
    England
    Amministratore
    Appletree Trading Estate
    Chipping Warden
    OX17 1LL Banbury
    The Handover Centre
    England
    EnglandBritishCompany Secretary22634560001
    TICEHURST, Jonathon Mark
    The Old House
    64 High Street
    SN14 8LP Marshfield
    Wiltshire
    Amministratore
    The Old House
    64 High Street
    SN14 8LP Marshfield
    Wiltshire
    BritishProperty Manger87622850001
    TORLAGE, Kevin Edgar
    130 Westway
    Raynes Park
    SW20 9LS London
    Amministratore
    130 Westway
    Raynes Park
    SW20 9LS London
    United KingdomSouth AfricanAccountant88938440001
    WILLIAMS, Paul David
    26 Wightwick Hall Road
    Wightwick
    WV6 8BZ Wolverhampton
    West Midlands
    Amministratore
    26 Wightwick Hall Road
    Wightwick
    WV6 8BZ Wolverhampton
    West Midlands
    United KingdomBritishCompany Director21594450001
    WINDER, Simon Paul
    Flat 2 9 Westbury Road
    N12 7NY London
    Amministratore
    Flat 2 9 Westbury Road
    N12 7NY London
    BritishAccountant75937140001
    WINDUSS, David Alexander
    Glebe House
    Buckland Dinham
    BA11 2QW Frome
    Somerset
    Amministratore
    Glebe House
    Buckland Dinham
    BA11 2QW Frome
    Somerset
    EnglandBritishAccountant64556700001
    YERBURY, John William Richard
    10 Bannerdown Close
    Batheaston
    BA1 7NJ Bath
    Amministratore
    10 Bannerdown Close
    Batheaston
    BA1 7NJ Bath
    BritishDirector50339880001

    Chi sono le persone con controllo significativo di EMBASSY INVESTMENTS LIMITED?

    Persone con controllo significativo
    NomeNotificato ilIndirizzoCessato
    Jacobs Investments Limited
    Waterside Drive
    Langley
    SL3 6AD Slough
    Unit 2
    England
    01 lug 2016
    Waterside Drive
    Langley
    SL3 6AD Slough
    Unit 2
    England
    No
    Forma giuridicaCompany Limited By Shares
    Paese di registrazioneUnited Kingdom
    Autorità legaleUk Companies Act
    Luogo di registrazioneRegistrar Of Companies Cardiff
    Numero di registrazione03871047
    Natura del controllo
    • La persona possiede, direttamente o indirettamente, più del 75% delle azioni della società.

    EMBASSY INVESTMENTS LIMITED ha ipoteche?

    Ipoteche
    ClassificazioneDateStatoDettagli
    Fixed and floating charge
    Creato il 13 mar 1997
    Consegnato il 20 mar 1997
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including uncalled capital goodwill bookdebts and patents.
    Persone aventi diritto
    • Midland Bank PLC
    Transazioni
    • 20 mar 1997Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 19 set 2002Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Legal mortgage
    Creato il 20 dic 1996
    Consegnato il 24 dic 1996
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from jacobs holdings PLC to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Land and buildings on the north west and east sides of thorncliffe lane chapeltown south yorkshire (freehold) with the benefit of all rights licences guarantees rent deposits contracts deeds undertakings and warranties relating to the property; any shares or membership rights in any management company for the property; any goodwill of any business from time to time carried on at the property; any rental and other money payable under any lease licence or other interest created in respect of the property; and all other payments whatever in respect of the property.
    Persone aventi diritto
    • Midland Bank PLC
    Transazioni
    • 24 dic 1996Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 19 set 2002Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Deed of further charge
    Creato il 11 set 1992
    Consegnato il 16 set 1992
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company and /or all or any of the other companies named therein to the chargee supplemental to the principal deeds as defined
    Brevi particolari
    Freehold property known as 3 and 4 bridge street nuneaton warwickshire.
    Persone aventi diritto
    • Singer & Friedlander Limited
    Transazioni
    • 16 set 1992Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 19 set 2002Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Debenture
    Creato il 30 mar 1992
    Consegnato il 08 apr 1992
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Persone aventi diritto
    • Midland Bank PLC
    Transazioni
    • 08 apr 1992Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 19 set 2002Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Legal charge
    Creato il 02 dic 1991
    Consegnato il 03 dic 1991
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    £ 50,000
    Brevi particolari
    130/133 station rd. Knowle solihull westmidlands t/n wm 281885.
    Persone aventi diritto
    • Ideal Estates Limited
    Transazioni
    • 03 dic 1991Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 04 feb 1992Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Deed of further charge and variation
    Creato il 11 apr 1991
    Consegnato il 15 apr 1991
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company and/or all or any of the other companies named therein to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Freehold 3 and 4 bridge street, nuneaton warwickshire title no wk 269051 all profit rents of the property.
    Persone aventi diritto
    • Singer & Friedlander Limited
    Transazioni
    • 15 apr 1991Registrazione di un'ipoteca
    • 19 set 2002Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Mortgage
    Creato il 10 ago 1989
    Consegnato il 11 ago 1989
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    F/H 3/4 bridge street nuneaton warwickshire t/no. Wk 269051. together with all buildings and erections thereon and all fixtures whatsoever now or at any time hereafter affixed or attached to the property or any part thereof other than trade machinery as defined by section 5 of the bills of sale act 1878.
    Persone aventi diritto
    • Singer & Friedlander Limited
    Transazioni
    • 11 ago 1989Registrazione di un'ipoteca
    • 19 set 2002Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Deed of charge
    Creato il 15 giu 1989
    Consegnato il 16 giu 1989
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    £270,000
    Brevi particolari
    F/H property being shop units number 1 to 4 at market street kingswinford west midlands t/no wm 314371.
    Persone aventi diritto
    • Singer & Friedlander Limited
    Transazioni
    • 16 giu 1989Registrazione di un'ipoteca
    Legal charge
    Creato il 26 mag 1989
    Consegnato il 30 mag 1989
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Land and premises 130/132 station road knowle solihull west midlands with all buildings and fixtures by way of A. floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment.
    Persone aventi diritto
    • Lloyds Bank PLC
    Transazioni
    • 30 mag 1989Registrazione di un'ipoteca
    • 25 mag 1994Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Mortgage
    Creato il 05 mag 1989
    Consegnato il 20 mag 1989
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    F/H property k/a 61 & 62 high street dudley west midlands t/no wm 413927 & all fixtures fittings plant machinery apparatus goods & materials.
    Persone aventi diritto
    • Singer & Friedlander Limited
    Transazioni
    • 20 mag 1989Registrazione di un'ipoteca
    • 19 set 2002Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Mortgage
    Creato il 05 mag 1989
    Consegnato il 20 mag 1989
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    F/H property being land & buildings on the west side of spon lane west bromwich west midlands t/no wm 2188005 & all fixtures fittings plant machinery apparatus goods & materials.
    Persone aventi diritto
    • Singer & Friedlander Limited
    Transazioni
    • 20 mag 1989Registrazione di un'ipoteca
    Charge
    Creato il 26 ott 1987
    Consegnato il 29 ott 1987
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Fixed & floating charge over the undertaking and all property and assets present and future including bookdebts & uncalled capital.
    Persone aventi diritto
    • Midland Bank PLC
    Transazioni
    • 29 ott 1987Registrazione di un'ipoteca
    • 19 set 2002Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)

    Fonte dati

    • Companies House del Regno Unito
      Il registro ufficiale delle imprese nel Regno Unito, che fornisce l'accesso pubblico alle informazioni sulle imprese, come nomi, indirizzi, amministratori e depositi finanziari.
    • Licenza: CC0