EMBASSY INVESTMENTS LIMITED
Panoramica
Nome della società | EMBASSY INVESTMENTS LIMITED |
---|---|
Stato della società | Sciolta |
Forma giuridica | Società a responsabilità limitata |
Numero di società | 01779219 |
Giurisdizione | Inghilterra/Galles |
Data di costituzione | |
Data di cessazione |
Riepilogo
Ha PSCs super sicuri | No |
---|---|
Ha ipoteche | Sì |
Ha una storia di insolvenza | No |
La sede legale è in contestazione | No |
Qual è lo scopo di EMBASSY INVESTMENTS LIMITED?
- Società inattiva (99999) / Attività di organizzazioni ed organismi extraterritoriali
Dove si trova EMBASSY INVESTMENTS LIMITED?
Indirizzo della sede legale | The Handover Centre Appletree Trading Estate Chipping Warden OX17 1LL Banbury England |
---|---|
Indirizzo della sede legale non recapitabile | No |
Quali erano i nomi precedenti di EMBASSY INVESTMENTS LIMITED?
Nome della società | Da | A |
---|---|---|
GRESWOLDE DEVELOPMENTS LIMITED | 19 dic 1983 | 19 dic 1983 |
Quali sono gli ultimi bilanci di EMBASSY INVESTMENTS LIMITED?
Ultimi bilanci | |
---|---|
Ultimi bilanci redatti al | 30 giu 2020 |
Quali sono le ultime deposizioni per EMBASSY INVESTMENTS LIMITED?
Data | Descrizione | Documento | Tipo | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gazzetta Ufficiale finale sciolta per scioglimento volontario | 1 pagine | GAZ2(A) | ||||||||||||||||||
Prima Gazzetta Ufficiale per lo scioglimento volontario | 1 pagine | GAZ1(A) | ||||||||||||||||||
Richiesta di cancellazione della società dal registro | 3 pagine | DS01 | ||||||||||||||||||
Memorandum e Statuto | 22 pagine | MA | ||||||||||||||||||
Dichiarazione degli oggetti sociali | 2 pagine | CC04 | ||||||||||||||||||
Cessazione della carica di Paul Clement Scott come amministratore in data 07 giu 2021 | 1 pagine | TM01 | ||||||||||||||||||
Cessazione della carica di Paul Clement Scott come segretario in data 07 giu 2021 | 1 pagine | TM02 | ||||||||||||||||||
legacy | 1 pagine | SH20 | ||||||||||||||||||
Stato del capitale al 08 giu 2021
| 3 pagine | SH19 | ||||||||||||||||||
legacy | 1 pagine | CAP-SS | ||||||||||||||||||
Risoluzioni Resolutions | 2 pagine | RESOLUTIONS | ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
Dichiarazione di conformità presentata il 15 nov 2020 senza aggiornamenti | 3 pagine | CS01 | ||||||||||||||||||
Conto per una società dormiente redatto al 30 giu 2020 | 8 pagine | AA | ||||||||||||||||||
Dettagli del segretario cambiati per Mr Paul Clement Scott il 15 nov 2019 | 1 pagine | CH03 | ||||||||||||||||||
Dettagli del direttore cambiati per Mr Paul Clement Scott il 15 nov 2019 | 2 pagine | CH01 | ||||||||||||||||||
Dichiarazione di conformità presentata il 15 nov 2019 senza aggiornamenti | 3 pagine | CS01 | ||||||||||||||||||
Indirizzo della sede legale modificato da Unit 2 Langley Park Waterside Drive Langley Slouth SL3 6AD a The Handover Centre Appletree Trading Estate Chipping Warden Banbury OX17 1LL in data 22 ott 2019 | 1 pagine | AD01 | ||||||||||||||||||
Conto per una società dormiente redatto al 30 giu 2019 | 8 pagine | AA | ||||||||||||||||||
Dichiarazione di conformità presentata il 15 nov 2018 senza aggiornamenti | 3 pagine | CS01 | ||||||||||||||||||
Conto per una società dormiente redatto al 30 giu 2018 | 8 pagine | AA | ||||||||||||||||||
Dichiarazione di conformità presentata il 15 nov 2017 senza aggiornamenti | 3 pagine | CS01 | ||||||||||||||||||
Conto per una società dormiente redatto al 30 giu 2017 | 8 pagine | AA | ||||||||||||||||||
Dichiarazione di conformità presentata il 15 nov 2016 con aggiornamenti | 5 pagine | CS01 | ||||||||||||||||||
Conto per una società dormiente redatto al 30 giu 2016 | 8 pagine | AA | ||||||||||||||||||
Cessazione della carica di Stephen David Bender come amministratore in data 30 mag 2016 | 1 pagine | TM01 | ||||||||||||||||||
Chi sono gli amministratori di EMBASSY INVESTMENTS LIMITED?
Nome | Nominato il | Dimissioni il | Ruolo | Indirizzo | Identificazione della società | Paese di residenza | Nazionalità | Data di nascita | Professione | Numero |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VARLEY, Alexandria | Amministratore | Appletree Trading Estate Chipping Warden OX17 1LL Banbury The Handover Centre England | England | British | Accountant | 114926980004 | ||||
PRIEST, Malcolm John | Segretario | 197a Station Road Knowle B93 0PU Solihull West Midlands | British | 106610560001 | ||||||
SCOTT, Paul Clement | Segretario | Appletree Trading Estate Chipping Warden OX17 1LL Banbury The Handover Centre England | British | 22634560001 | ||||||
WOODSIDE SECRETARIES LIMITED | Segretario | 61 Woodside Road KT3 3AW New Malden Surrey | 8879140001 | |||||||
BENDER, Stephen David | Amministratore | 56 Casewick Lane Uffington PE9 4SX Stamford Lincolnshire | United Kingdom | British | Accountant | 80314720001 | ||||
BRIDGES, Stuart John | Amministratore | Jasmine Cottage Nuptown RG42 6HS Warfield Berkshire | United Kingdom | British | Corporate Financier | 42176090002 | ||||
CLEVELEY, Michael Richard | Amministratore | 75 Tiddington Road CV37 7AF Stratford Upon Avon Warwickshire | Great Britain | British | Company Director | 116430680001 | ||||
HOLBECHE, Roger Malcolm | Amministratore | Barnmoor House Kington Lane CV35 8PP Claverdon Warwickshire | United Kingdom | British | Company Director | 16353130007 | ||||
KINGSHOTT, Michael James | Amministratore | Church Farm House Brick Kiln Lane TN12 8EN Horsmonden Kent | United Kingdom | British | Director | 83713020001 | ||||
NUTTALL, Peter Donald | Amministratore | 41 Nags Head Avening GL8 8NZ Tetbury Gloucestershire | British | Chartered Accountant | 29476820001 | |||||
PASCAN, Paul Michael | Amministratore | 38 Hillcroft LU6 1TU Dunstable Bedfordshire | British | Accountant | 52572380001 | |||||
PRIEST, Malcolm John | Amministratore | 197a Station Road Knowle B93 0PU Solihull West Midlands | United Kingdom | British | Chartered Accountant | 106610560001 | ||||
RUSSELL, Barry Charles | Amministratore | 21 The Albany 67 Woodcote Road SM6 0PS Wallington Surrey | British | Property Manager | 38094780002 | |||||
SCOTT, Paul Clement | Amministratore | Appletree Trading Estate Chipping Warden OX17 1LL Banbury The Handover Centre England | England | British | Company Secretary | 22634560001 | ||||
TICEHURST, Jonathon Mark | Amministratore | The Old House 64 High Street SN14 8LP Marshfield Wiltshire | British | Property Manger | 87622850001 | |||||
TORLAGE, Kevin Edgar | Amministratore | 130 Westway Raynes Park SW20 9LS London | United Kingdom | South African | Accountant | 88938440001 | ||||
WILLIAMS, Paul David | Amministratore | 26 Wightwick Hall Road Wightwick WV6 8BZ Wolverhampton West Midlands | United Kingdom | British | Company Director | 21594450001 | ||||
WINDER, Simon Paul | Amministratore | Flat 2 9 Westbury Road N12 7NY London | British | Accountant | 75937140001 | |||||
WINDUSS, David Alexander | Amministratore | Glebe House Buckland Dinham BA11 2QW Frome Somerset | England | British | Accountant | 64556700001 | ||||
YERBURY, John William Richard | Amministratore | 10 Bannerdown Close Batheaston BA1 7NJ Bath | British | Director | 50339880001 |
Chi sono le persone con controllo significativo di EMBASSY INVESTMENTS LIMITED?
Nome | Notificato il | Indirizzo | Cessato | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jacobs Investments Limited | 01 lug 2016 | Waterside Drive Langley SL3 6AD Slough Unit 2 England | No | ||||||||||
| |||||||||||||
Natura del controllo
|
EMBASSY INVESTMENTS LIMITED ha ipoteche?
Classificazione | Date | Stato | Dettagli | |
---|---|---|---|---|
Fixed and floating charge | Creato il 13 mar 1997 Consegnato il 20 mar 1997 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Brevi particolari Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including uncalled capital goodwill bookdebts and patents. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
Legal mortgage | Creato il 20 dic 1996 Consegnato il 24 dic 1996 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due or to become due from jacobs holdings PLC to the chargee on any account whatsoever | |
Brevi particolari Land and buildings on the north west and east sides of thorncliffe lane chapeltown south yorkshire (freehold) with the benefit of all rights licences guarantees rent deposits contracts deeds undertakings and warranties relating to the property; any shares or membership rights in any management company for the property; any goodwill of any business from time to time carried on at the property; any rental and other money payable under any lease licence or other interest created in respect of the property; and all other payments whatever in respect of the property. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
Deed of further charge | Creato il 11 set 1992 Consegnato il 16 set 1992 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due or to become due from the company and /or all or any of the other companies named therein to the chargee supplemental to the principal deeds as defined | |
Brevi particolari Freehold property known as 3 and 4 bridge street nuneaton warwickshire. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
Debenture | Creato il 30 mar 1992 Consegnato il 08 apr 1992 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Brevi particolari Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
Legal charge | Creato il 02 dic 1991 Consegnato il 03 dic 1991 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito £ 50,000 | |
Brevi particolari 130/133 station rd. Knowle solihull westmidlands t/n wm 281885. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
Deed of further charge and variation | Creato il 11 apr 1991 Consegnato il 15 apr 1991 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due or to become due from the company and/or all or any of the other companies named therein to the chargee on any account whatsoever | |
Brevi particolari Freehold 3 and 4 bridge street, nuneaton warwickshire title no wk 269051 all profit rents of the property. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
Mortgage | Creato il 10 ago 1989 Consegnato il 11 ago 1989 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Brevi particolari F/H 3/4 bridge street nuneaton warwickshire t/no. Wk 269051. together with all buildings and erections thereon and all fixtures whatsoever now or at any time hereafter affixed or attached to the property or any part thereof other than trade machinery as defined by section 5 of the bills of sale act 1878. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
Deed of charge | Creato il 15 giu 1989 Consegnato il 16 giu 1989 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito £270,000 | |
Brevi particolari F/H property being shop units number 1 to 4 at market street kingswinford west midlands t/no wm 314371. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
Legal charge | Creato il 26 mag 1989 Consegnato il 30 mag 1989 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Brevi particolari Land and premises 130/132 station road knowle solihull west midlands with all buildings and fixtures by way of A. floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
Mortgage | Creato il 05 mag 1989 Consegnato il 20 mag 1989 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Brevi particolari F/H property k/a 61 & 62 high street dudley west midlands t/no wm 413927 & all fixtures fittings plant machinery apparatus goods & materials. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
Mortgage | Creato il 05 mag 1989 Consegnato il 20 mag 1989 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Brevi particolari F/H property being land & buildings on the west side of spon lane west bromwich west midlands t/no wm 2188005 & all fixtures fittings plant machinery apparatus goods & materials. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
Charge | Creato il 26 ott 1987 Consegnato il 29 ott 1987 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Brevi particolari Fixed & floating charge over the undertaking and all property and assets present and future including bookdebts & uncalled capital. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
|
Fonte dati
- Companies House del Regno Unito
Il registro ufficiale delle imprese nel Regno Unito, che fornisce l'accesso pubblico alle informazioni sulle imprese, come nomi, indirizzi, amministratori e depositi finanziari. - Licenza: CC0