KEMBREY GROUP LIMITED
Panoramica
Nome della società | KEMBREY GROUP LIMITED |
---|---|
Stato della società | Sciolta |
Forma giuridica | Società a responsabilità limitata |
Numero di società | 01779711 |
Giurisdizione | Inghilterra/Galles |
Data di costituzione | |
Data di cessazione |
Riepilogo
Ha PSCs super sicuri | No |
---|---|
Ha ipoteche | Sì |
Ha una storia di insolvenza | No |
La sede legale è in contestazione | No |
Qual è lo scopo di KEMBREY GROUP LIMITED?
- Società inattiva (99999) / Attività di organizzazioni ed organismi extraterritoriali
Dove si trova KEMBREY GROUP LIMITED?
Indirizzo della sede legale | Roke Manor Old Salisbury Lane SO51 0ZN Romsey Hampshire |
---|---|
Indirizzo della sede legale non recapitabile | No |
Quali erano i nomi precedenti di KEMBREY GROUP LIMITED?
Nome della società | Da | A |
---|---|---|
MAINLINE DEVELOPMENTS LIMITED | 20 dic 1983 | 20 dic 1983 |
Quali sono gli ultimi bilanci di KEMBREY GROUP LIMITED?
Ultimi bilanci | |
---|---|
Ultimi bilanci redatti al | 31 ott 2018 |
Quali sono le ultime deposizioni per KEMBREY GROUP LIMITED?
Data | Descrizione | Documento | Tipo | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gazzetta Ufficiale finale sciolta per scioglimento volontario | 1 pagine | GAZ2(A) | ||||||||||
Prima Gazzetta Ufficiale per lo scioglimento volontario | 1 pagine | GAZ1(A) | ||||||||||
Stato del capitale al 05 nov 2019
| 5 pagine | SH19 | ||||||||||
Richiesta di cancellazione della società dal registro | 3 pagine | DS01 | ||||||||||
legacy | 1 pagine | SH20 | ||||||||||
legacy | 1 pagine | CAP-SS | ||||||||||
Risoluzioni Resolutions | 1 pagine | RESOLUTIONS | ||||||||||
| ||||||||||||
Conto per una società dormiente redatto al 31 ott 2018 | 8 pagine | AA | ||||||||||
Dichiarazione di conformità presentata il 01 gen 2019 con aggiornamenti | 4 pagine | CS01 | ||||||||||
Conto per una società dormiente redatto al 31 ott 2017 | 8 pagine | AA | ||||||||||
Cessazione della carica di Michael James Flowers come amministratore in data 30 giu 2018 | 1 pagine | TM01 | ||||||||||
Dichiarazione di conformità presentata il 01 gen 2018 con aggiornamenti | 4 pagine | CS01 | ||||||||||
Conto per una società dormiente redatto al 31 ott 2016 | 9 pagine | AA | ||||||||||
Nomina di Mr Andrew Gregory Lewis come amministratore in data 19 gen 2017 | 2 pagine | AP01 | ||||||||||
Dichiarazione di conformità presentata il 01 gen 2017 con aggiornamenti | 5 pagine | CS01 | ||||||||||
Dettagli del direttore cambiati per Sarah Louise Ellard il 03 gen 2017 | 2 pagine | CH01 | ||||||||||
Cessazione della carica di Steven John Bowers come amministratore in data 30 set 2016 | 1 pagine | TM01 | ||||||||||
Conto per una società dormiente redatto al 31 ott 2015 | 8 pagine | AA | ||||||||||
Bilancio annuale redatto al 01 gen 2016 con elenco completo degli azionisti | 5 pagine | AR01 | ||||||||||
| ||||||||||||
Conto per una società dormiente redatto al 31 ott 2014 | 8 pagine | AA | ||||||||||
Dettagli del direttore cambiati per Mr Michael James Flowers il 13 mar 2015 | 2 pagine | CH01 | ||||||||||
Bilancio annuale redatto al 01 gen 2015 con elenco completo degli azionisti | 6 pagine | AR01 | ||||||||||
| ||||||||||||
Dettagli del direttore cambiati per Sarah Louise Ellard il 09 dic 2014 | 2 pagine | CH01 | ||||||||||
Dettagli del segretario cambiati per Sarah Louise Ellard il 09 dic 2014 | 1 pagine | CH03 | ||||||||||
Conto per una società dormiente redatto al 31 ott 2013 | 8 pagine | AA | ||||||||||
Chi sono gli amministratori di KEMBREY GROUP LIMITED?
Nome | Nominato il | Dimissioni il | Ruolo | Indirizzo | Identificazione della società | Paese di residenza | Nazionalità | Data di nascita | Professione | Numero |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ELLARD, Sarah Louise | Segretario | Old Salisbury Lane SO51 0ZN Romsey Roke Manor Hampshire United Kingdom | British | Company Secretary | 43855640011 | |||||
ELLARD, Sarah Louise | Amministratore | Old Salisbury Lane SO51 0ZN Romsey Roke Manor Hampshire United Kingdom | England | British | Group Legal Director | 43855640013 | ||||
LEWIS, Andrew Gregory | Amministratore | Old Salisbury Lane SO51 0ZN Romsey Roke Manor Hampshire | United Kingdom | British | Company Director | 222848510001 | ||||
EDGE, Geoffrey | Segretario | Spindlewood Dog Kennel Hill Kiveton Park Station S26 6NG Sheffield South Yorkshire | British | 2055530001 | ||||||
LEIGHTON, Iain Gordon Kerr | Segretario | 71 Rectory Grove Clapham Common SW4 0DS London | British | Company Secretary | 42841660001 | |||||
VINE, Sylvia Elizabeth Faith | Segretario | Struan 65 Bell Hill GU32 2EA Petersfield Hampshire | British | Co Sec | 3801050001 | |||||
BILLINGTON, Philip Gordon | Amministratore | 25 Carbis Close Port Solent Cosham PO6 4TW Portsmouth Hampshire | British | Chairman | 18247670001 | |||||
BOWERS, Steven John | Amministratore | Old Salisbury Lane SO51 0ZN Romsey Roke Manor Hampshire United Kingdom | United Kingdom | British | Group Finance Director | 176189250001 | ||||
CLEARY, Michael John | Amministratore | 22 Main Road Naphill HP14 4QB High Wycombe Buckinghamshire | British | Director | 1525670001 | |||||
EDGE, Geoffrey | Amministratore | Spindlewood Dog Kennel Hill Kiveton Park Station S26 6NG Sheffield South Yorkshire | British | Accountant | 2055530001 | |||||
FLOWERS, Michael James | Amministratore | Old Salisbury Lane SO51 0LZ Romsey Roke Manor Hampshire United Kingdom | United Kingdom | Australian | Company Director | 188873370002 | ||||
GIBBS, Raymond John | Amministratore | Bridge House 7 Uxbridge Close SO31 7LP Sarisbury Soton Hampshire | British | Finance Director & Company Sec | 85421380001 | |||||
LEIGHTON, Iain Gordon Kerr | Amministratore | 71 Rectory Grove Clapham Common SW4 0DS London | United Kingdom | British | Company Secretary | 42841660001 | ||||
MACDERMOTT, Philip | Amministratore | 179 Sternhold Avenue SW2 4PF London | British | Director | 25679470001 | |||||
PAPWORTH, Mark Harry | Amministratore | Old Salisbury Lane SO51 0ZN Romsey Roke Manor Hampshire United Kingdom | England | British | Chief Executive | 103085690002 | ||||
PRICE, David John | Amministratore | 1500 Parkway Whiteley PO15 7AF Fareham Chemring House Hampshire United Kingdom | United Kingdom | British | Chief Executive | 75259760004 | ||||
RAYNER, Paul Adrian | Amministratore | 1500 Parkway Whiteley PO15 7AF Fareham Chemring House Hampshire United Kingdom | United Kingdom | British | Finance Director | 45628680002 | ||||
VINE, Sylvia Elizabeth Faith | Amministratore | Struan 65 Bell Hill GU32 2EA Petersfield Hampshire | British | Co Sec | 3801050001 | |||||
WHITEHORN, Justin Michael | Amministratore | Lower Farm House Upper Milton Milton Under Wychwood OX7 6EX Chipping Norton Oxfordshire | England | British | Director | 42825970001 |
Chi sono le persone con controllo significativo di KEMBREY GROUP LIMITED?
Nome | Notificato il | Indirizzo | Cessato | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kembrey Limited | 30 giu 2016 | Old Salisbury Lane SO51 0ZN Romsey Roke Manor Hampshire United Kingdom | No | ||||||||||
| |||||||||||||
Natura del controllo
|
KEMBREY GROUP LIMITED ha ipoteche?
Classificazione | Date | Stato | Dettagli | |
---|---|---|---|---|
Charge | Creato il 11 ott 1993 Consegnato il 13 ott 1993 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever supplemental to a fixed and floating charge dated 18 december 1989 | |
Brevi particolari Fixed charge on all goodwill and uncalled capital for the time being of the company; and all patents patent applications inventions trade marks trade names etc. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
Debenture | Creato il 29 set 1990 Consegnato il 09 ott 1990 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Brevi particolari Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
Fixed and floating charge | Creato il 18 dic 1989 Consegnato il 02 gen 1990 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Brevi particolari Fixed & floating charge on undertaking and all property and assets present and future including book/other debts uncalled capital. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
Fixed and floating charge | Creato il 15 lug 1988 Consegnato il 21 lug 1988 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Brevi particolari Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future including uncalled capital. Book and other debts. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
Legal charge | Creato il 17 lug 1986 Consegnato il 07 ago 1986 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due or to become due from the company to the chargee under the ters of a facility letter of even date and this charge | |
Brevi particolari All the shares in J.P.T. engineering group limited all dividends accruing thereon. All shares and stocks (please see for for full details). | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
|
Fonte dati
- Companies House del Regno Unito
Il registro ufficiale delle imprese nel Regno Unito, che fornisce l'accesso pubblico alle informazioni sulle imprese, come nomi, indirizzi, amministratori e depositi finanziari. - Licenza: CC0