WOODWARD FOODSERVICE LIMITED

WOODWARD FOODSERVICE LIMITED

  • Panoramica
  • Riepilogo
  • Scopo
  • Indirizzo
  • Denominazioni precedenti
  • Bilanci
  • Deposizioni
  • Amministratori
  • Persone con controllo significativo
  • Ipoteche
  • Fonte dati
  • Panoramica

    Nome della societàWOODWARD FOODSERVICE LIMITED
    Stato della societàSciolta
    Forma giuridicaSocietà a responsabilità limitata
    Numero di società 01786682
    GiurisdizioneInghilterra/Galles
    Data di costituzione
    Data di cessazione

    Qual è lo scopo di WOODWARD FOODSERVICE LIMITED?

    • Commercio all'ingrosso non specializzato di prodotti alimentari, bevande e tabacchi (46390) / Commercio all'ingrosso e al dettaglio; riparazione di autoveicoli e motocicli

    Dove si trova WOODWARD FOODSERVICE LIMITED?

    Indirizzo della sede legale
    Enterprise House
    Eureka Business Park
    TN25 4AG Ashford
    Kent
    Indirizzo della sede legale non recapitabileNo

    Quali erano i nomi precedenti di WOODWARD FOODSERVICE LIMITED?

    Denominazioni sociali precedenti
    Nome della societàDaA
    WOODWARD FROZEN FOODS (RHYL) LIMITED21 lug 199721 lug 1997
    WOODWARD FROZEN FOODS (RHYL) LIMITED05 apr 198405 apr 1984
    WOODWARDS FROZEN FOODS (RHYL) LIMITED23 mar 198423 mar 1984
    QUESTWEAVE LIMITED27 gen 198427 gen 1984

    Quali sono gli ultimi bilanci di WOODWARD FOODSERVICE LIMITED?

    Ultimi bilanci
    Ultimi bilanci redatti al01 lug 2017

    Quali sono le ultime deposizioni per WOODWARD FOODSERVICE LIMITED?

    Deposizioni
    DataDescrizioneDocumentoTipo

    Gazzetta Ufficiale finale sciolta per scioglimento volontario

    1 pagineGAZ2(A)

    Prima Gazzetta Ufficiale per lo scioglimento volontario

    1 pagineGAZ1(A)

    Richiesta di cancellazione della società dal registro

    3 pagineDS01

    Dichiarazione di conformità presentata il 25 gen 2019 con aggiornamenti

    4 pagineCS01

    Conto per una società dormiente redatto al 01 lug 2017

    9 pagineAA

    Dichiarazione di conformità presentata il 25 gen 2018 con aggiornamenti

    5 pagineCS01

    Stato del capitale al 25 gen 2018

    • Capitale: GBP 1
    3 pagineSH19

    legacy

    1 pagineSH20

    legacy

    1 pagineCAP-SS

    Risoluzioni

    Resolutions
    3 pagineRESOLUTIONS
    Risoluzioni
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    capital

    Risoluzioni

    Cance capital reserve 18/12/2017
    RES13
    capital

    Risoluzione di riduzione del capitale sociale emesso

    RES06

    Dettagli del direttore cambiati per Mrs Sarah Leanne Whibley il 17 mar 2017

    2 pagineCH01

    Conto per una società dormiente redatto al 30 giu 2016

    8 pagineAA

    Dichiarazione di conformità presentata il 25 gen 2017 con aggiornamenti

    5 pagineCS01

    Cessazione della carica di Ian Robert Goldsmith come amministratore in data 29 set 2016

    1 pagineTM01

    Esercizio contabile precedente prorogato dal 31 dic 2015 al 30 giu 2016

    1 pagineAA01

    Bilancio annuale redatto al 25 gen 2016 con elenco completo degli azionisti

    4 pagineAR01
    Deposizioni associate
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    capital08 feb 2016

    Stato del capitale al 08 feb 2016

    • Capitale: GBP 48,008,000
    SH01

    Bilancio redatto al 31 dic 2014

    14 pagineAA

    Cessazione della carica di Adrian John Whitehead come amministratore in data 31 mar 2015

    1 pagineTM01

    Nomina di Mrs Sarah Leanne Whibley come amministratore in data 01 apr 2015

    2 pagineAP01

    Nomina di Mrs Sarah Leanne Whibley come segretario in data 01 apr 2015

    2 pagineAP03

    Cessazione della carica di Adrian Whitehead come segretario in data 31 mar 2015

    1 pagineTM02

    Bilancio annuale redatto al 25 gen 2015 con elenco completo degli azionisti

    5 pagineAR01
    Deposizioni associate
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    capital09 feb 2015

    Stato del capitale al 09 feb 2015

    • Capitale: GBP 48,008,000
    SH01

    Varie

    Section 519
    1 pagineMISC

    Varie

    Section 519
    2 pagineMISC

    Dimissioni del revisore

    2 pagineAUD

    Chi sono gli amministratori di WOODWARD FOODSERVICE LIMITED?

    Amministratori
    NomeNominato ilDimissioni ilRuoloIndirizzoIdentificazione della societàPaese di residenzaNazionalitàData di nascitaProfessioneNumero
    WHIBLEY, Sarah Leanne
    Eureka Business Park
    TN25 4AG Ashford
    Enterprise House
    Kent
    Segretario
    Eureka Business Park
    TN25 4AG Ashford
    Enterprise House
    Kent
    197291130001
    WHIBLEY, Sarah Leanne
    Eureka Business Park
    TN25 4AG Ashford
    Enterprise House
    Kent
    Amministratore
    Eureka Business Park
    TN25 4AG Ashford
    Enterprise House
    Kent
    EnglandBritish197579800001
    AGGARWAL, Amit
    27 St Mary's Mansions
    St Mary's Terrace
    W2 1SQ London
    Segretario
    27 St Mary's Mansions
    St Mary's Terrace
    W2 1SQ London
    British113667030001
    ATTWOOD, Paul Gerard
    12 Holborn Drive
    L39 3QL Ormskirk
    Lancashire
    Segretario
    12 Holborn Drive
    L39 3QL Ormskirk
    Lancashire
    British72538660001
    BURRELL, Jayne Katherine
    1 Moat Farm Court
    Pulford Lane Dodleston
    CH4 9NN Chester
    Cheshire
    Segretario
    1 Moat Farm Court
    Pulford Lane Dodleston
    CH4 9NN Chester
    Cheshire
    British99547650001
    CHASE, Suzanne Gabrielle
    68 Linden Gardens
    Chiswick
    W4 2EW London
    Segretario
    68 Linden Gardens
    Chiswick
    W4 2EW London
    British78255980001
    ELSBY SMITH, Andrew Edward
    House Road
    2 Bordeaux Walk Seabridge
    ST5 3TZ Newcastle Under Lyme
    Staffordshire
    Segretario
    House Road
    2 Bordeaux Walk Seabridge
    ST5 3TZ Newcastle Under Lyme
    Staffordshire
    British114320980001
    EVANS, Adrian Wynne
    1 Llys Alarch
    Maes Gwilym Dyserth Road
    LL18 4QG Rhyl
    Denbighshire
    Segretario
    1 Llys Alarch
    Maes Gwilym Dyserth Road
    LL18 4QG Rhyl
    Denbighshire
    British36023680003
    HOWARTH, David
    Cherry Bank
    Church Lane, Guilden Sutton
    CH3 7EW Chester
    Cheshire
    Segretario
    Cherry Bank
    Church Lane, Guilden Sutton
    CH3 7EW Chester
    Cheshire
    British107155000001
    MOOREHEAD, Simon Charles Wheeler
    28 Chapel Lane
    Hale Barns
    WA15 0HN Altrincham
    Cheshire
    Segretario
    28 Chapel Lane
    Hale Barns
    WA15 0HN Altrincham
    Cheshire
    British101873090001
    PRENTIS, Jonathan Paul
    11 Ollerbarrow Road
    Altrincham
    WA15 9PW Hale
    Cintra Lodge
    Cheshire
    Segretario
    11 Ollerbarrow Road
    Altrincham
    WA15 9PW Hale
    Cintra Lodge
    Cheshire
    British48949090001
    ROGERS, John Ingram
    Shambles 30 Bron Deg
    Dyserth
    LL18 6BG Rhyl
    Clwyd
    Segretario
    Shambles 30 Bron Deg
    Dyserth
    LL18 6BG Rhyl
    Clwyd
    British3954020002
    WHITEHEAD, Adrian
    Eureka Business Park
    TN25 4AG Ashford
    Enterprise House
    Kent
    England
    Segretario
    Eureka Business Park
    TN25 4AG Ashford
    Enterprise House
    Kent
    England
    British90271430004
    BERRY, John Graham
    The Poplars Darland Lane Lavister
    Rossett
    LL12 0BA Wrexham
    Amministratore
    The Poplars Darland Lane Lavister
    Rossett
    LL12 0BA Wrexham
    WalesBritish10711650001
    BIRCH, Andrew Richard
    Swn Y Dwr
    Wern Road Minera
    LL11 3DW Wrexham
    Amministratore
    Swn Y Dwr
    Wern Road Minera
    LL11 3DW Wrexham
    British110457030001
    CHASE, Suzanne Gabrielle
    Linden Gardens
    Chiswick
    W4 2EW London
    68
    United Kingdom
    Amministratore
    Linden Gardens
    Chiswick
    W4 2EW London
    68
    United Kingdom
    United KingdomBritish135246350001
    DHALIWAL, Tarsem Singh
    Ruthin Road
    CH7 4AF Gwernymynydd
    Ty Coch
    Flintshire
    Amministratore
    Ruthin Road
    CH7 4AF Gwernymynydd
    Ty Coch
    Flintshire
    United KingdomBritish151680990001
    ELSBY SMITH, Andrew Edward
    House Road
    2 Bordeaux Walk Seabridge
    ST5 3TZ Newcastle Under Lyme
    Staffordshire
    Amministratore
    House Road
    2 Bordeaux Walk Seabridge
    ST5 3TZ Newcastle Under Lyme
    Staffordshire
    EnglandBritish114320980001
    FEARN, Matthew Robin Cyprian
    Eureka Business Park
    TN25 4AG Ashford
    Enterprise House
    Kent
    England
    Amministratore
    Eureka Business Park
    TN25 4AG Ashford
    Enterprise House
    Kent
    England
    United KingdomBritish109155280002
    FLOWERS, Christopher Rolf
    South Barn
    Birchfield Farm Summerbridge
    HG3 4JS Harrogate
    North Yorkshire
    Amministratore
    South Barn
    Birchfield Farm Summerbridge
    HG3 4JS Harrogate
    North Yorkshire
    EnglandBritish154718610001
    GOLDSMITH, Ian Robert, Dr
    Eureka Business Park
    TN25 4AG Ashford
    Enterprise House
    Kent
    England
    Amministratore
    Eureka Business Park
    TN25 4AG Ashford
    Enterprise House
    Kent
    England
    United KingdomBritish135413790002
    HOSKINS, William John
    3 Homewood Road
    AL1 4BE St. Albans
    Hertfordshire
    Amministratore
    3 Homewood Road
    AL1 4BE St. Albans
    Hertfordshire
    British49295070002
    HOWARTH, David
    Cherry Bank
    Church Lane, Guilden Sutton
    CH3 7EW Chester
    Cheshire
    Amministratore
    Cherry Bank
    Church Lane, Guilden Sutton
    CH3 7EW Chester
    Cheshire
    British107155000001
    HUSTAD, Hans Kristian
    Nygaards Alle 5,
    FOREIGN Oslo
    0871
    Norway
    Amministratore
    Nygaards Alle 5,
    FOREIGN Oslo
    0871
    Norway
    Norwegian103594230001
    HYSLOP, Edward James
    Mayfield House
    Hall Lane, Haughton
    CW6 9RH Tarporley
    Cheshire
    Amministratore
    Mayfield House
    Hall Lane, Haughton
    CW6 9RH Tarporley
    Cheshire
    EnglandBritish127371260001
    HYSLOP, Edward James
    Mayfield House
    Hall Lane, Haughton
    CW6 9RH Tarporley
    Cheshire
    Amministratore
    Mayfield House
    Hall Lane, Haughton
    CW6 9RH Tarporley
    Cheshire
    EnglandBritish127371260001
    JOHANNESSON, Jon Asgeir
    Laufasvegur 69
    FOREIGN Reykjavik
    101
    Iceland
    Amministratore
    Laufasvegur 69
    FOREIGN Reykjavik
    101
    Iceland
    IcelandIcelandic78382920001
    LODGE, David Robert
    Eureka Science Park
    TN25 4AG Ashford
    Enterprise House
    Kent
    Amministratore
    Eureka Science Park
    TN25 4AG Ashford
    Enterprise House
    Kent
    United KingdomBritish164083200001
    MCKAY, Francis John
    Enterprise House
    Eureka Business Park
    TN25 4AG Ashford
    Kent
    Amministratore
    Enterprise House
    Eureka Business Park
    TN25 4AG Ashford
    Kent
    British110371430001
    MOOREHEAD, Simon Charles Wheeler
    28 Chapel Lane
    Hale Barns
    WA15 0HN Altrincham
    Cheshire
    Amministratore
    28 Chapel Lane
    Hale Barns
    WA15 0HN Altrincham
    Cheshire
    British101873090001
    PRENTIS, Jonathan Paul
    11 Ollerbarrow Road
    Altrincham
    WA15 9PW Hale
    Cintra Lodge
    Cheshire
    Amministratore
    11 Ollerbarrow Road
    Altrincham
    WA15 9PW Hale
    Cintra Lodge
    Cheshire
    United KingdomBritish48949090001
    PRITCHARD, Andrew Simon
    Kidnal Grange
    Kidnal
    SY14 7DJ Malpas
    Cheshire
    Amministratore
    Kidnal Grange
    Kidnal
    SY14 7DJ Malpas
    Cheshire
    United KingdomBritish42467790003
    RAMSDEN, Andrew Nicholas
    The Farmhouse
    Wood Lea Farm Shepley
    HD8 8ES Huddersfield
    Amministratore
    The Farmhouse
    Wood Lea Farm Shepley
    HD8 8ES Huddersfield
    EnglandBritish122765080001
    SIGURDSSON, Gunnar
    4 Greenlink Walk
    Kew Riverside
    TW9 4AF Richmond Upon Thames
    London
    Amministratore
    4 Greenlink Walk
    Kew Riverside
    TW9 4AF Richmond Upon Thames
    London
    EnglandIcelandic114179720001
    WHITEHEAD, Adrian John, Mr,
    Eureka Science Park
    TN25 4AG Ashford
    Enterprise House
    Kent
    Amministratore
    Eureka Science Park
    TN25 4AG Ashford
    Enterprise House
    Kent
    EnglandBritish83031020003

    Chi sono le persone con controllo significativo di WOODWARD FOODSERVICE LIMITED?

    Persone con controllo significativo
    NomeNotificato ilIndirizzoCessato
    Brake Bros Limited
    Nicholas Road
    Eureka Science Park
    TN25 4AG Ashford
    Enterprise House
    England
    06 apr 2016
    Nicholas Road
    Eureka Science Park
    TN25 4AG Ashford
    Enterprise House
    England
    No
    Forma giuridicaPrivate Company Limited By Shares
    Paese di registrazioneEngland & Wales
    Autorità legaleCompanies Acts
    Luogo di registrazioneRegister Of Companies
    Numero di registrazione02035315
    Natura del controllo
    • La persona possiede, direttamente o indirettamente, più del 75% delle azioni della società.
    • La persona detiene, direttamente o indirettamente, più del 75% dei diritti di voto nella società.
    • La persona ha il diritto, direttamente o indirettamente, di nominare o rimuovere la maggioranza del consiglio di amministrazione della società.

    WOODWARD FOODSERVICE LIMITED ha ipoteche?

    Ipoteche
    ClassificazioneDateStatoDettagli
    Assignment of an agreement by way of security
    Creato il 05 set 2006
    Consegnato il 23 set 2006
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    The benefit of the company's interests in the agreement including (without limitation) all powers of enforcement of the same and all rights, titles, benefits and interests of the company whatsoever present and future whether proprietary, contractual or otherwise arising out of or connected with or relating to the agreement. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Lloyds Tsb Commercial Finance Limited (The Security Holder)
    Transazioni
    • 23 set 2006Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 03 ott 2008Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    All assets debenture
    Creato il 05 set 2006
    Consegnato il 23 set 2006
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Lloyds Tsb Commercial Finance Limited (The Security Holder)
    Transazioni
    • 23 set 2006Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 03 ott 2008Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    All assets debenture
    Creato il 02 ago 2005
    Consegnato il 08 ago 2005
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Lloyds Tsb Commercial Finance Limited (The Security Holder)
    Transazioni
    • 08 ago 2005Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 03 ott 2008Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Deed of accession to a debenture
    Creato il 25 feb 2005
    Consegnato il 04 mar 2005
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the charging companies (or any of them) to the security trustee and/or the other security beneficiaries (or any of them) under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transazioni
    • 04 mar 2005Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 05 lug 2006Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Share pledge
    Creato il 25 feb 2005
    Consegnato il 03 mar 2005
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee and/or the other security beneficiaries (or any of them) under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    The existing shares and related rights including dividends,. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland (As Security Trustee for the Securitybeneficiaries)
    Transazioni
    • 03 mar 2005Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 05 lug 2006Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Debenture
    Creato il 24 feb 2005
    Consegnato il 04 mar 2005
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due of the charging companies (or any of them) to the security trustee and/or any security beneficiaries (or any of them) under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland (Security Trustee)
    Transazioni
    • 04 mar 2005Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 05 lug 2006Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Legal charge
    Creato il 17 mar 1992
    Consegnato il 19 mar 1992
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    L/H coldstore premises at bodelwyddan near rhyl clwyd.. Floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment.
    Persone aventi diritto
    • National Westminster Bank PLC
    Transazioni
    • 19 mar 1992Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 11 mar 2000Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Mortgage debenture
    Creato il 02 lug 1984
    Consegnato il 12 lug 1984
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    A specific & equitable charge over the companys estate or interest in all f/h or l/h properties and proceeds of sale thereof. Fixed & floating charge undertaking and all property and assets present and future including goodwill & bookdebts by way of a legal mortgage over f/h land & buildings at the rear of fforddlas road rhyl.
    Persone aventi diritto
    • National Westminster Bank PLC
    Transazioni
    • 12 lug 1984Registrazione di un'ipoteca
    • 11 mar 2000Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)

    Fonte dati

    • Companies House del Regno Unito
      Il registro ufficiale delle imprese nel Regno Unito, che fornisce l'accesso pubblico alle informazioni sulle imprese, come nomi, indirizzi, amministratori e depositi finanziari.
    • Licenza: CC0