E.D.S. INTERNATIONAL LIMITED

E.D.S. INTERNATIONAL LIMITED

  • Panoramica
  • Riepilogo
  • Scopo
  • Indirizzo
  • Denominazioni precedenti
  • Bilanci
  • Deposizioni
  • Amministratori
  • Persone con controllo significativo
  • Ipoteche
  • Insolvenza
  • Fonte dati
  • Panoramica

    Nome della societàE.D.S. INTERNATIONAL LIMITED
    Stato della societàSciolta
    Forma giuridicaSocietà a responsabilità limitata
    Numero di società 01791299
    GiurisdizioneInghilterra/Galles
    Data di costituzione
    Data di cessazione

    Qual è lo scopo di E.D.S. INTERNATIONAL LIMITED?

    • Attività delle sedi centrali (70100) / Attività professionali, scientifiche e tecniche

    Dove si trova E.D.S. INTERNATIONAL LIMITED?

    Indirizzo della sede legale
    Hill House
    1 Little New Street
    EC4A 3TR London
    Indirizzo della sede legale non recapitabileNo

    Quali erano i nomi precedenti di E.D.S. INTERNATIONAL LIMITED?

    Denominazioni sociali precedenti
    Nome della societàDaA
    ELECTRONIC DATA SYSTEMS LIMITED 13 feb 198413 feb 1984

    Quali sono gli ultimi bilanci di E.D.S. INTERNATIONAL LIMITED?

    Ultimi bilanci
    Ultimi bilanci redatti al31 mar 2018

    Quali sono le ultime deposizioni per E.D.S. INTERNATIONAL LIMITED?

    Deposizioni
    DataDescrizioneDocumentoTipo

    Gazzetta ufficiale finale sciolta a seguito di liquidazione

    1 pagineGAZ2

    Ritorno della riunione finale in una liquidazione volontaria dei membri

    10 pagineLIQ13

    Dichiarazione dei ricevimenti e dei pagamenti dei liquidatori fino a 14 feb 2021

    9 pagineLIQ03

    Dichiarazione dei ricevimenti e dei pagamenti dei liquidatori fino a 14 feb 2020

    8 pagineLIQ03

    Indirizzo della sede legale modificato da Royal Pavilion Wellesley Road Aldershot Hampshire GU11 1PZ United Kingdom a Hill House 1 Little New Street London EC4A 3TR in data 04 mar 2019

    2 pagineAD01

    Dichiarazione di solvibilità

    9 pagineLIQ01

    Nomina di un liquidatore volontario

    3 pagine600

    Risoluzioni

    Resolutions
    1 pagineRESOLUTIONS
    Risoluzioni
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    liquidation

    Risoluzione speciale per la liquidazione al 15 feb 2019

    LRESSP

    legacy

    3 pagineSH20

    Stato del capitale al 21 dic 2018

    • Capitale: GBP 1
    3 pagineSH19

    legacy

    3 pagineCAP-SS

    Risoluzioni

    Resolutions
    2 pagineRESOLUTIONS
    Risoluzioni
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    capital

    Risoluzioni

    Cancellation of share premium account 21/12/2018
    RES13
    capital

    Risoluzione di riduzione del capitale sociale emesso

    RES06

    Bilancio redatto al 31 mar 2018

    19 pagineAA

    Dettagli del direttore cambiati per Mr Michael Charles Woodfine il 05 giu 2018

    2 pagineCH01

    Dichiarazione di conformità presentata il 29 mag 2018 senza aggiornamenti

    3 pagineCS01

    Esercizio contabile in corso prorogato dal 31 ott 2017 al 31 mar 2018

    1 pagineAA01

    Notifica di Dxc Technology Company come persona con controllo significativo il 01 apr 2017

    2 paginePSC02

    Cessazione di Hewlett Packard Enterprise Company come persona con controllo significativo il 01 apr 2017

    1 paginePSC07

    Notifica di Hewlett Packard Enterprise Company come persona con controllo significativo il 06 apr 2016

    1 paginePSC02

    Dichiarazione di conformità presentata il 29 mag 2017 con aggiornamenti

    5 pagineCS01

    Indirizzo della sede legale modificato da Cain Road Amen Corner Bracknell Berkshire RG12 1HN a Royal Pavilion Wellesley Road Aldershot Hampshire GU11 1PZ in data 26 giu 2017

    1 pagineAD01

    Nomina di Michael Charles Woodfine come amministratore in data 26 giu 2017

    2 pagineAP01

    Bilancio redatto al 31 ott 2016

    17 pagineAA

    Cessazione della carica di Bas Van Der Goorbergh come amministratore in data 16 mar 2017

    1 pagineTM01

    Cessazione della carica di Miral Hamani come amministratore in data 16 mar 2017

    1 pagineTM01

    Chi sono gli amministratori di E.D.S. INTERNATIONAL LIMITED?

    Amministratori
    NomeNominato ilDimissioni ilRuoloIndirizzoIdentificazione della societàPaese di residenzaNazionalitàData di nascitaProfessioneNumero
    BIJNEN, Jeroen Mark Robert
    1 Little New Street
    EC4A 3TR London
    Hill House
    Amministratore
    1 Little New Street
    EC4A 3TR London
    Hill House
    NetherlandsDutch228117650001
    DOUAY, Francois-Xavier
    1 Little New Street
    EC4A 3TR London
    Hill House
    Amministratore
    1 Little New Street
    EC4A 3TR London
    Hill House
    FranceFrench228117400001
    WOODFINE, Michael Charles
    1 Little New Street
    EC4A 3TR London
    Hill House
    Amministratore
    1 Little New Street
    EC4A 3TR London
    Hill House
    EnglandBritish208597210001
    BATEMAN, John Alfred
    Chestnut Lodge 137 Upper Chobham Road
    GU15 1EE Camberley
    Surrey
    England
    Segretario
    Chestnut Lodge 137 Upper Chobham Road
    GU15 1EE Camberley
    Surrey
    England
    British143948160001
    CURTIS, Mark Jonathan
    11 Friesian Close
    Ancells Farm
    GU13 8PT Fleet
    Hampshire
    Segretario
    11 Friesian Close
    Ancells Farm
    GU13 8PT Fleet
    Hampshire
    British72758650001
    GRAF VON WESTERHOLT UND GEYSENBERG, Hartwig
    67 Rte De Saint Loup
    FOREIGN 1290 Versoix
    Switzerland
    Segretario
    67 Rte De Saint Loup
    FOREIGN 1290 Versoix
    Switzerland
    German16263680001
    ORMROD, James
    10 Midgham Green
    Midgham
    RG7 5TT Reading
    Webcroft
    Berks
    Segretario
    10 Midgham Green
    Midgham
    RG7 5TT Reading
    Webcroft
    Berks
    Other130250210001
    PERKINS, Thomas Clark
    Cain Road
    RG12 1HN Bracknell
    Amen Corner
    Berkshire
    Segretario
    Cain Road
    RG12 1HN Bracknell
    Amen Corner
    Berkshire
    147605420001
    PUTLAND, Roberto
    Cain Road
    RG12 1HN Bracknell
    Amen Corner
    Berkshire
    Segretario
    Cain Road
    RG12 1HN Bracknell
    Amen Corner
    Berkshire
    162785150001
    ROSS, Ruairidh Michael
    89 Laitwood Road
    SW12 9QH London
    Segretario
    89 Laitwood Road
    SW12 9QH London
    British41785380002
    ROY, David Maitland
    14 Lovell Road
    Oakley
    MK43 7RZ Bedford
    Segretario
    14 Lovell Road
    Oakley
    MK43 7RZ Bedford
    British46026850002
    TROWER, Tara Dawn
    Amen Corner
    RG12 1HN Bracknell
    Cain Road
    Berkshire
    England
    Segretario
    Amen Corner
    RG12 1HN Bracknell
    Cain Road
    Berkshire
    England
    187393650001
    WYBORN, Frederick John
    12 Hall Park
    HP4 2NU Berkhamsted
    Hertfordshire
    Segretario
    12 Hall Park
    HP4 2NU Berkhamsted
    Hertfordshire
    British18313020001
    EDS SECRETARIAL SERVICES LIMITED
    4 Roundwood Avenue
    Stockley Park
    UB11 1BQ Uxbridge
    Middlesex
    Segretario
    4 Roundwood Avenue
    Stockley Park
    UB11 1BQ Uxbridge
    Middlesex
    69779900001
    BATEMAN, John Alfred
    Moorlands Virginia Drive
    GU25 4RX Virginia Water
    Surrey
    Amministratore
    Moorlands Virginia Drive
    GU25 4RX Virginia Water
    Surrey
    British4950690003
    BEST, James Robert
    3 Jersey Place
    SL5 9NA Ascot
    Berkshire
    Amministratore
    3 Jersey Place
    SL5 9NA Ascot
    Berkshire
    American121593050001
    BUTLER, Thomas Michael
    13 West Heath Road
    Hampstead
    NW3 7UU London
    Amministratore
    13 West Heath Road
    Hampstead
    NW3 7UU London
    British24904420001
    COURTLEY, David John
    25 Mount Pleasant Villas
    Crouch End
    N4 4HH London
    Amministratore
    25 Mount Pleasant Villas
    Crouch End
    N4 4HH London
    EnglandBritish141213480001
    DAVID, Douglas William
    Flat 1, 21 Cadogan Gardens
    SW3 2RW London
    Amministratore
    Flat 1, 21 Cadogan Gardens
    SW3 2RW London
    American116628880001
    ERHARDT, Thomas Joseph
    Newlands House
    Ledborough Gate
    HP9 2DQ Beaconsfield
    Buckinghamshire
    Amministratore
    Newlands House
    Ledborough Gate
    HP9 2DQ Beaconsfield
    Buckinghamshire
    American116628710001
    FINNAN, Sean Francis
    44 Sherfield Avenue
    WD3 1NL Rickmansworth
    Hertfordshire
    Amministratore
    44 Sherfield Avenue
    WD3 1NL Rickmansworth
    Hertfordshire
    United KingdomBritish88216570001
    FRENZEL, John Michael
    Route Dhermance 40c
    1222 Vesenaz
    FOREIGN Geneva
    Switzerland
    Amministratore
    Route Dhermance 40c
    1222 Vesenaz
    FOREIGN Geneva
    Switzerland
    American16263670002
    GILL, Dara Singh
    1 Wellsprings
    Brightwell Cum Sotwell
    OX10 0RN Wallingford
    Oxfordshire
    Amministratore
    1 Wellsprings
    Brightwell Cum Sotwell
    OX10 0RN Wallingford
    Oxfordshire
    British89844650001
    GRAF VON WESTERHOLT UND GEYSENBERG, Hartwig
    67 Rte De Saint Loup
    FOREIGN 1290 Versoix
    Switzerland
    Amministratore
    67 Rte De Saint Loup
    FOREIGN 1290 Versoix
    Switzerland
    German16263680001
    HAMANI, Miral
    Amen Corner
    RG12 1HN Bracknell
    Cain Road
    Berkshire
    Amministratore
    Amen Corner
    RG12 1HN Bracknell
    Cain Road
    Berkshire
    SwitzerlandFrench197048610001
    HAUBENSTRICKER, Thomas Albert
    Westbourn
    Pinewood Road
    GU25 4PY Virginia Water
    Amministratore
    Westbourn
    Pinewood Road
    GU25 4PY Virginia Water
    American118732600001
    KOEHLER, Michael Ronald
    Beaufort Woods
    Woodhall Lane
    SL5 9QW Ascot
    Berkshire
    Amministratore
    Beaufort Woods
    Woodhall Lane
    SL5 9QW Ascot
    Berkshire
    American118440560001
    LETELIER, Sergio Erik
    Cain Road
    RG12 1HN Bracknell
    Amen Corner
    Berkshire
    Amministratore
    Cain Road
    RG12 1HN Bracknell
    Amen Corner
    Berkshire
    FranceFrench132467640015
    LEWTHWAITE, Mark
    Tokers Green Lane
    RG4 9AY Kidmore End
    Highfields
    South Oxfordshire
    Amministratore
    Tokers Green Lane
    RG4 9AY Kidmore End
    Highfields
    South Oxfordshire
    EnglandBritish134517020001
    ORMOND, James
    Midgham Green
    Midgham
    RG7 5TT Reading
    Webcroft
    Berkshire
    Amministratore
    Midgham Green
    Midgham
    RG7 5TT Reading
    Webcroft
    Berkshire
    British137893640001
    SHAIKHALI, Juzer
    Cain Road
    RG12 1HN Bracknell
    Amen Corner
    Berkshire
    Amministratore
    Cain Road
    RG12 1HN Bracknell
    Amen Corner
    Berkshire
    EnglandBritish123578150001
    SHELTON, Robin Turner
    Kings Willow Lower Green
    Towersey
    OX9 3QP Thame
    Oxfordshire
    Amministratore
    Kings Willow Lower Green
    Towersey
    OX9 3QP Thame
    Oxfordshire
    United KingdomBritish35150170001
    STEVENS, Alan Charles
    Lorne House Grimms Hill
    HP16 9BG Great Missenden
    Buckinghamshire
    Amministratore
    Lorne House Grimms Hill
    HP16 9BG Great Missenden
    Buckinghamshire
    United KingdomBritish32033570002
    THOMAS, William Gennydd
    97 Hazelwood Road
    DE56 4AA Duffield
    Derbyshire
    Amministratore
    97 Hazelwood Road
    DE56 4AA Duffield
    Derbyshire
    British141194410001
    THORPE, David Allan
    Bobble Barn Farmhouse
    GL54 2ND Little Rissington
    Gloucestershire
    Amministratore
    Bobble Barn Farmhouse
    GL54 2ND Little Rissington
    Gloucestershire
    United KingdomBritish77702540001

    Chi sono le persone con controllo significativo di E.D.S. INTERNATIONAL LIMITED?

    Persone con controllo significativo
    NomeNotificato ilIndirizzoCessato
    Dxc Technology Company
    Tysons
    22102 Tysons
    1775 Tysons Boulevard
    Virginia
    United States
    01 apr 2017
    Tysons
    22102 Tysons
    1775 Tysons Boulevard
    Virginia
    United States
    No
    Forma giuridicaCorporation
    Paese di registrazioneUsa (Other)
    Autorità legaleNevada
    Luogo di registrazioneNevada
    Numero di registrazioneE0155692017-0
    Natura del controllo
    • La persona possiede, direttamente o indirettamente, più del 75% delle azioni della società.
    • La persona detiene, direttamente o indirettamente, più del 75% dei diritti di voto nella società.
    Hewlett Packard Enterprise Company
    Palo Alto
    3000 Hanover Street
    California
    Usa
    06 apr 2016
    Palo Alto
    3000 Hanover Street
    California
    Usa
    Forma giuridicaCorporation
    Paese di registrazioneCalifornia
    Autorità legaleDelaware
    Luogo di registrazioneCalifornia
    Numero di registrazioneC3766360
    Natura del controllo
    • La persona possiede, direttamente o indirettamente, più del 75% delle azioni della società.
    • La persona detiene, direttamente o indirettamente, più del 75% dei diritti di voto nella società.

    E.D.S. INTERNATIONAL LIMITED ha ipoteche?

    Ipoteche
    ClassificazioneDateStatoDettagli
    Share charge (created by CUBIC (UK) limited, E.D.S. international limited, international computers limited and W.S. atkins consultants limited)
    Creato il 13 ago 1998
    Consegnato il 21 ago 1998
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from transaction systems limited (the "company") to the chargee in its capacity as security agent (under the terms of the security trust deed as therein defined)) under any bank finance document (as therein defined) or in connection with the facilities on any account whatsoever
    Brevi particolari
    First fixed charge all future shares and dividends meaning: all dividends payable and other distributions in relation to any of the shares being all of the shareholders' present and future interest in and to the ordinary shares in the company detailed in schedule 1 of the share charge and any other shares issued by the company. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Bank of America International Limited
    Transazioni
    • 21 ago 1998Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 17 mar 2010Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (MG02)

    E.D.S. INTERNATIONAL LIMITED ha procedimenti di insolvenza?

    Numero di praticaDateTipoProfessionistiAltro
    1
    DataTipo
    15 feb 2019Inizio della liquidazione
    17 ago 2021Data di scioglimento
    Liquidazione volontaria dei soci
    NomeRuoloIndirizzoNominato ilCessato il
    Stephen Roland Browne
    1 New Street Square
    EC4A 3HQ London
    Praticante
    1 New Street Square
    EC4A 3HQ London
    Ian Harvey Dean
    1 New Street Square
    EC4A 3HQ London
    Praticante
    1 New Street Square
    EC4A 3HQ London

    Fonte dati

    • Companies House del Regno Unito
      Il registro ufficiale delle imprese nel Regno Unito, che fornisce l'accesso pubblico alle informazioni sulle imprese, come nomi, indirizzi, amministratori e depositi finanziari.
    • Licenza: CC0