E.D.S. INTERNATIONAL LIMITED
Panoramica
| Nome della società | E.D.S. INTERNATIONAL LIMITED |
|---|---|
| Stato della società | Sciolta |
| Forma giuridica | Società a responsabilità limitata |
| Numero di società | 01791299 |
| Giurisdizione | Inghilterra/Galles |
| Data di costituzione | |
| Data di cessazione |
Riepilogo
| Ha PSCs super sicuri | No |
|---|---|
| Ha ipoteche | Sì |
| Ha una storia di insolvenza | Sì |
| La sede legale è in contestazione | No |
Qual è lo scopo di E.D.S. INTERNATIONAL LIMITED?
- Attività delle sedi centrali (70100) / Attività professionali, scientifiche e tecniche
Dove si trova E.D.S. INTERNATIONAL LIMITED?
| Indirizzo della sede legale | Hill House 1 Little New Street EC4A 3TR London |
|---|---|
| Indirizzo della sede legale non recapitabile | No |
Quali erano i nomi precedenti di E.D.S. INTERNATIONAL LIMITED?
| Nome della società | Da | A |
|---|---|---|
| ELECTRONIC DATA SYSTEMS LIMITED | 13 feb 1984 | 13 feb 1984 |
Quali sono gli ultimi bilanci di E.D.S. INTERNATIONAL LIMITED?
| Ultimi bilanci | |
|---|---|
| Ultimi bilanci redatti al | 31 mar 2018 |
Quali sono le ultime deposizioni per E.D.S. INTERNATIONAL LIMITED?
| Data | Descrizione | Documento | Tipo | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gazzetta ufficiale finale sciolta a seguito di liquidazione | 1 pagine | GAZ2 | ||||||||||||||
Ritorno della riunione finale in una liquidazione volontaria dei membri | 10 pagine | LIQ13 | ||||||||||||||
Dichiarazione dei ricevimenti e dei pagamenti dei liquidatori fino a 14 feb 2021 | 9 pagine | LIQ03 | ||||||||||||||
Dichiarazione dei ricevimenti e dei pagamenti dei liquidatori fino a 14 feb 2020 | 8 pagine | LIQ03 | ||||||||||||||
Indirizzo della sede legale modificato da Royal Pavilion Wellesley Road Aldershot Hampshire GU11 1PZ United Kingdom a Hill House 1 Little New Street London EC4A 3TR in data 04 mar 2019 | 2 pagine | AD01 | ||||||||||||||
Dichiarazione di solvibilità | 9 pagine | LIQ01 | ||||||||||||||
Nomina di un liquidatore volontario | 3 pagine | 600 | ||||||||||||||
Risoluzioni Resolutions | 1 pagine | RESOLUTIONS | ||||||||||||||
| ||||||||||||||||
legacy | 3 pagine | SH20 | ||||||||||||||
Stato del capitale al 21 dic 2018
| 3 pagine | SH19 | ||||||||||||||
legacy | 3 pagine | CAP-SS | ||||||||||||||
Risoluzioni Resolutions | 2 pagine | RESOLUTIONS | ||||||||||||||
| ||||||||||||||||
Bilancio redatto al 31 mar 2018 | 19 pagine | AA | ||||||||||||||
Dettagli del direttore cambiati per Mr Michael Charles Woodfine il 05 giu 2018 | 2 pagine | CH01 | ||||||||||||||
Dichiarazione di conformità presentata il 29 mag 2018 senza aggiornamenti | 3 pagine | CS01 | ||||||||||||||
Esercizio contabile in corso prorogato dal 31 ott 2017 al 31 mar 2018 | 1 pagine | AA01 | ||||||||||||||
Notifica di Dxc Technology Company come persona con controllo significativo il 01 apr 2017 | 2 pagine | PSC02 | ||||||||||||||
Cessazione di Hewlett Packard Enterprise Company come persona con controllo significativo il 01 apr 2017 | 1 pagine | PSC07 | ||||||||||||||
Notifica di Hewlett Packard Enterprise Company come persona con controllo significativo il 06 apr 2016 | 1 pagine | PSC02 | ||||||||||||||
Dichiarazione di conformità presentata il 29 mag 2017 con aggiornamenti | 5 pagine | CS01 | ||||||||||||||
Indirizzo della sede legale modificato da Cain Road Amen Corner Bracknell Berkshire RG12 1HN a Royal Pavilion Wellesley Road Aldershot Hampshire GU11 1PZ in data 26 giu 2017 | 1 pagine | AD01 | ||||||||||||||
Nomina di Michael Charles Woodfine come amministratore in data 26 giu 2017 | 2 pagine | AP01 | ||||||||||||||
Bilancio redatto al 31 ott 2016 | 17 pagine | AA | ||||||||||||||
Cessazione della carica di Bas Van Der Goorbergh come amministratore in data 16 mar 2017 | 1 pagine | TM01 | ||||||||||||||
Cessazione della carica di Miral Hamani come amministratore in data 16 mar 2017 | 1 pagine | TM01 | ||||||||||||||
Chi sono gli amministratori di E.D.S. INTERNATIONAL LIMITED?
| Nome | Nominato il | Dimissioni il | Ruolo | Indirizzo | Identificazione della società | Paese di residenza | Nazionalità | Data di nascita | Professione | Numero |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BIJNEN, Jeroen Mark Robert | Amministratore | 1 Little New Street EC4A 3TR London Hill House | Netherlands | Dutch | 228117650001 | |||||
| DOUAY, Francois-Xavier | Amministratore | 1 Little New Street EC4A 3TR London Hill House | France | French | 228117400001 | |||||
| WOODFINE, Michael Charles | Amministratore | 1 Little New Street EC4A 3TR London Hill House | England | British | 208597210001 | |||||
| BATEMAN, John Alfred | Segretario | Chestnut Lodge 137 Upper Chobham Road GU15 1EE Camberley Surrey England | British | 143948160001 | ||||||
| CURTIS, Mark Jonathan | Segretario | 11 Friesian Close Ancells Farm GU13 8PT Fleet Hampshire | British | 72758650001 | ||||||
| GRAF VON WESTERHOLT UND GEYSENBERG, Hartwig | Segretario | 67 Rte De Saint Loup FOREIGN 1290 Versoix Switzerland | German | 16263680001 | ||||||
| ORMROD, James | Segretario | 10 Midgham Green Midgham RG7 5TT Reading Webcroft Berks | Other | 130250210001 | ||||||
| PERKINS, Thomas Clark | Segretario | Cain Road RG12 1HN Bracknell Amen Corner Berkshire | 147605420001 | |||||||
| PUTLAND, Roberto | Segretario | Cain Road RG12 1HN Bracknell Amen Corner Berkshire | 162785150001 | |||||||
| ROSS, Ruairidh Michael | Segretario | 89 Laitwood Road SW12 9QH London | British | 41785380002 | ||||||
| ROY, David Maitland | Segretario | 14 Lovell Road Oakley MK43 7RZ Bedford | British | 46026850002 | ||||||
| TROWER, Tara Dawn | Segretario | Amen Corner RG12 1HN Bracknell Cain Road Berkshire England | 187393650001 | |||||||
| WYBORN, Frederick John | Segretario | 12 Hall Park HP4 2NU Berkhamsted Hertfordshire | British | 18313020001 | ||||||
| EDS SECRETARIAL SERVICES LIMITED | Segretario | 4 Roundwood Avenue Stockley Park UB11 1BQ Uxbridge Middlesex | 69779900001 | |||||||
| BATEMAN, John Alfred | Amministratore | Moorlands Virginia Drive GU25 4RX Virginia Water Surrey | British | 4950690003 | ||||||
| BEST, James Robert | Amministratore | 3 Jersey Place SL5 9NA Ascot Berkshire | American | 121593050001 | ||||||
| BUTLER, Thomas Michael | Amministratore | 13 West Heath Road Hampstead NW3 7UU London | British | 24904420001 | ||||||
| COURTLEY, David John | Amministratore | 25 Mount Pleasant Villas Crouch End N4 4HH London | England | British | 141213480001 | |||||
| DAVID, Douglas William | Amministratore | Flat 1, 21 Cadogan Gardens SW3 2RW London | American | 116628880001 | ||||||
| ERHARDT, Thomas Joseph | Amministratore | Newlands House Ledborough Gate HP9 2DQ Beaconsfield Buckinghamshire | American | 116628710001 | ||||||
| FINNAN, Sean Francis | Amministratore | 44 Sherfield Avenue WD3 1NL Rickmansworth Hertfordshire | United Kingdom | British | 88216570001 | |||||
| FRENZEL, John Michael | Amministratore | Route Dhermance 40c 1222 Vesenaz FOREIGN Geneva Switzerland | American | 16263670002 | ||||||
| GILL, Dara Singh | Amministratore | 1 Wellsprings Brightwell Cum Sotwell OX10 0RN Wallingford Oxfordshire | British | 89844650001 | ||||||
| GRAF VON WESTERHOLT UND GEYSENBERG, Hartwig | Amministratore | 67 Rte De Saint Loup FOREIGN 1290 Versoix Switzerland | German | 16263680001 | ||||||
| HAMANI, Miral | Amministratore | Amen Corner RG12 1HN Bracknell Cain Road Berkshire | Switzerland | French | 197048610001 | |||||
| HAUBENSTRICKER, Thomas Albert | Amministratore | Westbourn Pinewood Road GU25 4PY Virginia Water | American | 118732600001 | ||||||
| KOEHLER, Michael Ronald | Amministratore | Beaufort Woods Woodhall Lane SL5 9QW Ascot Berkshire | American | 118440560001 | ||||||
| LETELIER, Sergio Erik | Amministratore | Cain Road RG12 1HN Bracknell Amen Corner Berkshire | France | French | 132467640015 | |||||
| LEWTHWAITE, Mark | Amministratore | Tokers Green Lane RG4 9AY Kidmore End Highfields South Oxfordshire | England | British | 134517020001 | |||||
| ORMOND, James | Amministratore | Midgham Green Midgham RG7 5TT Reading Webcroft Berkshire | British | 137893640001 | ||||||
| SHAIKHALI, Juzer | Amministratore | Cain Road RG12 1HN Bracknell Amen Corner Berkshire | England | British | 123578150001 | |||||
| SHELTON, Robin Turner | Amministratore | Kings Willow Lower Green Towersey OX9 3QP Thame Oxfordshire | United Kingdom | British | 35150170001 | |||||
| STEVENS, Alan Charles | Amministratore | Lorne House Grimms Hill HP16 9BG Great Missenden Buckinghamshire | United Kingdom | British | 32033570002 | |||||
| THOMAS, William Gennydd | Amministratore | 97 Hazelwood Road DE56 4AA Duffield Derbyshire | British | 141194410001 | ||||||
| THORPE, David Allan | Amministratore | Bobble Barn Farmhouse GL54 2ND Little Rissington Gloucestershire | United Kingdom | British | 77702540001 |
Chi sono le persone con controllo significativo di E.D.S. INTERNATIONAL LIMITED?
| Nome | Notificato il | Indirizzo | Cessato | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dxc Technology Company | 01 apr 2017 | Tysons 22102 Tysons 1775 Tysons Boulevard Virginia United States | No | ||||||||||
| |||||||||||||
Natura del controllo
| |||||||||||||
| Hewlett Packard Enterprise Company | 06 apr 2016 | Palo Alto 3000 Hanover Street California Usa | Sì | ||||||||||
| |||||||||||||
Natura del controllo
| |||||||||||||
E.D.S. INTERNATIONAL LIMITED ha ipoteche?
| Classificazione | Date | Stato | Dettagli | |
|---|---|---|---|---|
| Share charge (created by CUBIC (UK) limited, E.D.S. international limited, international computers limited and W.S. atkins consultants limited) | Creato il 13 ago 1998 Consegnato il 21 ago 1998 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due or to become due from transaction systems limited (the "company") to the chargee in its capacity as security agent (under the terms of the security trust deed as therein defined)) under any bank finance document (as therein defined) or in connection with the facilities on any account whatsoever | |
Brevi particolari First fixed charge all future shares and dividends meaning: all dividends payable and other distributions in relation to any of the shares being all of the shareholders' present and future interest in and to the ordinary shares in the company detailed in schedule 1 of the share charge and any other shares issued by the company. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
E.D.S. INTERNATIONAL LIMITED ha procedimenti di insolvenza?
| Numero di pratica | Date | Tipo | Professionisti | Altro | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
| Liquidazione volontaria dei soci |
|
Fonte dati
- Companies House del Regno Unito
Il registro ufficiale delle imprese nel Regno Unito, che fornisce l'accesso pubblico alle informazioni sulle imprese, come nomi, indirizzi, amministratori e depositi finanziari. - Licenza: CC0