TWR REALISATIONS LIMITED

TWR REALISATIONS LIMITED

  • Panoramica
  • Riepilogo
  • Scopo
  • Indirizzo
  • Denominazioni precedenti
  • Bilanci
  • Deposizioni
  • Amministratori
  • Ipoteche
  • Insolvenza
  • Fonte dati
  • Panoramica

    Nome della societàTWR REALISATIONS LIMITED
    Stato della societàSciolta
    Forma giuridicaSocietà a responsabilità limitata
    Numero di società 01791325
    GiurisdizioneInghilterra/Galles
    Data di costituzione
    Data di cessazione

    Qual è lo scopo di TWR REALISATIONS LIMITED?

    • (5247) /

    Dove si trova TWR REALISATIONS LIMITED?

    Indirizzo della sede legale
    ZOLFO COOPER
    Toronto Square Toronto Street
    LS1 2HJ Leeds
    West Yorkshire
    Indirizzo della sede legale non recapitabileNo

    Quali erano i nomi precedenti di TWR REALISATIONS LIMITED?

    Denominazioni sociali precedenti
    Nome della societàDaA
    THE WORKS RETAIL LIMITED05 mag 200405 mag 2004
    REMAINDERS LIMITED13 feb 198413 feb 1984

    Quali sono gli ultimi bilanci di TWR REALISATIONS LIMITED?

    Ultimi bilanci
    Ultimi bilanci redatti al29 apr 2006

    Quali sono le ultime deposizioni per TWR REALISATIONS LIMITED?

    Deposizioni
    DataDescrizioneDocumentoTipo

    Gazzetta ufficiale finale sciolta a seguito di liquidazione

    1 pagineGAZ2

    Ritorno della riunione finale in una liquidazione volontaria dei creditori

    16 pagine4.72

    Dichiarazione dei ricevimenti e dei pagamenti dei liquidatori fino a 19 lug 2012

    8 pagine4.68

    Dichiarazione dei ricevimenti e dei pagamenti dei liquidatori fino a 19 gen 2012

    10 pagine4.68

    Dichiarazione dei ricevimenti e dei pagamenti dei liquidatori fino a 19 lug 2011

    5 pagine4.68

    Dichiarazione dei ricevimenti e dei pagamenti dei liquidatori fino a 19 gen 2011

    6 pagine4.68

    Notifica al Registro delle imprese della dichiarazione di disdetta

    3 pagineF10.2

    Notifica al Registro delle imprese della dichiarazione di disdetta

    3 pagineF10.2

    Notifica al Registro delle imprese della dichiarazione di disdetta

    3 pagineF10.2

    Notifica al Registro delle imprese della dichiarazione di disdetta

    3 pagineF10.2

    Notifica al Registro delle imprese della dichiarazione di disdetta

    3 pagineF10.2

    Notifica al Registro delle imprese della dichiarazione di disdetta

    3 pagineF10.2

    Notifica al Registro delle imprese della dichiarazione di disdetta

    3 pagineF10.2

    Notifica al Registro delle imprese della dichiarazione di disdetta

    3 pagineF10.2

    Notifica al Registro delle imprese della dichiarazione di disdetta

    3 pagineF10.2

    Notifica al Registro delle imprese della dichiarazione di disdetta

    3 pagineF10.2

    Notifica al Registro delle imprese della dichiarazione di disdetta

    3 pagineF10.2

    Notifica al Registro delle imprese della dichiarazione di disdetta

    3 pagineF10.2

    Notifica al Registro delle imprese della dichiarazione di disdetta

    3 pagineF10.2

    Notifica al Registro delle imprese della dichiarazione di disdetta

    3 pagineF10.2

    Notifica al Registro delle imprese della dichiarazione di disdetta

    3 pagineF10.2

    Notifica al Registro delle imprese della dichiarazione di disdetta

    3 pagineF10.2

    Notifica al Registro delle imprese della dichiarazione di disdetta

    3 pagineF10.2

    Notifica al Registro delle imprese della dichiarazione di disdetta

    3 pagineF10.2

    Dichiarazione dei ricevimenti e dei pagamenti dei liquidatori fino a 19 lug 2010

    10 pagine4.68

    Chi sono gli amministratori di TWR REALISATIONS LIMITED?

    Amministratori
    NomeNominato ilDimissioni ilRuoloIndirizzoIdentificazione della societàPaese di residenzaNazionalitàData di nascitaProfessioneNumero
    KNIGHTON, Paul
    Broadoak
    108 Rouncil Lane
    CV8 1FQ Kenilworth
    Warwickshire
    Segretario
    Broadoak
    108 Rouncil Lane
    CV8 1FQ Kenilworth
    Warwickshire
    BritishDirector93446780002
    BOARDMAN, Christopher David
    Oakleigh
    Mattersey Road Ranskill
    DN22 8ND Retford
    Nottinghamshire
    Amministratore
    Oakleigh
    Mattersey Road Ranskill
    DN22 8ND Retford
    Nottinghamshire
    BritishDirector112343200001
    HUGHES, Paul Kerry
    Wendover
    257 Warwick Road
    CV8 1FB Kenilworth
    Warwickshire
    Amministratore
    Wendover
    257 Warwick Road
    CV8 1FB Kenilworth
    Warwickshire
    United KingdomBritishCompany Director91149130002
    KNIGHTON, Paul
    Broadoak
    108 Rouncil Lane
    CV8 1FQ Kenilworth
    Warwickshire
    Amministratore
    Broadoak
    108 Rouncil Lane
    CV8 1FQ Kenilworth
    Warwickshire
    BritishDirector93446780002
    MAY, Joy Elizabeth
    Echo Meadow House
    Grounds Farm Lane
    CV8 1PP Kenilworth
    Warks
    Amministratore
    Echo Meadow House
    Grounds Farm Lane
    CV8 1PP Kenilworth
    Warks
    United KingdomBritishCompany Director91149240002
    JAMES, John Anthony
    Rutland House
    148 Edmund Street
    B3 2JR Birmingham
    Segretario
    Rutland House
    148 Edmund Street
    B3 2JR Birmingham
    British56055780001
    JAMES, John Anthony
    17 Ashleigh Road
    B91 1AE Solihull
    West Midlands
    Segretario
    17 Ashleigh Road
    B91 1AE Solihull
    West Midlands
    British56055780002
    LAMB, Anne
    Rutland Houser 148 Edmund Street
    B3 2JR Birmingham
    Segretario
    Rutland Houser 148 Edmund Street
    B3 2JR Birmingham
    BritishSolicitor75817640001
    MADDOX, Christopher John
    4 Hinchwick Court
    Dorridge
    B93 8DF Solihull
    Wick House
    West Midlands
    Segretario
    4 Hinchwick Court
    Dorridge
    B93 8DF Solihull
    Wick House
    West Midlands
    British133556420001
    MCNAMARA, Anne
    Rutland House
    148 Edmund Street
    B3 2JR Birmingham
    West Midlands
    Segretario
    Rutland House
    148 Edmund Street
    B3 2JR Birmingham
    West Midlands
    British35765830001
    CROSSLEY, Jane Patricia
    110 Rosemary Hill Road
    Streetly
    B74 4HH Sutton Coldfield
    West Midlands
    Amministratore
    110 Rosemary Hill Road
    Streetly
    B74 4HH Sutton Coldfield
    West Midlands
    United KingdomBritish141522120001
    CROSSLEY, Michael Allan
    110 Rosemary Hill Road
    Streetly
    B74 4HH Sutton Coldfield
    West Midlands
    Amministratore
    110 Rosemary Hill Road
    Streetly
    B74 4HH Sutton Coldfield
    West Midlands
    United KingdomBritishDirector9201110001
    HINE, Derek Leslie
    Orchard Cottage
    Holt Heath
    WR6 6NN Worcester
    Worcestershire
    Amministratore
    Orchard Cottage
    Holt Heath
    WR6 6NN Worcester
    Worcestershire
    EnglandEnglishDirector118098210001
    JAMES, John Anthony
    17 Ashleigh Road
    B91 1AE Solihull
    West Midlands
    Amministratore
    17 Ashleigh Road
    B91 1AE Solihull
    West Midlands
    UkBritish56055780002
    LAMB, Anne
    Rutland Houser 148 Edmund Street
    B3 2JR Birmingham
    Amministratore
    Rutland Houser 148 Edmund Street
    B3 2JR Birmingham
    BritishSolicitor75817640001
    MADDOX, Christopher John
    4 Hinchwick Court
    Dorridge
    B93 8DF Solihull
    Wick House
    West Midlands
    Amministratore
    4 Hinchwick Court
    Dorridge
    B93 8DF Solihull
    Wick House
    West Midlands
    EnglandBritishAccountant133556420001
    NORRIS, Terence John
    Woodlands Dukes Covert
    GU19 5HU Bagshot
    Surrey
    Amministratore
    Woodlands Dukes Covert
    GU19 5HU Bagshot
    Surrey
    United KingdomBritishCompany Director8778080001
    TUCKI, Julian Paul
    30 May Lane
    Kings Heath
    B14 4AA Birmingham
    West Midlands
    Amministratore
    30 May Lane
    Kings Heath
    B14 4AA Birmingham
    West Midlands
    United KingdomBritishDirector50099680001
    WALKER SMITH, Andrew Simon Nicholas
    85 Forest House Lane
    Leicester Forest East
    LE3 3NU Leicester
    Leicestershire
    Amministratore
    85 Forest House Lane
    Leicester Forest East
    LE3 3NU Leicester
    Leicestershire
    BritishDirector82441900001
    WITHERS, Ian Stephen
    88 Fitzroy Avenue
    Harborne
    B27 8RQ Birmingham
    West Midlands
    Amministratore
    88 Fitzroy Avenue
    Harborne
    B27 8RQ Birmingham
    West Midlands
    BritishSolicitor33413750001
    WITHERS, Ian Stephen
    Rutland House
    148 Edmund Street
    B3 2JR Birmingham
    West Midlands
    Amministratore
    Rutland House
    148 Edmund Street
    B3 2JR Birmingham
    West Midlands
    BritishSolicitor33413750002
    WITHERS, Ian Stephen
    Rutland House
    148 Edmund Street
    B3 2JR Birmingham
    West Midlands
    Amministratore
    Rutland House
    148 Edmund Street
    B3 2JR Birmingham
    West Midlands
    BritishSolicitor33413750002
    WITHERS, Ian Stephen
    Rutland House
    148 Edmund Street
    B3 2JR Birmingham
    West Midlands
    Amministratore
    Rutland House
    148 Edmund Street
    B3 2JR Birmingham
    West Midlands
    BritishSolicitor33413750002
    WITHERS, Ian Stephen
    Rutland House
    148 Edmund Street
    B3 2JR Birmingham
    West Midlands
    Amministratore
    Rutland House
    148 Edmund Street
    B3 2JR Birmingham
    West Midlands
    BritishSolicitor33413750002
    WITHERS, Ian Stephen
    Rutland House
    148 Edmund Street
    B3 2JR Birmingham
    West Midlands
    Amministratore
    Rutland House
    148 Edmund Street
    B3 2JR Birmingham
    West Midlands
    BritishSolicitor33413750002

    TWR REALISATIONS LIMITED ha ipoteche?

    Ipoteche
    ClassificazioneDateStatoDettagli
    Rent deposit deed
    Creato il 09 nov 2005
    Consegnato il 12 nov 2005
    In corso
    Importo garantito
    £10183.34 and all other monies due or to become due
    Brevi particolari
    The monies standing to the credit from time to time of the interest earning account at a bank in the name of the landlord or its managing agent pursuant to the terms of the rent deposit deed.
    Persone aventi diritto
    • Westfield Mh Investments Limited
    Transazioni
    • 12 nov 2005Registrazione di un'ipoteca (395)
    Debenture
    Creato il 26 apr 2005
    Consegnato il 29 apr 2005
    In corso
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the security beneficiaries or any of them
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Hsbc Bank PLC (As Security Trustee for the Security Beneficiaries)
    Transazioni
    • 29 apr 2005Registrazione di un'ipoteca (395)
    Corporate guarantee
    Creato il 29 lug 2003
    Consegnato il 01 ago 2003
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the principal to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    On demand made by bos at any time on or after the due date payment (subject to any applicable grace periods) the guarantor shall secure the performance of its obligations under the guarantee by depositing with bos such amount up to the maximum amount of the secured liabilities as bos may specify.. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transazioni
    • 01 ago 2003Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 02 lug 2005Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Debenture
    Creato il 29 lug 2003
    Consegnato il 01 ago 2003
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transazioni
    • 01 ago 2003Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 02 lug 2005Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Debenture
    Creato il 15 lug 1999
    Consegnato il 28 lug 1999
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    .. fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Midland Bank PLC
    Transazioni
    • 28 lug 1999Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 05 dic 2002Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    A registered charge
    Creato il 10 lug 1985
    Consegnato il 22 lug 1985
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Fixed & floating charge over the undertaking and all property and assets present and future including book debts & uncalled capital.
    Persone aventi diritto
    • Midland Bank PLC
    Transazioni
    • 22 lug 1985Registrazione di un'ipoteca
    Debenture
    Creato il 20 lug 1984
    Consegnato il 21 lug 1984
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Persone aventi diritto
    • Jane P Crossley
    • Michael a Crossley
    Transazioni
    • 21 lug 1984Registrazione di un'ipoteca
    • 06 giu 1992Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)

    TWR REALISATIONS LIMITED ha procedimenti di insolvenza?

    Numero di praticaDateTipoProfessionistiAltro
    1
    DataTipo
    20 lug 2009Fine dell'amministrazione
    31 gen 2008Inizio dell'amministrazione
    In amministrazione
    NomeRuoloIndirizzoNominato ilCessato il
    Joanne Marie Wright
    Kroll Limited
    Wellington Plaza
    LS1 4DL 31 Wellington Street
    Leeds
    Praticante
    Kroll Limited
    Wellington Plaza
    LS1 4DL 31 Wellington Street
    Leeds
    Peter Mark Saville
    Kroll
    Wellington Plaza
    LS1 4DL 31 Wellington Street
    Leeds
    Praticante
    Kroll
    Wellington Plaza
    LS1 4DL 31 Wellington Street
    Leeds
    Stuart Charles Edward Mackellar
    Wellington Plaza 31 Wellington Street
    LS1 4DL Leeds
    Praticante
    Wellington Plaza 31 Wellington Street
    LS1 4DL Leeds
    2
    DataTipo
    26 gen 2013Data di scioglimento
    20 lug 2009Inizio della liquidazione
    Liquidazione volontaria dei creditori
    NomeRuoloIndirizzoNominato ilCessato il
    Stuart Charles Edward Mackellar
    10 Fleet Place
    EC4M 7RB London
    Praticante
    10 Fleet Place
    EC4M 7RB London
    Peter Mark Saville
    10 Fleet Place
    EC4M 7RB London
    Praticante
    10 Fleet Place
    EC4M 7RB London

    Fonte dati

    • Companies House del Regno Unito
      Il registro ufficiale delle imprese nel Regno Unito, che fornisce l'accesso pubblico alle informazioni sulle imprese, come nomi, indirizzi, amministratori e depositi finanziari.
    • Licenza: CC0