TMS INFORMATION SOLUTIONS LIMITED

TMS INFORMATION SOLUTIONS LIMITED

  • Panoramica
  • Riepilogo
  • Scopo
  • Indirizzo
  • Denominazioni precedenti
  • Bilanci
  • Deposizioni
  • Amministratori
  • Persone con controllo significativo
  • Ipoteche
  • Fonte dati
  • Panoramica

    Nome della societàTMS INFORMATION SOLUTIONS LIMITED
    Stato della societàSciolta
    Forma giuridicaSocietà a responsabilità limitata
    Numero di società 01793902
    GiurisdizioneInghilterra/Galles
    Data di costituzione
    Data di cessazione

    Qual è lo scopo di TMS INFORMATION SOLUTIONS LIMITED?

    • Società inattiva (99999) / Attività di organizzazioni ed organismi extraterritoriali

    Dove si trova TMS INFORMATION SOLUTIONS LIMITED?

    Indirizzo della sede legale
    Dawson House
    5 Jewry Street
    EC3N 2EX London
    England
    Indirizzo della sede legale non recapitabileNo

    Quali erano i nomi precedenti di TMS INFORMATION SOLUTIONS LIMITED?

    Denominazioni sociali precedenti
    Nome della societàDaA
    TMS COMPUTER AUTHORS LIMITED06 giu 198406 giu 1984
    NIMBLECROWN LIMITED22 feb 198422 feb 1984

    Quali sono gli ultimi bilanci di TMS INFORMATION SOLUTIONS LIMITED?

    Ultimi bilanci
    Ultimi bilanci redatti al31 dic 2016

    Quali sono le ultime deposizioni per TMS INFORMATION SOLUTIONS LIMITED?

    Deposizioni
    DataDescrizioneDocumentoTipo

    Gazzetta Ufficiale finale sciolta per scioglimento volontario

    1 pagineGAZ2(A)

    Prima Gazzetta Ufficiale per lo scioglimento volontario

    1 pagineGAZ1(A)

    Richiesta di cancellazione della società dal registro

    3 pagineDS01

    Dichiarazione di conformità presentata il 27 ago 2017 senza aggiornamenti

    3 pagineCS01

    Modifica dei dettagli di Parity Solutions Ltd come persona con controllo significativo il 03 gen 2017

    2 paginePSC05

    Conto per una società dormiente redatto al 31 dic 2016

    4 pagineAA

    Dichiarazione di conformità presentata il 27 ago 2016 con aggiornamenti

    5 pagineCS01

    Conto per una società dormiente redatto al 31 dic 2015

    4 pagineAA

    Indirizzo della sede legale modificato da 2 Bath Place Rivington Street London EC2A 3DR a Dawson House 5 Jewry Street London EC3N 2EX in data 18 apr 2016

    1 pagineAD01

    Bilancio annuale redatto al 27 ago 2015 con elenco completo degli azionisti

    3 pagineAR01
    Deposizioni associate
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    capital23 set 2015

    Stato del capitale al 23 set 2015

    • Capitale: GBP 289,619
    SH01

    Nomina di Mr Roger Harold Antony come segretario in data 30 giu 2015

    2 pagineAP03

    Cessazione della carica di Alastair John Lomond Woolley come segretario in data 30 giu 2015

    1 pagineTM02

    Nomina di Mr Roger Harold Antony come amministratore in data 30 giu 2015

    2 pagineAP01

    Cessazione della carica di Alastair John Lomond Woolley come amministratore in data 30 giu 2015

    1 pagineTM01

    Conto per una società dormiente redatto al 31 dic 2014

    5 pagineAA

    Indirizzo della sede legale modificato da 11 Golden Square London W1F 9JB England a 2 Bath Place Rivington Street London EC2A 3DR in data 09 dic 2014

    1 pagineAD01

    Indirizzo della sede legale modificato da Wimbledon Bridge House First Floor 1 Hartfield Road Wimbledon London SW19 3RU a 11 Golden Square London W1F 9JB in data 25 set 2014

    1 pagineAD01

    Bilancio annuale redatto al 27 ago 2014 con elenco completo degli azionisti

    3 pagineAR01
    Deposizioni associate
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    capital23 set 2014

    Stato del capitale al 23 set 2014

    • Capitale: GBP 289,619
    SH01

    Conto per una società dormiente redatto al 31 dic 2013

    5 pagineAA

    Bilancio annuale redatto al 27 ago 2013 con elenco completo degli azionisti

    3 pagineAR01
    Deposizioni associate
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    capital28 ago 2013

    Stato del capitale al 28 ago 2013

    • Capitale: GBP 289,619
    SH01

    Conto per una società dormiente redatto al 31 dic 2012

    5 pagineAA

    Bilancio annuale redatto al 27 ago 2012 con elenco completo degli azionisti

    3 pagineAR01

    Conto per una società dormiente redatto al 31 dic 2011

    5 pagineAA

    Bilancio annuale redatto al 27 ago 2011 con elenco completo degli azionisti

    3 pagineAR01

    Conto per una società dormiente redatto al 31 dic 2010

    4 pagineAA

    Chi sono gli amministratori di TMS INFORMATION SOLUTIONS LIMITED?

    Amministratori
    NomeNominato ilDimissioni ilRuoloIndirizzoIdentificazione della societàPaese di residenzaNazionalitàData di nascitaProfessioneNumero
    ANTONY, Roger Harold
    5 Jewry Street
    EC3N 2EX London
    Dawson House
    England
    Segretario
    5 Jewry Street
    EC3N 2EX London
    Dawson House
    England
    199221900001
    ANTONY, Roger Harold
    5 Jewry Street
    EC3N 2EX London
    Dawson House
    England
    Amministratore
    5 Jewry Street
    EC3N 2EX London
    Dawson House
    England
    EnglandBritish199013040001
    ARMOUR, Douglas William
    Deramore Ham Lane
    Elstead
    GU8 6HG Godalming
    Surrey
    Segretario nominato
    Deramore Ham Lane
    Elstead
    GU8 6HG Godalming
    Surrey
    British900007320001
    CONNER, Eileen
    1 Kipling Drive
    SW19 1TJ Wimbledon
    Segretario
    1 Kipling Drive
    SW19 1TJ Wimbledon
    British89546940001
    FIRTH, David Samuel Peter
    Wood Mill House
    Shoreham Road
    BN5 9SD Henfield
    West Sussex
    Segretario
    Wood Mill House
    Shoreham Road
    BN5 9SD Henfield
    West Sussex
    British77398810001
    KEEBLE, Michael Philip
    8 Ockley Road
    Ewhurst
    GU6 7QJ Cranleigh
    Surrey
    Segretario
    8 Ockley Road
    Ewhurst
    GU6 7QJ Cranleigh
    Surrey
    British34283070001
    KETCHIN, Ian Malcolm
    118 Goddington Lane
    BR6 9DZ Orpington
    Kent
    Segretario
    118 Goddington Lane
    BR6 9DZ Orpington
    Kent
    British93777900002
    LEYSHON, Alison Jane
    30 Foster Road
    Chiswick
    W4 4NY London
    Segretario
    30 Foster Road
    Chiswick
    W4 4NY London
    British65584930003
    NOLAN, Cheryl
    97 Bailey Bridge Road
    CM7 5TS Braintree
    Essex
    Segretario
    97 Bailey Bridge Road
    CM7 5TS Braintree
    Essex
    British104488100003
    WOOLLEY, Alastair John Lomond
    Bath Place
    Rivington Street
    EC2A 3DR London
    2
    England
    Segretario
    Bath Place
    Rivington Street
    EC2A 3DR London
    2
    England
    159552300001
    BRODIA SERVICES LIMITED
    22 Cogdean Way
    Corfe Mullen
    BH21 3XD Wimborne
    Dorset
    Segretario
    22 Cogdean Way
    Corfe Mullen
    BH21 3XD Wimborne
    Dorset
    4041520002
    FEENEY, James Melvin
    77 London Road West
    BA1 7JE Bath
    Somerset
    Amministratore
    77 London Road West
    BA1 7JE Bath
    Somerset
    British54768460002
    FIRTH, David Samuel Peter
    Wood Mill House
    Shoreham Road
    BN5 9SD Henfield
    West Sussex
    Amministratore
    Wood Mill House
    Shoreham Road
    BN5 9SD Henfield
    West Sussex
    United KingdomBritish77398810001
    GARVEY, Alan
    Edale
    Manor Lea Road, Milford
    GU8 5EF Godalming
    Surrey
    Amministratore
    Edale
    Manor Lea Road, Milford
    GU8 5EF Godalming
    Surrey
    British90284520001
    GEORGE, Gavin
    8 The Drove
    BN1 5NN Brighton
    East Sussex
    Amministratore
    8 The Drove
    BN1 5NN Brighton
    East Sussex
    British105810510001
    HILDER, Jean Ann
    Hale Farm Cottage Loxwood Road
    Rudgwick
    RH12 3BP Horsham
    West Sussex
    Amministratore
    Hale Farm Cottage Loxwood Road
    Rudgwick
    RH12 3BP Horsham
    West Sussex
    British4041530001
    HUGHES, John Llewellyn Mostyn
    Albion Riverside
    8 Hester Road
    SW11 4AR London
    C77
    Amministratore
    Albion Riverside
    8 Hester Road
    SW11 4AR London
    C77
    UkBritish104248860001
    JENNINGS, Keith Murray
    25 Jacaranda House
    Woburn Hill Park
    KT15 2NZ Addlestone
    Surrey
    Amministratore
    25 Jacaranda House
    Woburn Hill Park
    KT15 2NZ Addlestone
    Surrey
    British76560510001
    KETCHIN, Ian Malcolm
    118 Goddington Lane
    BR6 9DZ Orpington
    Kent
    Amministratore
    118 Goddington Lane
    BR6 9DZ Orpington
    Kent
    EnglandBritish93777900002
    KETTERINGHAM, Philip Neal
    19 High Ridge
    GU7 1YE Godalming
    Surrey
    Amministratore
    19 High Ridge
    GU7 1YE Godalming
    Surrey
    British57693050001
    LEYSHON, Alison Jane
    30 Foster Road
    Chiswick
    W4 4NY London
    Amministratore
    30 Foster Road
    Chiswick
    W4 4NY London
    British65584930003
    MCCGWIRE, Patrick Conor
    76a Deodar Road
    SW15 2NJ London
    Amministratore
    76a Deodar Road
    SW15 2NJ London
    British59628620001
    MILLER, Ian Kenneth
    4234 Lomo Alto Court
    Dallas
    Tx75219
    Usa
    Amministratore
    4234 Lomo Alto Court
    Dallas
    Tx75219
    Usa
    United KingdomScottish89546660001
    O'DRISCOLL, Ian
    Two Goods Farm
    Moorside
    DT10 1HQ Marnhull
    Dorset
    Amministratore
    Two Goods Farm
    Moorside
    DT10 1HQ Marnhull
    Dorset
    British68202110001
    PREECE, David Campbell
    Hale Farm Cottage Loxwood Road
    Rudgwick
    RH12 3BP Horsham
    West Sussex
    Amministratore
    Hale Farm Cottage Loxwood Road
    Rudgwick
    RH12 3BP Horsham
    West Sussex
    British34283060001
    WELCH, Alwyn Frank
    Coniston Farnham Lane
    GU27 1EZ Haslemere
    Surrey
    Amministratore
    Coniston Farnham Lane
    GU27 1EZ Haslemere
    Surrey
    EnglandBritish56811010001
    WILLIAMS, Neil
    1 Dowman Close
    Wimbledon
    SW19 2XG London
    Amministratore
    1 Dowman Close
    Wimbledon
    SW19 2XG London
    British57300460002
    WOOLLEY, Alastair John Lomond
    Bath Place
    Rivington Street
    EC2A 3DR London
    2
    England
    Amministratore
    Bath Place
    Rivington Street
    EC2A 3DR London
    2
    England
    United KingdomBritish89506550002

    Chi sono le persone con controllo significativo di TMS INFORMATION SOLUTIONS LIMITED?

    Persone con controllo significativo
    NomeNotificato ilIndirizzoCessato
    5 Jewry Street
    EC3N 2EX London
    Dawson House
    England
    06 apr 2016
    5 Jewry Street
    EC3N 2EX London
    Dawson House
    England
    No
    Forma giuridicaLimited Company
    Paese di registrazioneUk
    Autorità legaleCompanies House Act 2006
    Luogo di registrazioneCompanies House
    Numero di registrazione969618
    Natura del controllo
    • La persona possiede, direttamente o indirettamente, più del 75% delle azioni della società.

    TMS INFORMATION SOLUTIONS LIMITED ha ipoteche?

    Ipoteche
    ClassificazioneDateStatoDettagli
    Deed of admission to an omnibus guarantee and set-off agreement dated 8TH july 1999 and
    Creato il 18 mar 2003
    Consegnato il 26 mar 2003
    In corso
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company and/or all or any of the other companies named therein to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Any sum or sums for the time being standing to the credit of any present or future account of the company with the bank.
    Persone aventi diritto
    • Lloyds Tsb Bank PLC
    Transazioni
    • 26 mar 2003Registrazione di un'ipoteca (395)
    A deed of admission to an omnibus guarantee and set-off agreement dated 8TH july 1999
    Creato il 19 giu 2002
    Consegnato il 25 giu 2002
    In corso
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company and/or all or any of the other companies named therein to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Any sum or sums for the time being standing to the credit of any present or future account of the company with the bank.
    Persone aventi diritto
    • Lloyds Tsb Bank PLC
    Transazioni
    • 25 giu 2002Registrazione di un'ipoteca (395)
    Debenture
    Creato il 30 ott 1991
    Consegnato il 01 nov 1991
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Stock-in-trade work-in-progress. Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Persone aventi diritto
    • 3I Group PLC
    Transazioni
    • 01 nov 1991Registrazione di un'ipoteca
    • 08 mag 1999Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Single debenture
    Creato il 05 ott 1987
    Consegnato il 14 ott 1987
    In corso
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Inc all heritable property in scotlands.. Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Persone aventi diritto
    • Lloyds Bank PLC
    Transazioni
    • 14 ott 1987Registrazione di un'ipoteca

    Fonte dati

    • Companies House del Regno Unito
      Il registro ufficiale delle imprese nel Regno Unito, che fornisce l'accesso pubblico alle informazioni sulle imprese, come nomi, indirizzi, amministratori e depositi finanziari.
    • Licenza: CC0