APC DC NETWORK SOLUTIONS UK LIMITED

APC DC NETWORK SOLUTIONS UK LIMITED

  • Panoramica
  • Riepilogo
  • Scopo
  • Indirizzo
  • Denominazioni precedenti
  • Bilanci
  • Deposizioni
  • Amministratori
  • Persone con controllo significativo
  • Ipoteche
  • Fonte dati
  • Panoramica

    Nome della societàAPC DC NETWORK SOLUTIONS UK LIMITED
    Stato della societàSciolta
    Forma giuridicaSocietà a responsabilità limitata
    Numero di società 01794380
    GiurisdizioneInghilterra/Galles
    Data di costituzione
    Data di cessazione

    Qual è lo scopo di APC DC NETWORK SOLUTIONS UK LIMITED?

    • Società non commerciali (74990) / Attività professionali, scientifiche e tecniche
    • Società inattiva (99999) / Attività di organizzazioni ed organismi extraterritoriali

    Dove si trova APC DC NETWORK SOLUTIONS UK LIMITED?

    Indirizzo della sede legale
    Schneider Electric
    Stafford Park 5
    TF3 3BL Telford
    England
    Indirizzo della sede legale non recapitabileNo

    Quali erano i nomi precedenti di APC DC NETWORK SOLUTIONS UK LIMITED?

    Denominazioni sociali precedenti
    Nome della societàDaA
    ADVANCE POWER LIMITED01 ago 199501 ago 1995
    FARNELL POWER LIMITED01 feb 199301 feb 1993
    ADVANCE POWER SUPPLIES LIMITED22 set 198822 set 1988
    BONAR ADVANCE LIMITED18 dic 198718 dic 1987
    ADVANCE POWER SUPPLIES LIMITED15 mar 198415 mar 1984
    REGALISER LIMITED23 feb 198423 feb 1984

    Quali sono gli ultimi bilanci di APC DC NETWORK SOLUTIONS UK LIMITED?

    Ultimi bilanci
    Ultimi bilanci redatti al31 dic 2021

    Quali sono le ultime deposizioni per APC DC NETWORK SOLUTIONS UK LIMITED?

    Deposizioni
    DataDescrizioneDocumentoTipo

    Gazzetta Ufficiale finale sciolta per scioglimento volontario

    1 pagineGAZ2(A)

    Prima Gazzetta Ufficiale per lo scioglimento volontario

    1 pagineGAZ1(A)

    Richiesta di cancellazione della società dal registro

    3 pagineDS01

    Dichiarazione di conformità presentata il 17 giu 2022 con aggiornamenti

    4 pagineCS01

    Cessazione della carica di Trevor Lambeth come amministratore in data 31 mar 2022

    1 pagineTM01

    Conto per una società dormiente redatto al 31 dic 2021

    9 pagineAA

    Nomina di Antoine Marie Sage come amministratore in data 15 feb 2022

    2 pagineAP01

    I registri sono stati trasferiti al luogo di ispezione registrato 7 Albemarle Street London W1S 4HQ

    1 pagineAD03

    L'indirizzo di ispezione del registro è stato modificato a 7 Albemarle Street London W1S 4HQ

    1 pagineAD02

    Dettagli del segretario cambiati per Invensys Secretaries Limited il 31 ott 2016

    1 pagineCH04

    Dichiarazione di conformità presentata il 17 giu 2021 con aggiornamenti

    4 pagineCS01

    Conto per una società dormiente redatto al 31 dic 2020

    10 pagineAA

    Dichiarazione di conformità presentata il 17 giu 2020 con aggiornamenti

    4 pagineCS01

    Modifica dei dettagli di American Power Conversion Holdings (Uk) Limited come persona con controllo significativo il 10 lug 2017

    2 paginePSC05

    Conto per una società dormiente redatto al 31 dic 2019

    11 pagineAA

    Bilancio per una piccola impresa redatto al 31 dic 2018

    16 pagineAA

    Dichiarazione di conformità presentata il 17 giu 2019 con aggiornamenti

    4 pagineCS01

    Dichiarazione di conformità presentata il 17 giu 2018 con aggiornamenti

    4 pagineCS01

    Stato del capitale al 23 apr 2018

    • Capitale: GBP 1
    3 pagineSH19

    legacy

    2 pagineSH20

    legacy

    3 pagineCAP-SS

    Risoluzioni

    Resolutions
    1 pagineRESOLUTIONS
    Risoluzioni
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    capital

    Risoluzioni

    Cancel share prem a/c & other reserves. Sum created by reduction credited to distributable reserve 27/03/2018
    RES13
    capital

    Risoluzione di riduzione del capitale sociale emesso

    RES06

    Conto per una società dormiente redatto al 31 dic 2017

    11 pagineAA

    Bilancio redatto al 31 dic 2016

    16 pagineAA

    Indirizzo della sede legale modificato da 2nd Floor, 80 Victoria Street London SW1E 5JL a Schneider Electric Stafford Park 5 Telford TF3 3BL in data 19 lug 2017

    1 pagineAD01

    Chi sono gli amministratori di APC DC NETWORK SOLUTIONS UK LIMITED?

    Amministratori
    NomeNominato ilDimissioni ilRuoloIndirizzoIdentificazione della societàPaese di residenzaNazionalitàData di nascitaProfessioneNumero
    INVENSYS SECRETARIES LIMITED
    Stafford Park 5
    TF3 3BL Telford
    Schneider Electric
    England
    Segretario
    Stafford Park 5
    TF3 3BL Telford
    Schneider Electric
    England
    Tipo di documento di identificazioneSocietà a responsabilità limitata del Regno Unito
    Numero di registrazione1070856
    75491680003
    RICCI, Michael John
    Fairgrounds Road
    West Kingston
    132
    Rhode Island 02892
    United States
    Amministratore
    Fairgrounds Road
    West Kingston
    132
    Rhode Island 02892
    United States
    United StatesAmericanCorporate Controller69785400001
    SAGE, Antoine Marie
    80 Victoria Street
    SW1E 5JL London
    Schneider Electric
    England
    Amministratore
    80 Victoria Street
    SW1E 5JL London
    Schneider Electric
    England
    EnglandFrenchChief Financial Officer Uk & I285147660002
    ATKINSON, Richard
    5 Lukins Drive
    CM6 1XQ Dunmow
    Essex
    Segretario
    5 Lukins Drive
    CM6 1XQ Dunmow
    Essex
    British60376890001
    ELSTONE, Henry Claude
    Valley House
    Darrington
    WF8 3BT Pontefract
    West Yorkshire
    Segretario
    Valley House
    Darrington
    WF8 3BT Pontefract
    West Yorkshire
    British81771100001
    LEIGHTON, Iain Gordon Kerr
    71 Rectory Grove
    Clapham Common
    SW4 0DS London
    Segretario
    71 Rectory Grove
    Clapham Common
    SW4 0DS London
    British42841660001
    MULLEN, Kenneth John
    Tonhil House
    Borrowby
    YO7 4QQ Thirsk
    North Yorkshire
    Segretario
    Tonhil House
    Borrowby
    YO7 4QQ Thirsk
    North Yorkshire
    Scottish146642810001
    ABOGADO NOMINEES LIMITED
    New Bridge Street
    EC4V 6JA London
    100
    United Kingdom
    Segretario nominato
    New Bridge Street
    EC4V 6JA London
    100
    United Kingdom
    Tipo di documento di identificazioneSEE
    Numero di registrazione1688036
    900021150001
    PINSENT MASONS SECRETARIAL LIMITED
    Park Row
    LS1 5AB Leeds
    1
    United Kingdom
    Segretario
    Park Row
    LS1 5AB Leeds
    1
    United Kingdom
    Tipo di documento di identificazioneSEE
    Numero di registrazione2318923
    76579530001
    PINSENT MASONS SECRETARIAL LIMITED
    1 Park Row
    LS1 5AB Leeds
    West Yorkshire
    Segretario
    1 Park Row
    LS1 5AB Leeds
    West Yorkshire
    76579530001
    AUSTIN, Carey Jean Julian
    31 Upper Brighton Road
    BN14 9HY Worthing
    West Sussex
    Amministratore
    31 Upper Brighton Road
    BN14 9HY Worthing
    West Sussex
    United KingdomBritishCompany Director28291620001
    BARDOS, Peter Andrew
    55 Havers Lane
    CM23 3PA Bishops Stortford
    Hertfordshire
    Amministratore
    55 Havers Lane
    CM23 3PA Bishops Stortford
    Hertfordshire
    BritishEngineer15830020001
    BARLOCK, Paul Regis
    Chancery House
    The Old Palace Palace Road
    Ripon
    North Yorkshire
    Amministratore
    Chancery House
    The Old Palace Palace Road
    Ripon
    North Yorkshire
    BritishDirector60958980001
    BELISARIO, Anthony Alfredo
    24 Coronation Road
    Prestbury
    GL52 3DA Cheltenham
    Gloucestershire
    Amministratore
    24 Coronation Road
    Prestbury
    GL52 3DA Cheltenham
    Gloucestershire
    United KingdomBritishChief Executive19258750001
    DOWDING, Keith Stuart
    12 Nursery View
    SN7 8SJ Faringdon
    Oxfordshire
    Amministratore
    12 Nursery View
    SN7 8SJ Faringdon
    Oxfordshire
    BritishDirector60105220001
    EATON, Michael Roy
    1 Lonsdale
    CB1 6LT Linton
    Cambridgeshire
    Amministratore
    1 Lonsdale
    CB1 6LT Linton
    Cambridgeshire
    BritishSales Director76022370001
    FAIRLAMB, David Andrew
    The Manse Church Street
    Henham
    CM22 6AJ Bishops Stortford
    Hertfordshire
    Amministratore
    The Manse Church Street
    Henham
    CM22 6AJ Bishops Stortford
    Hertfordshire
    BritishAccountant28796300001
    FISHER, Andrew Charles
    5 Esholt Avenue
    Guiseley
    LS20 8AX Leeds
    West Yorkshire
    Amministratore
    5 Esholt Avenue
    Guiseley
    LS20 8AX Leeds
    West Yorkshire
    BritishFinance Director41331580001
    GIGUERE, Jeffrey Joseph
    82 Keene Street
    Providence
    Rhode Island 02906
    Usa
    Amministratore
    82 Keene Street
    Providence
    Rhode Island 02906
    Usa
    United StatesAmericanDirector Of Legal Affairs69785660002
    HALL, Eric
    Barton House
    River View
    LS23 6BA Boston Spa
    West Yorkshire
    Amministratore
    Barton House
    River View
    LS23 6BA Boston Spa
    West Yorkshire
    EnglandBritishDirector Of Companies9835660001
    HODGSON, Peter
    37 Oakwood Road
    LS22 7QY Wetherby
    West Yorkshire
    Amministratore
    37 Oakwood Road
    LS22 7QY Wetherby
    West Yorkshire
    United KingdomBritishCompany Director33266670001
    JONES, David Alan
    Tredragon
    Church Street Long Marston
    YO5 8NW York
    Amministratore
    Tredragon
    Church Street Long Marston
    YO5 8NW York
    BritishCompany Director9835650001
    JONES, David Alan
    Tredragon
    Church Street Long Marston
    YO5 8NW York
    Amministratore
    Tredragon
    Church Street Long Marston
    YO5 8NW York
    BritishDirector Of Companies9835650001
    KIDD, Raymond
    3 Rosedale
    Pannal
    HG3 1LB Harrogate
    North Yorkshire
    Amministratore
    3 Rosedale
    Pannal
    HG3 1LB Harrogate
    North Yorkshire
    BritishDirector Of Companies11224840001
    LAMBETH, Trevor
    c/o Schneider Electric Limited
    Stafford Park 5
    TF3 3BL Telford
    Shropshire
    United Kingdom
    Amministratore
    c/o Schneider Electric Limited
    Stafford Park 5
    TF3 3BL Telford
    Shropshire
    United Kingdom
    EnglandBritishAccountant85777080001
    LAMMING, Philip Andrew
    25 Leconfield Garth
    Follifoot
    HG3 1NF Harrogate
    North Yorkshire
    Amministratore
    25 Leconfield Garth
    Follifoot
    HG3 1NF Harrogate
    North Yorkshire
    BritishCompany Director29764990001
    MCKENZIE, Ian Munro
    12 The Fairway
    Bar Hill
    CB3 8SR Cambridge
    Cambridgeshire
    Amministratore
    12 The Fairway
    Bar Hill
    CB3 8SR Cambridge
    Cambridgeshire
    AustralianCompany Director18803950001
    MUIR, Donald Michael
    44 East Shore Road
    Jamestown
    Rhode Island 02835
    Usa
    Amministratore
    44 East Shore Road
    Jamestown
    Rhode Island 02835
    Usa
    UsaCfo & Vice Pres Finance & Admi69785570001
    MULLEN, Kenneth John
    Tonhil House
    Borrowby
    YO7 4QQ Thirsk
    North Yorkshire
    Amministratore
    Tonhil House
    Borrowby
    YO7 4QQ Thirsk
    North Yorkshire
    United KingdomScottishCompany Secretary146642810001
    PARKINSON, Kenneth
    15 Meyrick Avenue
    LS22 6SP Wetherby
    West Yorkshire
    Amministratore
    15 Meyrick Avenue
    LS22 6SP Wetherby
    West Yorkshire
    BritishCompany Director43257300001
    PARKINSON, Kenneth
    15 Meyrick Avenue
    LS22 6SP Wetherby
    Amministratore
    15 Meyrick Avenue
    LS22 6SP Wetherby
    BritishDirector Of Companies33266680001
    PERRET, Sylvie Therese
    Av Jean Kuntzmann Montbonnot
    Saint Ismier
    140
    38334
    France
    Amministratore
    Av Jean Kuntzmann Montbonnot
    Saint Ismier
    140
    38334
    France
    FranceFrenchSchneider It Emea Vp Finance149971880001
    WARD, Peter Douglas
    90 Station Road
    Burley In Wharfedale
    LS29 7NS Ilkley
    West Yorkshire
    Amministratore
    90 Station Road
    Burley In Wharfedale
    LS29 7NS Ilkley
    West Yorkshire
    EnglishDirector Of Companies48821190001
    WEXLER, Peter
    4 Deep Meadow Road
    Barrington 02806
    Rhode Island
    U S A
    Amministratore
    4 Deep Meadow Road
    Barrington 02806
    Rhode Island
    U S A
    UsaAmericanAttorney122137850001

    Chi sono le persone con controllo significativo di APC DC NETWORK SOLUTIONS UK LIMITED?

    Persone con controllo significativo
    NomeNotificato ilIndirizzoCessato
    Stafford Park 5
    TF3 3BL Telford
    Schneider Electric
    England
    06 apr 2016
    Stafford Park 5
    TF3 3BL Telford
    Schneider Electric
    England
    No
    Forma giuridicaPrivate Limited Company
    Paese di registrazioneEngland
    Autorità legaleCompanies Act 2006
    Luogo di registrazioneCompanies House
    Numero di registrazione03972902
    Natura del controllo
    • La persona possiede, direttamente o indirettamente, più del 75% delle azioni della società.
    • La persona detiene, direttamente o indirettamente, più del 75% dei diritti di voto nella società.
    • La persona ha il diritto, direttamente o indirettamente, di nominare o rimuovere la maggioranza del consiglio di amministrazione della società.

    APC DC NETWORK SOLUTIONS UK LIMITED ha ipoteche?

    Ipoteche
    ClassificazioneDateStatoDettagli
    Guarantee and debenture
    Creato il 21 apr 1995
    Consegnato il 27 apr 1995
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All present and future obligations and liabilities (whether actual or contingentand whether owed jointly or severally or as principal debtor, guarantor, surety or otherwise or as the equivalent obligor under the laws of any jurisdiction) of each obligor (as defined) to the chargee and the lenders and to any of them under the financing documents (as defined)
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • The Royal Bank of Scotland PLC
    Transazioni
    • 27 apr 1995Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 19 apr 2000Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Supplemental debenture
    Creato il 26 giu 1985
    Consegnato il 09 lug 1985
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee pursuant to a loan agreement dated 13.4.84 as amended by a supplemental agreement dated 3.6.85 and all monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    F/H land at raynham road, bishop stortford (full detailes see doc M12). Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Persone aventi diritto
    • The First National Bank of Boston
    Transazioni
    • 09 lug 1985Registrazione di un'ipoteca
    Charge
    Creato il 16 apr 1984
    Consegnato il 24 apr 1984
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Land rear the dannion rd biships storpord fixed & floating charge undertaking and all property and assets present and future including goodwill, book debts uncalled capital, all buildings, fixtures fixed plant and machinery.
    Persone aventi diritto
    • Gould Instruments Limited
    Transazioni
    • 24 apr 1984Registrazione di un'ipoteca
    Debenture
    Creato il 16 apr 1984
    Consegnato il 19 apr 1984
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee supplemental to a loan agreement dated 13.4.84
    Brevi particolari
    Legal motgage over f/h land at raynham road, bisliops stortford. Fixed & floating charge over undertaking and all property and assets present and future including good will book debts, uncalled capital all buildings fixtures, fixed plant and machinery all stocks shares & other securities.
    Persone aventi diritto
    • The First National Bank of Boston
    Transazioni
    • 19 apr 1984Registrazione di un'ipoteca

    Fonte dati

    • Companies House del Regno Unito
      Il registro ufficiale delle imprese nel Regno Unito, che fornisce l'accesso pubblico alle informazioni sulle imprese, come nomi, indirizzi, amministratori e depositi finanziari.
    • Licenza: CC0