APC DC NETWORK SOLUTIONS UK LIMITED
Panoramica
Nome della società | APC DC NETWORK SOLUTIONS UK LIMITED |
---|---|
Stato della società | Sciolta |
Forma giuridica | Società a responsabilità limitata |
Numero di società | 01794380 |
Giurisdizione | Inghilterra/Galles |
Data di costituzione | |
Data di cessazione |
Riepilogo
Ha PSCs super sicuri | No |
---|---|
Ha ipoteche | Sì |
Ha una storia di insolvenza | No |
La sede legale è in contestazione | No |
Qual è lo scopo di APC DC NETWORK SOLUTIONS UK LIMITED?
- Società non commerciali (74990) / Attività professionali, scientifiche e tecniche
- Società inattiva (99999) / Attività di organizzazioni ed organismi extraterritoriali
Dove si trova APC DC NETWORK SOLUTIONS UK LIMITED?
Indirizzo della sede legale | Schneider Electric Stafford Park 5 TF3 3BL Telford England |
---|---|
Indirizzo della sede legale non recapitabile | No |
Quali erano i nomi precedenti di APC DC NETWORK SOLUTIONS UK LIMITED?
Nome della società | Da | A |
---|---|---|
ADVANCE POWER LIMITED | 01 ago 1995 | 01 ago 1995 |
FARNELL POWER LIMITED | 01 feb 1993 | 01 feb 1993 |
ADVANCE POWER SUPPLIES LIMITED | 22 set 1988 | 22 set 1988 |
BONAR ADVANCE LIMITED | 18 dic 1987 | 18 dic 1987 |
ADVANCE POWER SUPPLIES LIMITED | 15 mar 1984 | 15 mar 1984 |
REGALISER LIMITED | 23 feb 1984 | 23 feb 1984 |
Quali sono gli ultimi bilanci di APC DC NETWORK SOLUTIONS UK LIMITED?
Ultimi bilanci | |
---|---|
Ultimi bilanci redatti al | 31 dic 2021 |
Quali sono le ultime deposizioni per APC DC NETWORK SOLUTIONS UK LIMITED?
Data | Descrizione | Documento | Tipo | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gazzetta Ufficiale finale sciolta per scioglimento volontario | 1 pagine | GAZ2(A) | ||||||||||||||
Prima Gazzetta Ufficiale per lo scioglimento volontario | 1 pagine | GAZ1(A) | ||||||||||||||
Richiesta di cancellazione della società dal registro | 3 pagine | DS01 | ||||||||||||||
Dichiarazione di conformità presentata il 17 giu 2022 con aggiornamenti | 4 pagine | CS01 | ||||||||||||||
Cessazione della carica di Trevor Lambeth come amministratore in data 31 mar 2022 | 1 pagine | TM01 | ||||||||||||||
Conto per una società dormiente redatto al 31 dic 2021 | 9 pagine | AA | ||||||||||||||
Nomina di Antoine Marie Sage come amministratore in data 15 feb 2022 | 2 pagine | AP01 | ||||||||||||||
I registri sono stati trasferiti al luogo di ispezione registrato 7 Albemarle Street London W1S 4HQ | 1 pagine | AD03 | ||||||||||||||
L'indirizzo di ispezione del registro è stato modificato a 7 Albemarle Street London W1S 4HQ | 1 pagine | AD02 | ||||||||||||||
Dettagli del segretario cambiati per Invensys Secretaries Limited il 31 ott 2016 | 1 pagine | CH04 | ||||||||||||||
Dichiarazione di conformità presentata il 17 giu 2021 con aggiornamenti | 4 pagine | CS01 | ||||||||||||||
Conto per una società dormiente redatto al 31 dic 2020 | 10 pagine | AA | ||||||||||||||
Dichiarazione di conformità presentata il 17 giu 2020 con aggiornamenti | 4 pagine | CS01 | ||||||||||||||
Modifica dei dettagli di American Power Conversion Holdings (Uk) Limited come persona con controllo significativo il 10 lug 2017 | 2 pagine | PSC05 | ||||||||||||||
Conto per una società dormiente redatto al 31 dic 2019 | 11 pagine | AA | ||||||||||||||
Bilancio per una piccola impresa redatto al 31 dic 2018 | 16 pagine | AA | ||||||||||||||
Dichiarazione di conformità presentata il 17 giu 2019 con aggiornamenti | 4 pagine | CS01 | ||||||||||||||
Dichiarazione di conformità presentata il 17 giu 2018 con aggiornamenti | 4 pagine | CS01 | ||||||||||||||
Stato del capitale al 23 apr 2018
| 3 pagine | SH19 | ||||||||||||||
legacy | 2 pagine | SH20 | ||||||||||||||
legacy | 3 pagine | CAP-SS | ||||||||||||||
Risoluzioni Resolutions | 1 pagine | RESOLUTIONS | ||||||||||||||
| ||||||||||||||||
Conto per una società dormiente redatto al 31 dic 2017 | 11 pagine | AA | ||||||||||||||
Bilancio redatto al 31 dic 2016 | 16 pagine | AA | ||||||||||||||
Indirizzo della sede legale modificato da 2nd Floor, 80 Victoria Street London SW1E 5JL a Schneider Electric Stafford Park 5 Telford TF3 3BL in data 19 lug 2017 | 1 pagine | AD01 | ||||||||||||||
Chi sono gli amministratori di APC DC NETWORK SOLUTIONS UK LIMITED?
Nome | Nominato il | Dimissioni il | Ruolo | Indirizzo | Identificazione della società | Paese di residenza | Nazionalità | Data di nascita | Professione | Numero | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
INVENSYS SECRETARIES LIMITED | Segretario | Stafford Park 5 TF3 3BL Telford Schneider Electric England |
| 75491680003 | ||||||||||
RICCI, Michael John | Amministratore | Fairgrounds Road West Kingston 132 Rhode Island 02892 United States | United States | American | Corporate Controller | 69785400001 | ||||||||
SAGE, Antoine Marie | Amministratore | 80 Victoria Street SW1E 5JL London Schneider Electric England | England | French | Chief Financial Officer Uk & I | 285147660002 | ||||||||
ATKINSON, Richard | Segretario | 5 Lukins Drive CM6 1XQ Dunmow Essex | British | 60376890001 | ||||||||||
ELSTONE, Henry Claude | Segretario | Valley House Darrington WF8 3BT Pontefract West Yorkshire | British | 81771100001 | ||||||||||
LEIGHTON, Iain Gordon Kerr | Segretario | 71 Rectory Grove Clapham Common SW4 0DS London | British | 42841660001 | ||||||||||
MULLEN, Kenneth John | Segretario | Tonhil House Borrowby YO7 4QQ Thirsk North Yorkshire | Scottish | 146642810001 | ||||||||||
ABOGADO NOMINEES LIMITED | Segretario nominato | New Bridge Street EC4V 6JA London 100 United Kingdom |
| 900021150001 | ||||||||||
PINSENT MASONS SECRETARIAL LIMITED | Segretario | Park Row LS1 5AB Leeds 1 United Kingdom |
| 76579530001 | ||||||||||
PINSENT MASONS SECRETARIAL LIMITED | Segretario | 1 Park Row LS1 5AB Leeds West Yorkshire | 76579530001 | |||||||||||
AUSTIN, Carey Jean Julian | Amministratore | 31 Upper Brighton Road BN14 9HY Worthing West Sussex | United Kingdom | British | Company Director | 28291620001 | ||||||||
BARDOS, Peter Andrew | Amministratore | 55 Havers Lane CM23 3PA Bishops Stortford Hertfordshire | British | Engineer | 15830020001 | |||||||||
BARLOCK, Paul Regis | Amministratore | Chancery House The Old Palace Palace Road Ripon North Yorkshire | British | Director | 60958980001 | |||||||||
BELISARIO, Anthony Alfredo | Amministratore | 24 Coronation Road Prestbury GL52 3DA Cheltenham Gloucestershire | United Kingdom | British | Chief Executive | 19258750001 | ||||||||
DOWDING, Keith Stuart | Amministratore | 12 Nursery View SN7 8SJ Faringdon Oxfordshire | British | Director | 60105220001 | |||||||||
EATON, Michael Roy | Amministratore | 1 Lonsdale CB1 6LT Linton Cambridgeshire | British | Sales Director | 76022370001 | |||||||||
FAIRLAMB, David Andrew | Amministratore | The Manse Church Street Henham CM22 6AJ Bishops Stortford Hertfordshire | British | Accountant | 28796300001 | |||||||||
FISHER, Andrew Charles | Amministratore | 5 Esholt Avenue Guiseley LS20 8AX Leeds West Yorkshire | British | Finance Director | 41331580001 | |||||||||
GIGUERE, Jeffrey Joseph | Amministratore | 82 Keene Street Providence Rhode Island 02906 Usa | United States | American | Director Of Legal Affairs | 69785660002 | ||||||||
HALL, Eric | Amministratore | Barton House River View LS23 6BA Boston Spa West Yorkshire | England | British | Director Of Companies | 9835660001 | ||||||||
HODGSON, Peter | Amministratore | 37 Oakwood Road LS22 7QY Wetherby West Yorkshire | United Kingdom | British | Company Director | 33266670001 | ||||||||
JONES, David Alan | Amministratore | Tredragon Church Street Long Marston YO5 8NW York | British | Company Director | 9835650001 | |||||||||
JONES, David Alan | Amministratore | Tredragon Church Street Long Marston YO5 8NW York | British | Director Of Companies | 9835650001 | |||||||||
KIDD, Raymond | Amministratore | 3 Rosedale Pannal HG3 1LB Harrogate North Yorkshire | British | Director Of Companies | 11224840001 | |||||||||
LAMBETH, Trevor | Amministratore | c/o Schneider Electric Limited Stafford Park 5 TF3 3BL Telford Shropshire United Kingdom | England | British | Accountant | 85777080001 | ||||||||
LAMMING, Philip Andrew | Amministratore | 25 Leconfield Garth Follifoot HG3 1NF Harrogate North Yorkshire | British | Company Director | 29764990001 | |||||||||
MCKENZIE, Ian Munro | Amministratore | 12 The Fairway Bar Hill CB3 8SR Cambridge Cambridgeshire | Australian | Company Director | 18803950001 | |||||||||
MUIR, Donald Michael | Amministratore | 44 East Shore Road Jamestown Rhode Island 02835 Usa | Usa | Cfo & Vice Pres Finance & Admi | 69785570001 | |||||||||
MULLEN, Kenneth John | Amministratore | Tonhil House Borrowby YO7 4QQ Thirsk North Yorkshire | United Kingdom | Scottish | Company Secretary | 146642810001 | ||||||||
PARKINSON, Kenneth | Amministratore | 15 Meyrick Avenue LS22 6SP Wetherby West Yorkshire | British | Company Director | 43257300001 | |||||||||
PARKINSON, Kenneth | Amministratore | 15 Meyrick Avenue LS22 6SP Wetherby | British | Director Of Companies | 33266680001 | |||||||||
PERRET, Sylvie Therese | Amministratore | Av Jean Kuntzmann Montbonnot Saint Ismier 140 38334 France | France | French | Schneider It Emea Vp Finance | 149971880001 | ||||||||
WARD, Peter Douglas | Amministratore | 90 Station Road Burley In Wharfedale LS29 7NS Ilkley West Yorkshire | English | Director Of Companies | 48821190001 | |||||||||
WEXLER, Peter | Amministratore | 4 Deep Meadow Road Barrington 02806 Rhode Island U S A | Usa | American | Attorney | 122137850001 |
Chi sono le persone con controllo significativo di APC DC NETWORK SOLUTIONS UK LIMITED?
Nome | Notificato il | Indirizzo | Cessato | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
American Power Conversion Holdings (Uk) Limited | 06 apr 2016 | Stafford Park 5 TF3 3BL Telford Schneider Electric England | No | ||||||||||
| |||||||||||||
Natura del controllo
|
APC DC NETWORK SOLUTIONS UK LIMITED ha ipoteche?
Classificazione | Date | Stato | Dettagli | |
---|---|---|---|---|
Guarantee and debenture | Creato il 21 apr 1995 Consegnato il 27 apr 1995 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All present and future obligations and liabilities (whether actual or contingentand whether owed jointly or severally or as principal debtor, guarantor, surety or otherwise or as the equivalent obligor under the laws of any jurisdiction) of each obligor (as defined) to the chargee and the lenders and to any of them under the financing documents (as defined) | |
Brevi particolari Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
Supplemental debenture | Creato il 26 giu 1985 Consegnato il 09 lug 1985 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due or to become due from the company to the chargee pursuant to a loan agreement dated 13.4.84 as amended by a supplemental agreement dated 3.6.85 and all monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Brevi particolari F/H land at raynham road, bishop stortford (full detailes see doc M12). Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
Charge | Creato il 16 apr 1984 Consegnato il 24 apr 1984 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Brevi particolari Land rear the dannion rd biships storpord fixed & floating charge undertaking and all property and assets present and future including goodwill, book debts uncalled capital, all buildings, fixtures fixed plant and machinery. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
Debenture | Creato il 16 apr 1984 Consegnato il 19 apr 1984 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due or to become due from the company to the chargee supplemental to a loan agreement dated 13.4.84 | |
Brevi particolari Legal motgage over f/h land at raynham road, bisliops stortford. Fixed & floating charge over undertaking and all property and assets present and future including good will book debts, uncalled capital all buildings fixtures, fixed plant and machinery all stocks shares & other securities. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
|
Fonte dati
- Companies House del Regno Unito
Il registro ufficiale delle imprese nel Regno Unito, che fornisce l'accesso pubblico alle informazioni sulle imprese, come nomi, indirizzi, amministratori e depositi finanziari. - Licenza: CC0