PENTA WATFORD LIMITED
Panoramica
Nome della società | PENTA WATFORD LIMITED |
---|---|
Stato della società | Sciolta |
Forma giuridica | Società a responsabilità limitata |
Numero di società | 01794529 |
Giurisdizione | Inghilterra/Galles |
Data di costituzione | |
Data di cessazione |
Riepilogo
Ha PSCs super sicuri | No |
---|---|
Ha ipoteche | Sì |
Ha una storia di insolvenza | No |
La sede legale è in contestazione | No |
Qual è lo scopo di PENTA WATFORD LIMITED?
- Società non commerciali (74990) / Attività professionali, scientifiche e tecniche
Dove si trova PENTA WATFORD LIMITED?
Indirizzo della sede legale | First Floor Unit 3140 Park Square Solihull Parkway Birmingham Business Park B37 7YN Birmingham |
---|---|
Indirizzo della sede legale non recapitabile | No |
Quali erano i nomi precedenti di PENTA WATFORD LIMITED?
Nome della società | Da | A |
---|---|---|
ROSE OF WATFORD LIMITED | 16 nov 1984 | 16 nov 1984 |
ROSE MOTOR SALES LIMITED | 23 feb 1984 | 23 feb 1984 |
Quali sono gli ultimi bilanci di PENTA WATFORD LIMITED?
Ultimi bilanci | |
---|---|
Ultimi bilanci redatti al | 31 dic 2019 |
Quali sono le ultime deposizioni per PENTA WATFORD LIMITED?
Data | Descrizione | Documento | Tipo | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gazzetta Ufficiale finale sciolta per scioglimento volontario | 1 pagine | GAZ2(A) | ||||||||||
Prima Gazzetta Ufficiale per lo scioglimento volontario | 1 pagine | GAZ1(A) | ||||||||||
Richiesta di cancellazione della società dal registro | 1 pagine | DS01 | ||||||||||
Conto per una società dormiente redatto al 31 dic 2019 | 6 pagine | AA | ||||||||||
Dichiarazione di conformità presentata il 05 giu 2020 senza aggiornamenti | 3 pagine | CS01 | ||||||||||
Cessazione della carica di Thomas Andrew Dale come amministratore in data 29 gen 2020 | 1 pagine | TM01 | ||||||||||
Conto per una società dormiente redatto al 31 dic 2018 | 6 pagine | AA | ||||||||||
Nomina di Inchcape Uk Corporate Management Limited come segretario in data 04 lug 2019 | 2 pagine | AP04 | ||||||||||
Nomina di Mr Thomas Andrew Dale come amministratore in data 04 lug 2019 | 2 pagine | AP01 | ||||||||||
Cessazione della carica di Anton Clive Jeary come amministratore in data 04 lug 2019 | 1 pagine | TM01 | ||||||||||
Cessazione della carica di Anton Clive Jeary come segretario in data 04 lug 2019 | 1 pagine | TM02 | ||||||||||
Dichiarazione di conformità presentata il 05 giu 2019 senza aggiornamenti | 3 pagine | CS01 | ||||||||||
Conto per una società dormiente redatto al 31 dic 2017 | 6 pagine | AA | ||||||||||
Dichiarazione di conformità presentata il 05 giu 2018 senza aggiornamenti | 3 pagine | CS01 | ||||||||||
Modifica dei dettagli di Inchcape Motors International Limited come persona con controllo significativo il 01 apr 2018 | 5 pagine | PSC05 | ||||||||||
Indirizzo della sede legale modificato da Inchcape House Langford Lane Kidlington Oxford OX5 1HT a First Floor Unit 3140 Park Square Solihull Parkway Birmingham Business Park Birmingham B37 7YN in data 09 apr 2018 | 2 pagine | AD01 | ||||||||||
Conto per una società dormiente redatto al 31 dic 2016 | 6 pagine | AA | ||||||||||
Dichiarazione di conformità presentata il 05 giu 2017 con aggiornamenti | 5 pagine | CS01 | ||||||||||
Conto per una società dormiente redatto al 31 dic 2015 | 6 pagine | AA | ||||||||||
Bilancio annuale redatto al 05 giu 2016 con elenco completo degli azionisti | 4 pagine | AR01 | ||||||||||
| ||||||||||||
Dettagli del direttore cambiati per Mr Martin Peter Wheatley il 29 gen 2016 | 3 pagine | CH01 | ||||||||||
Dettagli del direttore cambiati per Mr Martin Peter Wheatley il 29 gen 2016 | 3 pagine | CH01 | ||||||||||
Conto per una società dormiente redatto al 31 dic 2014 | 6 pagine | AA | ||||||||||
Bilancio annuale redatto al 05 giu 2015 con elenco completo degli azionisti | 4 pagine | AR01 | ||||||||||
| ||||||||||||
Conto per una società dormiente redatto al 31 dic 2013 | 5 pagine | AA | ||||||||||
Chi sono gli amministratori di PENTA WATFORD LIMITED?
Nome | Nominato il | Dimissioni il | Ruolo | Indirizzo | Identificazione della società | Paese di residenza | Nazionalità | Data di nascita | Professione | Numero | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
INCHCAPE UK CORPORATE MANAGEMENT LIMITED | Segretario | Solihull Parkway Birmingham Business Park B37 7YN Birmingham First Floor, Unit 3140 Park Square United Kingdom |
| 100307260071 | ||||||||||
WHEATLEY, Martin Peter | Amministratore | Solihull Parkway Birmingham Business Park B37 7YN Birmingham First Floor Unit 3140 Park Square | England | British | Company Secretary | 55180460002 | ||||||||
GREEN, David Simon | Segretario | 14 Chudleigh Crescent IG3 9AS Ilford Essex | British | Office Manager | 36449310001 | |||||||||
JAMES, John William | Segretario | 15 Squirrel Rise Marlow Bottom SL7 3PN Marlow Buckinghamshire | British | 936210001 | ||||||||||
JEARY, Anton Clive | Segretario | Solihull Parkway Birmingham Business Park B37 7YN Birmingham First Floor Unit 3140 Park Square | British | 92285800001 | ||||||||||
LIGHT, John Michael Heathcote | Segretario | 138 Petersham Road TW10 6UX Richmond Surrey | British | Secretary | 2902370001 | |||||||||
DALE, Thomas Andrew | Amministratore | Solihull Parkway Birmingham Business Park B37 7YN Birmingham First Floor Unit 3140 Park Square | United Kingdom | British | Company Director | 260286850001 | ||||||||
GREEN, David Simon | Amministratore | 14 Chudleigh Crescent IG3 9AS Ilford Essex | United Kingdom | British | Office Manager | 36449310001 | ||||||||
HEATH, Reginald Frank | Amministratore | Linden Croft Linden Road St Georges Hill KT13 0QW Weybridge Surrey | United Kingdom | British | Company Director | 30254400001 | ||||||||
JAMES, John William | Amministratore | 15 Squirrel Rise Marlow Bottom SL7 3PN Marlow Buckinghamshire | United Kingdom | British | Company Director | 936210001 | ||||||||
JAMES, John William | Amministratore | 15 Squirrel Rise Marlow Bottom SL7 3PN Marlow Buckinghamshire | United Kingdom | British | Company Director | 936210001 | ||||||||
JEARY, Anton Clive | Amministratore | Solihull Parkway Birmingham Business Park B37 7YN Birmingham First Floor Unit 3140 Park Square | England | British | Accountant | 169892630001 | ||||||||
LIGHT, John Michael Heathcote | Amministratore | 138 Petersham Road TW10 6UX Richmond Surrey | British | Company Director | 2902370001 | |||||||||
LIGHT, John Michael Heathcote | Amministratore | 138 Petersham Road TW10 6UX Richmond Surrey | British | Company Director | 2902370001 | |||||||||
TAYLOR, Leslie Charles James | Amministratore | Woodcock Tower Road GU26 6SL Hindhead Surrey | British | Company Director | 2902380001 |
Chi sono le persone con controllo significativo di PENTA WATFORD LIMITED?
Nome | Notificato il | Indirizzo | Cessato | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Inchcape Motors International Limited | 06 apr 2016 | Solihull Parkway Birmingham Business Park B37 7YN Birmingham First Floor Unit 3140 Park Square United Kingdom | No | ||||||||||
| |||||||||||||
Natura del controllo
|
PENTA WATFORD LIMITED ha ipoteche?
Classificazione | Date | Stato | Dettagli | |
---|---|---|---|---|
Debenture | Creato il 01 feb 1989 Consegnato il 17 feb 1989 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Brevi particolari Including trade fixtures. Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
Legal charge | Creato il 16 mag 1986 Consegnato il 21 mag 1986 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito Sterling pounds 25,000 and all other moneys due or to become due from the company to the chargee under the terms of a hire purchase agreement. | |
Brevi particolari L/H land & buildings k/a plot 1D greenhill crescent hollywell industrial estate watford together with all fixtures & fittings and fixed plant or machinery and all improvements & additions. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
Mortgage debenture | Creato il 10 dic 1984 Consegnato il 10 dic 1984 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Brevi particolari L/H plot 1D greenhill crescent, holywell industrial estate, watford, hertfordshire, title no. Hd 63652, l/h 5/11 (odd) hempstead road, watford, hertfordshire together with all fixtures whatsoever now or at any time hereafter affixed or attached to the property or any part thereof other than trade machinery as defined by section 5 of the bills of sale act 1878. fixed charge over all buildings and erections thereon and all fixtures whatsoever now or at any time hereafter affixed or attached to the property or any part thereof other than trade machinery as defined by section 5 of the bills of sale act 1878. fixed & floating charge over undertaking and all property and assets present and future including goodwill uncalled capital. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
Letter of set off. | Creato il 07 dic 1984 Consegnato il 20 dic 1984 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Brevi particolari All monies from time to time held in the companys deposit account with lombard north central PLC and numbered 609622L or such ofter deposit account as may be opered during the currency or either of the facilities made avialable to the company under the terms of lombard north central plcs's letter of the 28 november 1984. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
|
Fonte dati
- Companies House del Regno Unito
Il registro ufficiale delle imprese nel Regno Unito, che fornisce l'accesso pubblico alle informazioni sulle imprese, come nomi, indirizzi, amministratori e depositi finanziari. - Licenza: CC0