WICKES DEVELOPMENTS LIMITED

WICKES DEVELOPMENTS LIMITED

  • Panoramica
  • Riepilogo
  • Scopo
  • Indirizzo
  • Denominazioni precedenti
  • Bilanci
  • Deposizioni
  • Amministratori
  • Persone con controllo significativo
  • Ipoteche
  • Insolvenza
  • Fonte dati
  • Panoramica

    Nome della societàWICKES DEVELOPMENTS LIMITED
    Stato della societàSciolta
    Forma giuridicaSocietà a responsabilità limitata
    Numero di società 01795477
    GiurisdizioneInghilterra/Galles
    Data di costituzione
    Data di cessazione

    Qual è lo scopo di WICKES DEVELOPMENTS LIMITED?

    • Sviluppo di progetti di costruzione (41100) / Costruzioni

    Dove si trova WICKES DEVELOPMENTS LIMITED?

    Indirizzo della sede legale
    C/O Mazars Llp 1st Floor
    Two Chamberlain Square
    B3 3AX Birmingham
    Indirizzo della sede legale non recapitabileNo

    Quali erano i nomi precedenti di WICKES DEVELOPMENTS LIMITED?

    Denominazioni sociali precedenti
    Nome della societàDaA
    HEWAPOINT LIMITED28 feb 198428 feb 1984

    Quali sono gli ultimi bilanci di WICKES DEVELOPMENTS LIMITED?

    Ultimi bilanci
    Ultimi bilanci redatti al27 dic 2020

    Quali sono le ultime deposizioni per WICKES DEVELOPMENTS LIMITED?

    Deposizioni
    DataDescrizioneDocumentoTipo

    Gazzetta ufficiale finale sciolta a seguito di liquidazione

    1 pagineGAZ2

    Ritorno della riunione finale in una liquidazione volontaria dei membri

    11 pagineLIQ13

    L'indirizzo di ispezione del registro è stato modificato a Lodge Way House Lodge Way Harlestone Road Northampton NN5 7UG

    2 pagineAD02

    Indirizzo della sede legale modificato da Lodge Way House Lodge Way Harlestone Road Northampton NN5 7UG a C/O Mazars Llp 1st Floor Two Chamberlain Square Birmingham B3 3AX in data 23 set 2022

    2 pagineAD01

    Nomina di un liquidatore volontario

    3 pagine600

    Risoluzioni

    Resolutions
    1 pagineRESOLUTIONS
    Risoluzioni
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    liquidation

    Risoluzione speciale per la liquidazione al 12 set 2022

    LRESSP

    Dichiarazione di solvibilità

    5 pagineLIQ01

    Notifica di Travis Perkins Financing Company No.3 Limited come persona con controllo significativo il 06 set 2022

    2 paginePSC02

    Cessazione di Wickes Properties Limited come persona con controllo significativo il 06 set 2022

    1 paginePSC07

    Nomina di Tp Directors Ltd come amministratore in data 27 giu 2022

    2 pagineAP02

    Bilancio redatto al 27 dic 2020

    19 pagineAA

    Dichiarazione di conformità presentata il 05 ott 2021 senza aggiornamenti

    3 pagineCS01

    Bilancio redatto al 28 dic 2019

    20 pagineAA

    Dichiarazione di conformità presentata il 01 ott 2020 senza aggiornamenti

    3 pagineCS01

    Bilancio redatto al 29 dic 2018

    20 pagineAA

    Dichiarazione di conformità presentata il 01 ott 2019 senza aggiornamenti

    3 pagineCS01

    Cessazione della carica di John Peter Carter come amministratore in data 01 mag 2019

    1 pagineTM01

    Dichiarazione di conformità presentata il 01 ott 2018 senza aggiornamenti

    3 pagineCS01

    Bilancio redatto al 30 dic 2017

    19 pagineAA

    Dichiarazione di conformità presentata il 01 ott 2017 con aggiornamenti

    4 pagineCS01

    Bilancio redatto al 31 dic 2016

    18 pagineAA

    Cessazione della carica di Anthony David Buffin come amministratore in data 11 lug 2017

    1 pagineTM01

    Nomina di Mr Alan Richard Williams come amministratore in data 11 lug 2017

    2 pagineAP01

    Dichiarazione di conformità presentata il 18 ott 2016 con aggiornamenti

    5 pagineCS01

    Bilancio redatto al 26 dic 2015

    18 pagineAA

    Chi sono gli amministratori di WICKES DEVELOPMENTS LIMITED?

    Amministratori
    NomeNominato ilDimissioni ilRuoloIndirizzoIdentificazione della societàPaese di residenzaNazionalitàData di nascitaProfessioneNumero
    TPG MANAGEMENT SERVICES LIMITED
    Lodge Way
    Harlestone Road
    NN5 7UG Northampton
    Lodge Way House
    England
    England
    Segretario
    Lodge Way
    Harlestone Road
    NN5 7UG Northampton
    Lodge Way House
    England
    England
    Tipo di documento di identificazioneSocietà a responsabilità limitata del Regno Unito
    Numero di registrazione8929285
    186000060001
    WILLIAMS, Alan Richard
    Lodge Way
    Harlestone Road
    NN5 7UG Northampton
    Lodge Way House
    United Kingdom
    Amministratore
    Lodge Way
    Harlestone Road
    NN5 7UG Northampton
    Lodge Way House
    United Kingdom
    United KingdomBritish137582690004
    TP DIRECTORS LTD
    Lodge Way
    Harlestone Road
    NN5 7UG Northampton
    Lodge Way House
    United Kingdom
    Amministratore
    Lodge Way
    Harlestone Road
    NN5 7UG Northampton
    Lodge Way House
    United Kingdom
    Tipo di documento di identificazioneSocietà a responsabilità limitata del Regno Unito
    Numero di registrazione03480295
    191205550001
    PIKE, Andrew Stephen
    Lodge Way House
    Lodge Way, Harlestone Road
    NN5 7UG Northampton
    Travis Perkins Plc
    Northamptonshire
    Segretario
    Lodge Way House
    Lodge Way, Harlestone Road
    NN5 7UG Northampton
    Travis Perkins Plc
    Northamptonshire
    British65678800002
    RIMMER, Barbara
    28 Chapel Lane
    Hale Barns
    WA15 0HN Altrincham
    Cheshire
    Segretario
    28 Chapel Lane
    Hale Barns
    WA15 0HN Altrincham
    Cheshire
    British76973560002
    STOKES-SMITH, Keith Reginald
    5a The Broadway
    Penn Road
    HP9 2PD Beaconsfield
    Buckinghamshire
    Segretario
    5a The Broadway
    Penn Road
    HP9 2PD Beaconsfield
    Buckinghamshire
    British75650590001
    ARCHER, William Ernest
    The Priory
    2 Astley Close
    WA16 8GJ Knutsford
    Cheshire
    Amministratore
    The Priory
    2 Astley Close
    WA16 8GJ Knutsford
    Cheshire
    British15170380004
    BAMFORD, Carmel
    36 Enmore Gardens
    East Sheen
    SW14 8RF London
    Amministratore
    36 Enmore Gardens
    East Sheen
    SW14 8RF London
    British17771540001
    BHOTE, Sanaya Homi
    50 Bonnersfield Lane
    HA1 2LE Harrow
    Middlesex
    Amministratore
    50 Bonnersfield Lane
    HA1 2LE Harrow
    Middlesex
    British72716110002
    BIRD, Jeremy
    Lodge Way House
    Lodge Way, Harlestone Road
    NN5 7UG Northampton
    Amministratore
    Lodge Way House
    Lodge Way, Harlestone Road
    NN5 7UG Northampton
    United KingdomBritish111434190001
    BIRD, Richard Sidney
    Lodge Way House
    Lodge Way, Harlestone Road
    NN5 7UG Northampton
    Amministratore
    Lodge Way House
    Lodge Way, Harlestone Road
    NN5 7UG Northampton
    British111500210001
    BUFFIN, Anthony David
    Lodge Way House
    Lodge Way
    NN5 7UG Harlestone Road
    Northampton
    Amministratore
    Lodge Way House
    Lodge Way
    NN5 7UG Harlestone Road
    Northampton
    EnglandBritish178011680002
    CARTER, John Peter
    Lodge Way House
    Lodge Way, Harlestone Road
    NN5 7UG Northampton
    Amministratore
    Lodge Way House
    Lodge Way, Harlestone Road
    NN5 7UG Northampton
    United KingdomBritish46226920007
    COOPER, Geoffrey Ian
    Travis Perkins Plc, Lodge Way House
    Lodge Way, Harlestone Road
    NN5 7UG Northampton
    Northamptonshire
    Amministratore
    Travis Perkins Plc, Lodge Way House
    Lodge Way, Harlestone Road
    NN5 7UG Northampton
    Northamptonshire
    United KingdomBritish104472550001
    CORNER, Michael Richmond
    95 Castelnau
    Barnes
    SW13 London
    Amministratore
    95 Castelnau
    Barnes
    SW13 London
    British21206150001
    EDWARDS, Fred
    2 Moreland Drive
    SL9 8BB Gerrards Cross
    Buckinghamshire
    Amministratore
    2 Moreland Drive
    SL9 8BB Gerrards Cross
    Buckinghamshire
    British75885570002
    FRIEDMAN, Douglas Benjamin
    46 Lankaster Gardens
    N2 9AJ London
    Amministratore
    46 Lankaster Gardens
    N2 9AJ London
    American15200060001
    HAMPDEN SMITH, Paul Nigel
    Travis Perkins Plc, Lodge Way House
    Lodge Way, Harlestone Road
    NN5 7UG Northampton
    Northamptonshire
    Amministratore
    Travis Perkins Plc, Lodge Way House
    Lodge Way, Harlestone Road
    NN5 7UG Northampton
    Northamptonshire
    United KingdomBritish72135950007
    HOSKINS, William John
    3 Homewood Road
    AL1 4BE St. Albans
    Hertfordshire
    Amministratore
    3 Homewood Road
    AL1 4BE St. Albans
    Hertfordshire
    British49295070002
    JONES, Paul Samuel
    Brooklyn Newell Green
    Warfield
    RG42 6AJ Bracknell
    Berkshire
    Amministratore
    Brooklyn Newell Green
    Warfield
    RG42 6AJ Bracknell
    Berkshire
    British75187050001
    PENNY, Michael William Harrison
    Windrush
    9 Downsway
    GU1 2YA Guildford
    Surrey
    Amministratore
    Windrush
    9 Downsway
    GU1 2YA Guildford
    Surrey
    United KingdomBritish144262470001
    RICE, John Michael
    Wayside Cottage
    Street Lane Rodeheath
    ST7 3SN Cheshire
    Amministratore
    Wayside Cottage
    Street Lane Rodeheath
    ST7 3SN Cheshire
    British72718070001
    STOKES-SMITH, Keith Reginald
    5a The Broadway
    Penn Road
    HP9 2PD Beaconsfield
    Buckinghamshire
    Amministratore
    5a The Broadway
    Penn Road
    HP9 2PD Beaconsfield
    Buckinghamshire
    British75650590001
    THACKER, Colin David
    Old Place Farm
    Birling Road Ryarsh
    ME19 5JS West Malling
    Kent
    Amministratore
    Old Place Farm
    Birling Road Ryarsh
    ME19 5JS West Malling
    Kent
    United KingdomBritish39672600001
    THOMAS, Geoffrey John
    8 Stanbrooke Way Church Lane
    Yielden
    MK44 1AU Bedford
    North Bedfordshire
    Amministratore
    8 Stanbrooke Way Church Lane
    Yielden
    MK44 1AU Bedford
    North Bedfordshire
    British42980950001
    WILSON, Geoffrey Charles
    Broadoaks
    237 Seabridge Lane
    ST5 3TB Newcastle Under Lyme
    Staffordshire
    Amministratore
    Broadoaks
    237 Seabridge Lane
    ST5 3TB Newcastle Under Lyme
    Staffordshire
    British72996700001

    Chi sono le persone con controllo significativo di WICKES DEVELOPMENTS LIMITED?

    Persone con controllo significativo
    NomeNotificato ilIndirizzoCessato
    Lodge Way
    Harlestone Road
    NN5 7UG Northampton
    Lodge Way House
    United Kingdom
    06 set 2022
    Lodge Way
    Harlestone Road
    NN5 7UG Northampton
    Lodge Way House
    United Kingdom
    No
    Forma giuridicaLimited By Shares
    Paese di registrazioneEngland And Wales
    Autorità legaleUnited Kingdom (England And Wales)
    Luogo di registrazioneCompanies House
    Numero di registrazione07180292
    Natura del controllo
    • La persona possiede, direttamente o indirettamente, più del 75% delle azioni della società.
    • La persona detiene, direttamente o indirettamente, più del 75% dei diritti di voto nella società.
    • La persona ha il diritto, direttamente o indirettamente, di nominare o rimuovere la maggioranza del consiglio di amministrazione della società.
    Wickes Properties Limited
    Lodge Way
    Harlestone Road
    NN5 7UG Northampton
    Lodge Way House
    England
    06 apr 2016
    Lodge Way
    Harlestone Road
    NN5 7UG Northampton
    Lodge Way House
    England
    Forma giuridicaLimited Company
    Paese di registrazioneUk
    Autorità legaleCompanies Act 2006
    Luogo di registrazioneEngland And Wales
    Numero di registrazione1406897
    Natura del controllo
    • La persona possiede, direttamente o indirettamente, più del 75% delle azioni della società.
    • La persona detiene, direttamente o indirettamente, più del 75% dei diritti di voto nella società.
    • La persona ha il diritto, direttamente o indirettamente, di nominare o rimuovere la maggioranza del consiglio di amministrazione della società.

    WICKES DEVELOPMENTS LIMITED ha ipoteche?

    Ipoteche
    ClassificazioneDateStatoDettagli
    A mezzanine debenture
    Creato il 28 lug 2003
    Consegnato il 13 ago 2003
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the issuer and each of the other guarantors to the secured parties (or any of them) under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Ing Bank N.V. , London Branch, (As Security Trustee for Itself and the Other Secured Parties)
    Transazioni
    • 13 ago 2003Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 31 mar 2005Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Senior security accession deed
    Creato il 29 gen 2003
    Consegnato il 13 feb 2003
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All money and liabilities due or to become due from each charging company and each of the other obligors to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    Retained land at high rd,goodmayes,redbridge known as 1-4 railway cottages and land/blds on south-east side of high rd,chadwell heath. Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Ing Bank N.V.London Branch,as Security Trustee for Itself and the Other Secured Parties
    Transazioni
    • 13 feb 2003Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 31 mar 2005Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Subordinated security accession deed
    Creato il 29 gen 2003
    Consegnato il 13 feb 2003
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All money and liabilities due or to become due from each charging company and each of the other obligors to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    Land t high rd,goodmayes,redbridge known as 1-4 railway cottages and land and buildings on the south-east side of high road,chadwell heath. Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Ing Bank N.V.London Branch,as Security Trustee for Itself and the Other Secured Parties
    Transazioni
    • 13 feb 2003Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 05 ago 2003Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Security accession deed between the company, focus do it all limited (the "parent") and ing bank N.V., london branch (the "security agent") supplemental to a debenture entered into pursuant to the subordinated loan agreement dated 29.12.00 between inter alia, the parent and the security agent
    Creato il 16 gen 2001
    Consegnato il 31 gen 2001
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All money and liabilities now or hereafter due, owing or incurred to the secured parties (or any of them) by each charging company and each of the other obligors under the finance documents (or any of them) in whatsoever manner together with all interest accruing thereon and all costs, charges and expenses incurred by any of the secured parties
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Ing Bank N.V,London Branch
    Transazioni
    • 31 gen 2001Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 27 giu 2002Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Debenture
    Creato il 29 dic 2000
    Consegnato il 09 gen 2001
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All money and liabilities due or to become due from each charging company (as defined) and each of the other obligors under the finance documents (as defined),to the secured parties (or any of them) on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Persone aventi diritto
    • Ing Bank N.V. London Branch (As Security Agent)
    Transazioni
    • 09 gen 2001Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 05 feb 2003Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Security accession deed being supplemental to a debenture dated 26 september 2000 (as defined)
    Creato il 27 ott 2000
    Consegnato il 06 nov 2000
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All money and liabilities due or to become due from each charging company (as defined) and each of the other obligors to the secured parties (as defined) under the finance documents (as defined) in any manner whatsoever and in any currency or currencies
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Ing Bank N.V.,London Branch,as Security Agent
    Transazioni
    • 06 nov 2000Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 20 feb 2001Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Legal charge supplemental to a guarantee and debenture dated 3RD july 1996, a guarantee and debenture dated 12TH december 1996 and a guarantee and debenture dated 7TH january 1997 issued by the company
    Creato il 21 ago 1997
    Consegnato il 03 set 1997
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of this legal charge
    Brevi particolari
    F/H 1 to 4 railway cottages and land and buildings on the south east side of high road goodmayes ilford. T/n-NGL76432.
    Persone aventi diritto
    • Barclays Bank PLC
    Transazioni
    • 03 set 1997Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 11 nov 1998Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Guarantee and debenture
    Creato il 07 gen 1997
    Consegnato il 15 gen 1997
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies and liabilities due owing or incurred in any manner by each charging company to the chargee (as security trustee for and on behalf of the banks) in accordance with any applicable facilities agreement
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Barclays Bank PLC
    Transazioni
    • 15 gen 1997Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 30 set 1998Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Limited recourse guarantee and debenture
    Creato il 12 dic 1996
    Consegnato il 20 dic 1996
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company and all or any of the other companies named therein to the chargee as agent and trustee for the banks (as defined) under the facilities agreement (as defined)
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Barclays Bank PLC
    Transazioni
    • 20 dic 1996Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 30 set 1998Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Guarantee and debenture
    Creato il 03 lug 1996
    Consegnato il 10 lug 1996
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All the new money liabilities (as defined therein) outstanding, due or owing or incurred by the charging companies (as defined therein) to the chargee
    Brevi particolari
    .. fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Barclays Bank PLC
    Transazioni
    • 10 lug 1996Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 05 dic 1997Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Legal charge
    Creato il 07 set 1993
    Consegnato il 10 set 1993
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    The deposit and interim payment (as the same are defined in an agreement for the sale and purchase of the property dated 7/9/93 "the contract") due from the company to the chargee under the terms of the said contract
    Brevi particolari
    The l/h land at marsh barton road exeter more particularly describes in an agreement dated 7/9/93.
    Persone aventi diritto
    • Wgtc Nominees Limited
    Transazioni
    • 10 set 1993Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 30 mar 1994Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Legal charge
    Creato il 26 feb 1993
    Consegnato il 06 mar 1993
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    £1,350,000 due from the company to the chargee under the terms of this charge
    Brevi particolari
    F/H land and buildings to the south of cuton hall alne springfield chelmsford currently forming part of t/n ex 469422.
    Persone aventi diritto
    • Wgtc Nominees Limited
    Transazioni
    • 06 mar 1993Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 24 ago 1993Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)

    WICKES DEVELOPMENTS LIMITED ha procedimenti di insolvenza?

    Numero di praticaDateTipoProfessionistiAltro
    1
    DataTipo
    12 set 2022Inizio della liquidazione
    23 dic 2023Data di scioglimento
    Liquidazione volontaria dei soci
    NomeRuoloIndirizzoNominato ilCessato il
    Simon David Chandler
    1st Floor Two Chamberlain Square
    B3 3AX Birmingham
    Praticante
    1st Floor Two Chamberlain Square
    B3 3AX Birmingham
    Scott Christian Bevan
    Mazars Llp First Floor, Two Chamberlain Square
    B3 3AX Birmingham
    Praticante
    Mazars Llp First Floor, Two Chamberlain Square
    B3 3AX Birmingham

    Fonte dati

    • Companies House del Regno Unito
      Il registro ufficiale delle imprese nel Regno Unito, che fornisce l'accesso pubblico alle informazioni sulle imprese, come nomi, indirizzi, amministratori e depositi finanziari.
    • Licenza: CC0