IVORY BEVERAGES LIMITED

IVORY BEVERAGES LIMITED

  • Panoramica
  • Riepilogo
  • Scopo
  • Indirizzo
  • Denominazioni precedenti
  • Bilanci
  • Deposizioni
  • Amministratori
  • Ipoteche
  • Fonte dati
  • Panoramica

    Nome della societàIVORY BEVERAGES LIMITED
    Stato della societàSciolta
    Forma giuridicaSocietà a responsabilità limitata
    Numero di società 01796736
    GiurisdizioneInghilterra/Galles
    Data di costituzione
    Data di cessazione

    Qual è lo scopo di IVORY BEVERAGES LIMITED?

    • (7499) /

    Dove si trova IVORY BEVERAGES LIMITED?

    Indirizzo della sede legale
    East Wing 14th Floor
    389 Chiswick High Road
    W4 4AJ Chiswick
    London
    Indirizzo della sede legale non recapitabileNo

    Quali erano i nomi precedenti di IVORY BEVERAGES LIMITED?

    Denominazioni sociali precedenti
    Nome della societàDaA
    COFFEE MAC LIMITED02 mar 198402 mar 1984

    Quali sono gli ultimi bilanci di IVORY BEVERAGES LIMITED?

    Ultimi bilanci
    Ultimi bilanci redatti al30 mar 2008

    Quali sono le ultime deposizioni per IVORY BEVERAGES LIMITED?

    Deposizioni
    DataDescrizioneDocumentoTipo

    Gazzetta Ufficiale finale sciolta per scioglimento volontario

    1 pagineGAZ2(A)

    Prima Gazzetta Ufficiale per lo scioglimento volontario

    1 pagineGAZ1(A)

    Richiesta di cancellazione della società dal registro

    3 pagineDS01

    Stato del capitale al 15 apr 2010

    • Capitale: GBP 1
    4 pagineSH19

    legacy

    1 pagineSH20

    legacy

    1 pagineCAP-SS

    Risoluzioni

    Resolutions
    3 pagineRESOLUTIONS
    Risoluzioni
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    capital

    Risoluzioni

    Transactions authorised 09/04/2010
    RES13

    Risoluzioni

    Resolutions
    2 pagineRESOLUTIONS
    Risoluzioni
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    incorporation

    Risoluzione di modifica del Memorandum e/o degli Articoli di Associazione

    RES01
    capital

    Risoluzione di riduzione del capitale sociale emesso

    RES06

    Bilancio annuale redatto al 15 nov 2009 con elenco completo degli azionisti

    5 pagineAR01

    Dettagli del direttore cambiati per Mr Timothy Michael Roe il 11 dic 2009

    2 pagineCH01

    Dettagli del direttore cambiati per Mr Andrew Wyatt Bristow Aca Bsc(Hons) il 11 dic 2009

    2 pagineCH01

    Bilancio redatto al 30 mar 2008

    14 pagineAA

    legacy

    3 pagine363a

    legacy

    1 pagine288c

    legacy

    1 pagine288c

    legacy

    1 pagine288b

    legacy

    1 pagine288b

    legacy

    8 pagine363s

    Bilancio redatto al 01 apr 2007

    14 pagineAA

    Bilancio redatto al 02 apr 2006

    18 pagineAA

    Bilancio redatto al 30 set 2005

    21 pagineAA

    legacy

    8 pagine363s

    legacy

    1 pagine287

    legacy

    1 pagine288b

    legacy

    1 pagine288a

    Chi sono gli amministratori di IVORY BEVERAGES LIMITED?

    Amministratori
    NomeNominato ilDimissioni ilRuoloIndirizzoIdentificazione della societàPaese di residenzaNazionalitàData di nascitaProfessioneNumero
    GREENWOOD, Michael Frank
    Gloucester Road
    Kew
    TW9 3BT Richmond
    51
    Surrey
    Segretario
    Gloucester Road
    Kew
    TW9 3BT Richmond
    51
    Surrey
    British90910000002
    BRISTOW, Andrew Wyatt
    Garden Road
    BR1 3LX Bromley
    22
    Kent
    Amministratore
    Garden Road
    BR1 3LX Bromley
    22
    Kent
    EnglandBritish8748280008
    ROE, Timothy Michael
    Kenley Road
    SW19 3JQ London
    2a
    Amministratore
    Kenley Road
    SW19 3JQ London
    2a
    EnglandBritish51264250001
    ATKINSON, Richard
    5 Lukins Drive
    CM6 1XQ Dunmow
    Essex
    Segretario
    5 Lukins Drive
    CM6 1XQ Dunmow
    Essex
    British60376890001
    HALEY, Paul Stewart
    3 Providential Street
    Flockton
    WF4 4DJ Wakefield
    West Yorkshire
    Segretario
    3 Providential Street
    Flockton
    WF4 4DJ Wakefield
    West Yorkshire
    British101774450001
    LEMPRIERE, Paul John
    20 Bishop Burton Road
    Cherry Burton
    HU17 7RW Beverley
    E Yorkshire
    Segretario
    20 Bishop Burton Road
    Cherry Burton
    HU17 7RW Beverley
    E Yorkshire
    British7658350001
    MCKAY, William Trevor
    1 West Court
    HA0 3QQ North Wembley
    Middlesex
    Segretario
    1 West Court
    HA0 3QQ North Wembley
    Middlesex
    British588890001
    ALLAWAY, Michael John
    Grove Cottage
    Blounts Court Road
    RG9 5EU Peppard
    Henley On Thames
    Amministratore
    Grove Cottage
    Blounts Court Road
    RG9 5EU Peppard
    Henley On Thames
    United KingdomBritish37618690001
    ATKINSON, Richard
    5 Lukins Drive
    CM6 1XQ Dunmow
    Essex
    Amministratore
    5 Lukins Drive
    CM6 1XQ Dunmow
    Essex
    British60376890001
    BLAKE, Frank George Bennett
    117 Pannal Ash Road
    HG2 9JL Harrogate
    North Yorkshire
    Amministratore
    117 Pannal Ash Road
    HG2 9JL Harrogate
    North Yorkshire
    EnglandBritish3779990001
    CHRISTOPHER, John Martin
    24 Bridge Court
    Morley
    LS27 0BD Leeds
    West Yorkshire
    Amministratore
    24 Bridge Court
    Morley
    LS27 0BD Leeds
    West Yorkshire
    British18639650001
    DRAUDE, Barry
    20 Chestnut Green
    Monk Fryston
    LS25 5PN Leeds
    West Yorkshire
    Amministratore
    20 Chestnut Green
    Monk Fryston
    LS25 5PN Leeds
    West Yorkshire
    United KingdomBritish112174490001
    DUNNE, Jeremy Robert
    16 Greenhill Road
    Armley
    LS12 3QA Leeds
    West Yorkshire
    Amministratore
    16 Greenhill Road
    Armley
    LS12 3QA Leeds
    West Yorkshire
    United KingdomBritish84111110001
    FIRTH, Michael Roger
    Stamford House
    The Green, Green Hammerton
    YO26 8BQ York
    North Yorkshire
    Amministratore
    Stamford House
    The Green, Green Hammerton
    YO26 8BQ York
    North Yorkshire
    British62298980001
    GIDDINGS, Allan
    Rock House Back Lane
    Sicklinghall
    LS22 4BQ Wetherby
    West Yorkshire
    Amministratore
    Rock House Back Lane
    Sicklinghall
    LS22 4BQ Wetherby
    West Yorkshire
    British2164900001
    HALEY, Paul Stewart
    3 Providential Street
    Flockton
    WF4 4DJ Wakefield
    West Yorkshire
    Amministratore
    3 Providential Street
    Flockton
    WF4 4DJ Wakefield
    West Yorkshire
    British101774450001
    IVORY, Christopher Richard
    The Old Mill
    Kirkbridge Crakehall
    DL8 1PN Bedale
    North Yorkshire
    Amministratore
    The Old Mill
    Kirkbridge Crakehall
    DL8 1PN Bedale
    North Yorkshire
    British12090570001
    LEMPRIERE, Paul John
    20 Bishop Burton Road
    Cherry Burton
    HU17 7RW Beverley
    E Yorkshire
    Amministratore
    20 Bishop Burton Road
    Cherry Burton
    HU17 7RW Beverley
    E Yorkshire
    EnglandBritish7658350001
    LUCK, Gary Darren Michael
    73 De Vigier Avenue
    CB10 2AY Saffron Walden
    Essex
    Amministratore
    73 De Vigier Avenue
    CB10 2AY Saffron Walden
    Essex
    United KingdomBritish92311040001
    MACLACHLAN, Ronald Alan
    Oakcroft 30 The Orchards
    BD16 4AZ Bingley
    West Yorkshire
    Amministratore
    Oakcroft 30 The Orchards
    BD16 4AZ Bingley
    West Yorkshire
    British18639640001
    MILLER, Billy David
    96 Green Park Road
    HX3 0SW Halifax
    West Yorkshire
    Amministratore
    96 Green Park Road
    HX3 0SW Halifax
    West Yorkshire
    British79550070001
    MORGAN, David Edward
    40 Singingwood Lane
    CA 94563 Orinda
    California
    Usa
    Amministratore
    40 Singingwood Lane
    CA 94563 Orinda
    California
    Usa
    British60419650002
    MURRAY, Steven John
    9 Whiteoak Gardens The Hollies
    DA15 8WE Sidcup
    Kent
    Amministratore
    9 Whiteoak Gardens The Hollies
    DA15 8WE Sidcup
    Kent
    United KingdomBritish21176500001
    WILFORD, Roy
    Hindlea
    Trigfa Estate
    LL72 8LL Moelfre
    Anglesey
    Amministratore
    Hindlea
    Trigfa Estate
    LL72 8LL Moelfre
    Anglesey
    British76263740001

    IVORY BEVERAGES LIMITED ha ipoteche?

    Ipoteche
    ClassificazioneDateStatoDettagli
    Debenture
    Creato il 24 dic 2001
    Consegnato il 03 gen 2002
    In corso
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Persone aventi diritto
    • Venture Finance PLC
    Transazioni
    • 03 gen 2002Registrazione di un'ipoteca (395)
    Chattel mortgage
    Creato il 08 ago 2000
    Consegnato il 10 ago 2000
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Various chattels the insurance policies in relation thereto and all the right title and interest in and to the benefit of all present and future contracts and agreements relating to the chattels. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Barclays Bank PLC
    Transazioni
    • 10 ago 2000Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 16 gen 2002Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Guarantee & debenture
    Creato il 23 mar 1998
    Consegnato il 30 mar 1998
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company and/or all or any of the other companies named therein to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Persone aventi diritto
    • Barclays Bank PLC
    Transazioni
    • 30 mar 1998Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 16 gen 2002Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Guarantee and debenture
    Creato il 11 mar 1997
    Consegnato il 21 mar 1997
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee and all monies due or to become due from northallerton wholesale foods limited and/or land food products limited formerly known as flipchoice limited (the "group companies") except any monies due by the group companies as guarantor for the company
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Barclays Bank PLC
    Transazioni
    • 21 mar 1997Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 16 gen 2002Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Debenture
    Creato il 11 mar 1997
    Consegnato il 19 mar 1997
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • 3I PLC
    Transazioni
    • 19 mar 1997Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 16 gen 2002Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Guarantee and debenture
    Creato il 03 feb 1997
    Consegnato il 13 feb 1997
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies and liabilities due or to become due from the company and northallerton wholesale foods limited (the "group company") to the chargee,except any monies or liabilities due owing or incurred by the group company as guarantor for the company
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Barclays Bank PLC
    Transazioni
    • 13 feb 1997Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 16 gen 2002Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Supplemental debenture
    Creato il 09 dic 1996
    Consegnato il 24 dic 1996
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All obligations and liabilities (whether actual or contingent and whether owed jointly or severally or in any other capacity whatsoever) of each relevant obligor (as defined therein) to the institutions (as defined therein) (or any of them) under each of the financing documents to which that relevant obligor is a party
    Brevi particolari
    L/H property k/a the warehouse and land on the east side of ripley drive normanton t/n WYK555975 k/a carter mills 146 cleckheaton rd bradford units 5 & 6 normanton industrial estate normanton west yorkshire t/no's;- wyk 527220 & WYK531219 l/h property k/a unit 4 westwoods alphin brook road marsh barton exeter unit 29 earith business park fen drove earith huntingdon cambridgeshire. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • National Westminster Bank PLC
    Transazioni
    • 24 dic 1996Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 02 gen 2002Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Guarantee and debenture
    Creato il 03 ott 1996
    Consegnato il 10 ott 1996
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All obligations and liabilities (whether actual or contingient whether owed jointly or severally or in any other capacity whatsoever) of each relevant obligor to the chargee as agent and trustee for itself and for each institution (or any of them) as defined therein under each of the financing documents to which that relevant obligor is a party.
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • National Westminster Bank PLC
    Transazioni
    • 10 ott 1996Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 18 feb 1997Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Mortgage debenture
    Creato il 17 mag 1991
    Acquisito il 18 ott 1991
    Consegnato il 29 gen 1992
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies
    Brevi particolari
    A specific equitable charge over all freehold and leasehold properties and/or the proceeds of sale thereof fixed and floating charges over undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts and the benefits of any licences.
    Persone aventi diritto
    • National Westminster Bank PLC
    Transazioni
    • 29 gen 1992Registrazione di un'acquisizione (400)
    • 24 giu 1994Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Debenture
    Creato il 24 ott 1989
    Consegnato il 30 ott 1989
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    A specific equitable charge over all freehold and leasehold properties and/or the proceeds of sale thereof fixed and floating charges over undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts and the benefits of any licences.
    Persone aventi diritto
    • National Westminster Bank PLC
    Transazioni
    • 30 ott 1989Registrazione di un'ipoteca
    • 24 giu 1994Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Guarantee & debenture
    Creato il 14 giu 1989
    Consegnato il 21 giu 1989
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company and/or all or any of the other companies named therein to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Persone aventi diritto
    • Barclays Bank PLC
    Transazioni
    • 21 giu 1989Registrazione di un'ipoteca

    Fonte dati

    • Companies House del Regno Unito
      Il registro ufficiale delle imprese nel Regno Unito, che fornisce l'accesso pubblico alle informazioni sulle imprese, come nomi, indirizzi, amministratori e depositi finanziari.
    • Licenza: CC0