BANKING TECHNOLOGY LIMITED

BANKING TECHNOLOGY LIMITED

  • Panoramica
  • Riepilogo
  • Scopo
  • Indirizzo
  • Denominazioni precedenti
  • Bilanci
  • Deposizioni
  • Amministratori
  • Ipoteche
  • Fonte dati
  • Panoramica

    Nome della societàBANKING TECHNOLOGY LIMITED
    Stato della societàSciolta
    Forma giuridicaSocietà a responsabilità limitata
    Numero di società 01797903
    GiurisdizioneInghilterra/Galles
    Data di costituzione
    Data di cessazione

    Qual è lo scopo di BANKING TECHNOLOGY LIMITED?

    • (7499) /

    Dove si trova BANKING TECHNOLOGY LIMITED?

    Indirizzo della sede legale
    Mortimer House
    37-41 Mortimer Street
    W1T 3JH London
    Indirizzo della sede legale non recapitabileNo

    Quali erano i nomi precedenti di BANKING TECHNOLOGY LIMITED?

    Denominazioni sociali precedenti
    Nome della societàDaA
    PRESSAGE LIMITED07 mar 198407 mar 1984

    Quali sono gli ultimi bilanci di BANKING TECHNOLOGY LIMITED?

    Ultimi bilanci
    Ultimi bilanci redatti al31 dic 2009

    Quali sono le ultime deposizioni per BANKING TECHNOLOGY LIMITED?

    Deposizioni
    DataDescrizioneDocumentoTipo

    Gazzetta Ufficiale finale sciolta per scioglimento volontario

    1 pagineGAZ2(A)

    Prima Gazzetta Ufficiale per lo scioglimento volontario

    1 pagineGAZ1(A)

    Richiesta di cancellazione della società dal registro

    3 pagineDS01

    Nomina di Miss Rachel Elizabeth Jacobs come amministratore

    2 pagineAP01

    Dettagli del direttore cambiati per Mr Adam Christopher Walker il 05 ott 2010

    2 pagineCH01

    Dettagli del direttore cambiati per Mr Peter Stephen Rigby il 05 ott 2010

    2 pagineCH01

    Dettagli del segretario cambiati per Miss Julie Louise Wilson il 27 set 2010

    1 pagineCH03

    Conto per una società dormiente redatto al 31 dic 2009

    8 pagineAA

    Dettagli del direttore cambiati per John William Burton il 11 ago 2010

    2 pagineCH01

    Bilancio annuale redatto al 01 giu 2010 con elenco completo degli azionisti

    6 pagineAR01
    Deposizioni associate
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    capital01 lug 2010

    Stato del capitale al 01 lug 2010

    • Capitale: GBP 100
    SH01

    Nomina di Gareth Richard Wright come amministratore

    2 pagineAP01

    Dettagli del segretario cambiati per Miss Julie Louise Wilson il 02 dic 2009

    1 pagineCH03

    Dettagli del direttore cambiati per Mark Henry Kerswell il 02 dic 2009

    2 pagineCH01

    Dettagli del direttore cambiati per Peter Stephen Rigby il 01 dic 2009

    2 pagineCH01

    Dettagli del direttore cambiati per Adam Christopher Walker il 27 nov 2009

    2 pagineCH01

    Bilancio redatto al 31 dic 2008

    5 pagineAA

    legacy

    2 pagine288a

    legacy

    4 pagine363a

    legacy

    1 pagine288c

    Bilancio redatto al 31 dic 2007

    5 pagineAA

    legacy

    4 pagine363a

    legacy

    1 pagine288c

    legacy

    1 pagine288a

    legacy

    1 pagine288b

    legacy

    1 pagine288a

    Chi sono gli amministratori di BANKING TECHNOLOGY LIMITED?

    Amministratori
    NomeNominato ilDimissioni ilRuoloIndirizzoIdentificazione della societàPaese di residenzaNazionalitàData di nascitaProfessioneNumero
    WOOLLARD, Julie Louise
    37/41 Mortimer Street
    W1T 3JH London
    Mortimer House
    England
    Segretario
    37/41 Mortimer Street
    W1T 3JH London
    Mortimer House
    England
    British139159370002
    BURTON, John William
    Mortimer House
    37-41 Mortimer Street
    W1T 3JH London
    Amministratore
    Mortimer House
    37-41 Mortimer Street
    W1T 3JH London
    United KingdomBritish113684810001
    JACOBS, Rachel Elizabeth
    37/41 Mortimer Street
    W1T 3JH London
    Mortimer House
    England
    Amministratore
    37/41 Mortimer Street
    W1T 3JH London
    Mortimer House
    England
    United KingdomBritish92334500004
    KERSWELL, Mark Henry
    37/41 Mortimer Street
    W1T 3JH London
    Mortimer House
    England
    Amministratore
    37/41 Mortimer Street
    W1T 3JH London
    Mortimer House
    England
    EnglandBritish82609620003
    RIGBY, Peter Stephen
    37/41 Mortimer Street
    W1T 3JH London
    Mortimer House
    England
    Amministratore
    37/41 Mortimer Street
    W1T 3JH London
    Mortimer House
    England
    SwitzerlandBritish69164290007
    WALKER, Adam Christopher
    37/41 Mortimer Street
    W1T 3JH London
    Mortimer House
    England
    Amministratore
    37/41 Mortimer Street
    W1T 3JH London
    Mortimer House
    England
    SwitzerlandBritish129368430002
    WRIGHT, Gareth Richard
    37/41 Mortimer Street
    W1T 3JH London
    Mortimer House
    England
    Amministratore
    37/41 Mortimer Street
    W1T 3JH London
    Mortimer House
    England
    United KingdomBritish131115190001
    CALLABY, Andrea Mary
    5 Thornton Drive
    CO4 5WB Colchester
    Essex
    Segretario
    5 Thornton Drive
    CO4 5WB Colchester
    Essex
    British70352690002
    HAYWARD, Pearl Catherine
    60 Idmiston Square
    KT4 7SY Worcester Park
    Surrey
    Segretario
    60 Idmiston Square
    KT4 7SY Worcester Park
    Surrey
    British61319730001
    LODGE, David William
    19 Windermere Drive
    CM7 8UB Braintree
    Essex
    Segretario
    19 Windermere Drive
    CM7 8UB Braintree
    Essex
    British10640040001
    PEACH, Inez Mary
    Silverwood Station Road
    Semley
    SP7 9AH Shaftesbury
    Dorset
    Segretario
    Silverwood Station Road
    Semley
    SP7 9AH Shaftesbury
    Dorset
    British9976010001
    RICHMOND, Sonia Anna
    8 Viscount Gardens
    KT14 6HE Byfleet
    Surrey
    Segretario
    8 Viscount Gardens
    KT14 6HE Byfleet
    Surrey
    British118535490002
    WHITE, Teresa Catherine
    2 Cuckoo Dene
    W7 3DP London
    Segretario
    2 Cuckoo Dene
    W7 3DP London
    British65724350001
    WITHERS, John Martin
    High Trees Farm
    2 Lexden Road West Bergholt
    CO6 3BT Colchester
    Essex
    Segretario
    High Trees Farm
    2 Lexden Road West Bergholt
    CO6 3BT Colchester
    Essex
    British41682250002
    CROPPER, Anthony Graham
    Meadow House
    Moules Lane Hadstock
    CB21 4PD Cambridge
    Cambridgeshire
    Amministratore
    Meadow House
    Moules Lane Hadstock
    CB21 4PD Cambridge
    Cambridgeshire
    EnglandBritish8664640001
    FOYE, Anthony Martin
    Lynwood
    White Lane
    RG26 5TN Hannington
    Hampshire
    Amministratore
    Lynwood
    White Lane
    RG26 5TN Hannington
    Hampshire
    United KingdomBritish99515780001
    GILBERTSON, David Stuart
    Casa Maria
    Spaniard's End Hampstead
    NW3 7JG London
    Amministratore
    Casa Maria
    Spaniard's End Hampstead
    NW3 7JG London
    United KingdomBritish10921820004
    POWELL, Anthony
    14 Hill Road
    OX9 5AD Watlington
    Oxfordshire
    Amministratore
    14 Hill Road
    OX9 5AD Watlington
    Oxfordshire
    British56260870001
    WILKINSON, James Henry
    2 The Nursery
    Sutton Courtenay
    OX14 4UA Abingdon
    Oxfordshire
    Amministratore
    2 The Nursery
    Sutton Courtenay
    OX14 4UA Abingdon
    Oxfordshire
    United KingdomBritish56006210002
    WITHERS, John Martin
    High Trees Farm
    2 Lexden Road West Bergholt
    CO6 3BT Colchester
    Essex
    Amministratore
    High Trees Farm
    2 Lexden Road West Bergholt
    CO6 3BT Colchester
    Essex
    British41682250002
    WYLES, Rhona Irene
    43 Blomfield Road
    W9 2PF London
    Amministratore
    43 Blomfield Road
    W9 2PF London
    British51215380001

    BANKING TECHNOLOGY LIMITED ha ipoteche?

    Ipoteche
    ClassificazioneDateStatoDettagli
    Deed of charge
    Creato il 22 nov 1990
    Consegnato il 11 dic 1990
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company and/or all or any of the other companies named therein to the chargee under the terms of the financing documents (as defined in the charge)
    Brevi particolari
    (See doc M179 for full details). Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Persone aventi diritto
    • Morgan Guaranty Trust Company of New York (As Agent)
    Transazioni
    • 11 dic 1990Registrazione di un'ipoteca
    • 06 dic 1994Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Guarantee & debenture
    Creato il 25 set 1985
    Consegnato il 04 ott 1985
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company and/or all or any of the other companies named therein to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Persone aventi diritto
    • Barclays Bank PLC
    Transazioni
    • 04 ott 1985Registrazione di un'ipoteca

    Fonte dati

    • Companies House del Regno Unito
      Il registro ufficiale delle imprese nel Regno Unito, che fornisce l'accesso pubblico alle informazioni sulle imprese, come nomi, indirizzi, amministratori e depositi finanziari.
    • Licenza: CC0