RADAMEC DEFENCE SYSTEMS LIMITED

RADAMEC DEFENCE SYSTEMS LIMITED

  • Panoramica
  • Riepilogo
  • Scopo
  • Indirizzo
  • Denominazioni precedenti
  • Bilanci
  • Deposizioni
  • Amministratori
  • Ipoteche
  • Insolvenza
  • Fonte dati
  • Panoramica

    Nome della societàRADAMEC DEFENCE SYSTEMS LIMITED
    Stato della societàSciolta
    Forma giuridicaSocietà a responsabilità limitata
    Numero di società 01799669
    GiurisdizioneInghilterra/Galles
    Data di costituzione
    Data di cessazione

    Qual è lo scopo di RADAMEC DEFENCE SYSTEMS LIMITED?

    • (7499) /

    Dove si trova RADAMEC DEFENCE SYSTEMS LIMITED?

    Indirizzo della sede legale
    Arcadia House Maritime Walk
    Ocean Village
    SO14 3TL Southampton
    Indirizzo della sede legale non recapitabileNo

    Quali erano i nomi precedenti di RADAMEC DEFENCE SYSTEMS LIMITED?

    Denominazioni sociali precedenti
    Nome della societàDaA
    ACREGUARD LIMITED13 mar 198413 mar 1984

    Quali sono gli ultimi bilanci di RADAMEC DEFENCE SYSTEMS LIMITED?

    Ultimi bilanci
    Ultimi bilanci redatti al31 dic 2009

    Quali sono le ultime deposizioni per RADAMEC DEFENCE SYSTEMS LIMITED?

    Deposizioni
    DataDescrizioneDocumentoTipo

    Gazzetta ufficiale finale sciolta a seguito di liquidazione

    1 pagineGAZ2

    Ritorno della riunione finale in una liquidazione volontaria dei membri

    4 pagine4.71

    Dichiarazione dei ricevimenti e dei pagamenti dei liquidatori fino a 13 dic 2011

    8 pagine4.68

    Indirizzo della sede legale modificato da 417 Bridport Road Greenford Middlesex UB6 8UA in data 04 gen 2011

    1 pagineAD01

    Dichiarazione di solvibilità

    2 pagine4.70

    Risoluzione di insolvenza

    Resolution INSOLVENCY:Special Resolution ;- "in specie"
    1 pagineLIQ MISC RES

    Risoluzioni

    Resolutions
    1 pagineRESOLUTIONS
    Risoluzioni
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    liquidation

    Risoluzione speciale per la liquidazione al 14 dic 2010

    LRESSP

    Nomina di un liquidatore volontario

    1 pagine600

    Bilancio annuale redatto al 19 giu 2010 con elenco completo degli azionisti

    5 pagineAR01
    Deposizioni associate
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    capital01 lug 2010

    Stato del capitale al 01 lug 2010

    • Capitale: GBP 10,000
    SH01

    Conto per una società dormiente redatto al 31 dic 2009

    8 pagineAA

    Dettagli del direttore cambiati per Andrew Hamment il 01 ott 2009

    2 pagineCH01

    Dettagli del direttore cambiati per Mr Paul David Dean il 01 ott 2009

    2 pagineCH01

    Dettagli del segretario cambiati per Mr David Garbett-Edwards il 01 ott 2009

    1 pagineCH03

    Dettagli del direttore cambiati per Douglas Caster il 01 ott 2009

    2 pagineCH01

    Bilancio redatto al 31 dic 2008

    8 pagineAA

    legacy

    4 pagine363a

    legacy

    1 pagine288a

    legacy

    1 pagine288a

    legacy

    1 pagine288b

    legacy

    1 pagine288b

    legacy

    4 pagine363a

    Bilancio redatto al 31 dic 2007

    8 pagineAA

    Bilancio redatto al 31 dic 2006

    8 pagineAA

    legacy

    3 pagine363a

    legacy

    1 pagine288c

    Chi sono gli amministratori di RADAMEC DEFENCE SYSTEMS LIMITED?

    Amministratori
    NomeNominato ilDimissioni ilRuoloIndirizzoIdentificazione della societàPaese di residenzaNazionalitàData di nascitaProfessioneNumero
    GARBETT-EDWARDS, David
    Bridport Road
    UB6 8UA Greenford
    417
    Middlesex
    England
    Segretario
    Bridport Road
    UB6 8UA Greenford
    417
    Middlesex
    England
    British132637550001
    CASTER, Douglas
    Bridport Road
    UB6 8UA Greenford
    417
    Middlesex
    England
    Amministratore
    Bridport Road
    UB6 8UA Greenford
    417
    Middlesex
    England
    United KingdomBritish37374260003
    DEAN, Paul David
    Bridport Road
    UB6 8UA Greenford
    417
    Middlesex
    England
    Amministratore
    Bridport Road
    UB6 8UA Greenford
    417
    Middlesex
    England
    EnglandBritish78059050002
    HAMMENT, Andrew Norman
    Bridport Road
    UB6 8UA Greenford
    417
    Middlesex
    England
    Amministratore
    Bridport Road
    UB6 8UA Greenford
    417
    Middlesex
    England
    United KingdomBritish48353460001
    JEFFCOAT, David John
    417 Bridport Road
    UB6 8UA Greenford
    Middlesex
    Segretario
    417 Bridport Road
    UB6 8UA Greenford
    Middlesex
    British71377180005
    MOORE, Lionel Philip
    36 Kingsley Square
    GU51 1AH Fleet
    Hampshire
    Segretario
    36 Kingsley Square
    GU51 1AH Fleet
    Hampshire
    British31291040004
    BLOGH, Julian, Doctor
    Malvern 83 Green Lane
    SL1 8EG Burnham Beeches
    Buckinghamshire
    Amministratore
    Malvern 83 Green Lane
    SL1 8EG Burnham Beeches
    Buckinghamshire
    United KingdomBritish36783690003
    BOWLES, Martin Gibson
    53 Fairfax Road
    GU14 8JR Farnborough
    Hampshire
    Amministratore
    53 Fairfax Road
    GU14 8JR Farnborough
    Hampshire
    British68577330001
    DOBSON, John Spencer
    50 Westover Road
    GU13 9DB Fleet
    Hampshire
    Amministratore
    50 Westover Road
    GU13 9DB Fleet
    Hampshire
    British29804520001
    GRIFFIN, Richard Brian
    119 Cranborne Avenue
    Tolworth
    KT6 7JR Surbiton
    Surrey
    Amministratore
    119 Cranborne Avenue
    Tolworth
    KT6 7JR Surbiton
    Surrey
    British29201370001
    INCE, Richard Henry
    31 Armitage Court
    SL5 9TA Sunninghill
    Berks
    Amministratore
    31 Armitage Court
    SL5 9TA Sunninghill
    Berks
    British32959100001
    IRVIN, Brian Victor
    13 Saint Nicholas Drive
    TW17 9LD Shepperton
    Middlesex
    Amministratore
    13 Saint Nicholas Drive
    TW17 9LD Shepperton
    Middlesex
    British83573480001
    JEFFCOAT, David John
    417 Bridport Road
    UB6 8UA Greenford
    Middlesex
    Amministratore
    417 Bridport Road
    UB6 8UA Greenford
    Middlesex
    British71377180005
    MITCHELL, Colin Sydney
    8 Ellis Farm Close
    Mayford
    GU22 9QN Woking
    Surrey
    Amministratore
    8 Ellis Farm Close
    Mayford
    GU22 9QN Woking
    Surrey
    British58288020001
    MOORE, Lionel Philip
    36 Kingsley Square
    GU51 1AH Fleet
    Hampshire
    Amministratore
    36 Kingsley Square
    GU51 1AH Fleet
    Hampshire
    British31291040004
    MULLINS, Francis Howard, Dr
    21 West End Terrace
    SO22 5EN Winchester
    Amministratore
    21 West End Terrace
    SO22 5EN Winchester
    British23213650002
    NEEDHAM, Martin John, Dr
    The Laurels The Street
    RH6 0BY Charlwood
    Surrey
    Amministratore
    The Laurels The Street
    RH6 0BY Charlwood
    Surrey
    British53580360001
    STRAKER, Anthony John
    6 Broadwell Road
    Wrecclesham
    GU10 4QH Farnham
    Surrey
    Amministratore
    6 Broadwell Road
    Wrecclesham
    GU10 4QH Farnham
    Surrey
    British1450820001
    THORN, Simon Jeremy Boughton
    1 Ambleside Crescent
    Folly Hill
    GU9 0RZ Farnham
    Surrey
    Amministratore
    1 Ambleside Crescent
    Folly Hill
    GU9 0RZ Farnham
    Surrey
    British53580270001
    WHITTAKER, Alan William
    Milford House Bath Road
    Speen
    RG13 1RG Newbury
    Berkshire
    Amministratore
    Milford House Bath Road
    Speen
    RG13 1RG Newbury
    Berkshire
    British42113900001
    WHITTAKER, Leonard Bertram
    Hurtwood House
    Lawbrook Lane, Peaslake
    GU5 9QW Guildford
    Surrey
    Amministratore
    Hurtwood House
    Lawbrook Lane, Peaslake
    GU5 9QW Guildford
    Surrey
    United KingdomBritish1561540004
    YATES, Andrew Charles
    Squirrel Bank Yatesbury Close
    GU9 8UF Farnham
    Surrey
    Amministratore
    Squirrel Bank Yatesbury Close
    GU9 8UF Farnham
    Surrey
    United KingdomBritish31319060001

    RADAMEC DEFENCE SYSTEMS LIMITED ha ipoteche?

    Ipoteche
    ClassificazioneDateStatoDettagli
    Debenture
    Creato il 08 ago 2000
    Consegnato il 12 ago 2000
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Fortis Bank Sa-Nv
    Transazioni
    • 12 ago 2000Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 15 ago 2003Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Fixed and floating charge
    Creato il 24 ott 1995
    Consegnato il 28 ott 1995
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including uncalled capital goodwill bookdebts and patents.
    Persone aventi diritto
    • Midland Bank PLC
    Transazioni
    • 28 ott 1995Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 21 ago 2002Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Debenture
    Creato il 20 gen 1992
    Consegnato il 31 gen 1992
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    (See 395 for full details). A specific equitable charge over all freehold and leasehold properties and/or the proceeds of sale thereof fixed and floating charges over undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts and the benefits of any licences.
    Persone aventi diritto
    • Standard Chartered Bank
    Transazioni
    • 31 gen 1992Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 22 dic 1995Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Composite guarantee & debenture
    Creato il 18 mag 1987
    Consegnato il 27 mag 1987
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from thecompany and/or all or any of the other companies named therein to the charge on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Persone aventi diritto
    • London Interstate Bank Limited
    Transazioni
    • 27 mag 1987Registrazione di un'ipoteca
    • 21 feb 1992Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Debenture
    Creato il 29 ott 1985
    Consegnato il 13 nov 1985
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from thecompany to the chargee under the terms of the guarantee dates 8.7.85 and/for the debenture dates 9.12.80 and/or thie debenture.
    Brevi particolari
    By way of floraing charge all the undertaking, and property of the company whatsoever and wheresoever both present and future incouding the uncalled capital of the company subject to the floating charge created by a mortgage debenture DATED17 july 1984 (see M18 for full details).
    Persone aventi diritto
    • Railway Pension Investments Limited.
    Transazioni
    • 13 nov 1985Registrazione di un'ipoteca
    • 23 gen 1992Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Mortgage debenture
    Creato il 17 lug 1984
    Consegnato il 24 lug 1984
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    A specific equitable charge over the company's estate or interest in all f/h or l/h properties and the proceeds of sale thereof. Fixed & floating charge undertaking and all property and assets present and future including goodwill & book debts.
    Persone aventi diritto
    • National Westminster Bank PLC
    Transazioni
    • 24 lug 1984Registrazione di un'ipoteca
    • 31 gen 1992Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)

    RADAMEC DEFENCE SYSTEMS LIMITED ha procedimenti di insolvenza?

    Numero di praticaDateTipoProfessionistiAltro
    1
    DataTipo
    14 dic 2010Inizio della liquidazione
    12 lug 2012Data di scioglimento
    Liquidazione volontaria dei soci
    NomeRuoloIndirizzoNominato ilCessato il
    William Matthew Humphries Tait
    2 City Place Beehive Ring Road
    London Gatwick Airport
    RH6 0PA Gatwick
    West Sussex
    Praticante
    2 City Place Beehive Ring Road
    London Gatwick Airport
    RH6 0PA Gatwick
    West Sussex
    Andrew Howard Beckingham
    Bdo Stoy Hayward Llp
    Arcadia House
    SO14 3TL Maritime Walk
    Ocean Village Southampton
    Praticante
    Bdo Stoy Hayward Llp
    Arcadia House
    SO14 3TL Maritime Walk
    Ocean Village Southampton

    Fonte dati

    • Companies House del Regno Unito
      Il registro ufficiale delle imprese nel Regno Unito, che fornisce l'accesso pubblico alle informazioni sulle imprese, come nomi, indirizzi, amministratori e depositi finanziari.
    • Licenza: CC0