LEEDS PHOTOVISUAL LIMITED

LEEDS PHOTOVISUAL LIMITED

  • Panoramica
  • Riepilogo
  • Scopo
  • Indirizzo
  • Denominazioni precedenti
  • Bilanci
  • Deposizioni
  • Amministratori
  • Ipoteche
  • Fonte dati
  • Panoramica

    Nome della societàLEEDS PHOTOVISUAL LIMITED
    Stato della societàSciolta
    Forma giuridicaSocietà a responsabilità limitata
    Numero di società 01800891
    GiurisdizioneInghilterra/Galles
    Data di costituzione
    Data di cessazione

    Qual è lo scopo di LEEDS PHOTOVISUAL LIMITED?

    • Società inattiva (99999) / Attività di organizzazioni ed organismi extraterritoriali

    Dove si trova LEEDS PHOTOVISUAL LIMITED?

    Indirizzo della sede legale
    Promandis House
    Bradbourne Drive
    MK7 8AJ Tilbrook Milton Keynes
    Buckinghamshire
    Indirizzo della sede legale non recapitabileNo

    Quali erano i nomi precedenti di LEEDS PHOTOVISUAL LIMITED?

    Denominazioni sociali precedenti
    Nome della societàDaA
    HARGREAVES PHOTOGRAPHIC LIMITED 16 mar 198416 mar 1984

    Quali sono gli ultimi bilanci di LEEDS PHOTOVISUAL LIMITED?

    Ultimi bilanci
    Ultimi bilanci redatti al31 dic 2014

    Quali sono le ultime deposizioni per LEEDS PHOTOVISUAL LIMITED?

    Deposizioni
    DataDescrizioneDocumentoTipo

    Gazzetta Ufficiale finale sciolta per scioglimento volontario

    1 pagineGAZ2(A)

    Prima Gazzetta Ufficiale per lo scioglimento volontario

    1 pagineGAZ1(A)

    Richiesta di cancellazione della società dal registro

    3 pagineDS01

    Cessazione della carica di Christiane Brock come amministratore in data 30 mag 2016

    1 pagineTM01

    Iscrizione dell'ipoteca 018008910009, creata il 06 giu 2016

    44 pagineMR01

    Nomina di Mrs Christiane Brock come amministratore in data 25 feb 2016

    2 pagineAP01

    Cessazione della carica di Colin Halpern come amministratore in data 25 feb 2016

    1 pagineTM01

    Bilancio annuale redatto al 31 ott 2015 con elenco completo degli azionisti

    4 pagineAR01
    Deposizioni associate
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    capital04 nov 2015

    Stato del capitale al 04 nov 2015

    • Capitale: GBP 250,000
    SH01

    Conto per una società dormiente redatto al 31 dic 2014

    5 pagineAA

    Bilancio annuale redatto al 31 ott 2014 con elenco completo degli azionisti

    4 pagineAR01
    Deposizioni associate
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    capital12 dic 2014

    Stato del capitale al 12 dic 2014

    • Capitale: GBP 250,000
    SH01

    Conto per una società dormiente redatto al 31 dic 2013

    5 pagineAA

    Bilancio annuale redatto al 31 ott 2013 con elenco completo degli azionisti

    4 pagineAR01
    Deposizioni associate
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    capital26 nov 2013

    Stato del capitale al 26 nov 2013

    • Capitale: GBP 250,000
    SH01

    Conto per una società dormiente redatto al 31 dic 2012

    5 pagineAA

    Cessazione della carica di Joseph Clark come amministratore

    1 pagineTM01

    Cessazione della carica di Joseph Clark come amministratore

    1 pagineTM01

    Nomina di Mr Andreas Schaefer come segretario

    1 pagineAP03

    Cessazione della carica di Joseph Clark come segretario

    1 pagineTM02

    Nomina di Mr Andreas Schaefer come amministratore

    2 pagineAP01

    Cessazione della carica di Christopher Urgo come amministratore

    1 pagineTM01

    Bilancio annuale redatto al 31 ott 2012 con elenco completo degli azionisti

    4 pagineAR01

    Conto per una società dormiente redatto al 31 dic 2011

    5 pagineAA

    legacy

    3 pagineMG02

    legacy

    3 pagineMG02

    legacy

    3 pagineMG02

    Bilancio annuale redatto al 31 ott 2011 con elenco completo degli azionisti

    4 pagineAR01

    Chi sono gli amministratori di LEEDS PHOTOVISUAL LIMITED?

    Amministratori
    NomeNominato ilDimissioni ilRuoloIndirizzoIdentificazione della societàPaese di residenzaNazionalitàData di nascitaProfessioneNumero
    SCHAEFER, Andreas
    Promandis House
    Bradbourne Drive
    MK7 8AJ Tilbrook Milton Keynes
    Buckinghamshire
    Segretario
    Promandis House
    Bradbourne Drive
    MK7 8AJ Tilbrook Milton Keynes
    Buckinghamshire
    179466190001
    SCHAEFER, Andreas
    Promandis House
    Bradbourne Drive
    MK7 8AJ Tilbrook Milton Keynes
    Buckinghamshire
    Amministratore
    Promandis House
    Bradbourne Drive
    MK7 8AJ Tilbrook Milton Keynes
    Buckinghamshire
    GermanyGerman171085060001
    CLARK, Joseph Ogilvie
    Promandis House
    Bradbourne Drive
    MK7 8AJ Tilbrook Milton Keynes
    Buckinghamshire
    Segretario
    Promandis House
    Bradbourne Drive
    MK7 8AJ Tilbrook Milton Keynes
    Buckinghamshire
    159523260001
    RICHARDSON, Jonathan Charles
    Promandis House
    Bradbourne Drive
    MK7 8AJ Tilbrook Milton Keynes
    Buckinghamshire
    Segretario
    Promandis House
    Bradbourne Drive
    MK7 8AJ Tilbrook Milton Keynes
    Buckinghamshire
    British118293300001
    ROSS, Norma Ethel
    14 Leathwood
    Maghull
    L31 6AT Liverpool
    Merseyside
    Segretario
    14 Leathwood
    Maghull
    L31 6AT Liverpool
    Merseyside
    British9050900001
    SMITH, Stephen Anthony
    12 Chestnut Avenue
    HA6 1HR Northwood
    Middlesex
    Segretario
    12 Chestnut Avenue
    HA6 1HR Northwood
    Middlesex
    British6780200001
    UNDERWOOD, Paul Laurence
    Hill Barn 44a Wappenham Road
    Helmdon
    NN13 5QA Brackley
    Northamptonshire
    Segretario
    Hill Barn 44a Wappenham Road
    Helmdon
    NN13 5QA Brackley
    Northamptonshire
    British81277620001
    BROCK, Christiane
    Promandis House
    Bradbourne Drive
    MK7 8AJ Tilbrook Milton Keynes
    Buckinghamshire
    Amministratore
    Promandis House
    Bradbourne Drive
    MK7 8AJ Tilbrook Milton Keynes
    Buckinghamshire
    GermanyGerman205502210001
    CLARK, Joseph Ogilvie
    Promandis House
    Bradbourne Drive
    MK7 8AJ Tilbrook Milton Keynes
    Buckinghamshire
    Amministratore
    Promandis House
    Bradbourne Drive
    MK7 8AJ Tilbrook Milton Keynes
    Buckinghamshire
    EnglandBritish72081060002
    CUNNINGHAM, Anthony Gerald
    Cleeve House
    Weathercock Lane
    MK17 8NP Woburn Sands
    Bedfordshire
    Amministratore
    Cleeve House
    Weathercock Lane
    MK17 8NP Woburn Sands
    Bedfordshire
    British11015530001
    FISCHER, Andrew Olaf
    Promandis House
    Bradbourne Drive
    MK7 8AJ Tilbrook Milton Keynes
    Buckinghamshire
    Amministratore
    Promandis House
    Bradbourne Drive
    MK7 8AJ Tilbrook Milton Keynes
    Buckinghamshire
    United KingdomGerman70312740034
    FISHER, Ian
    Promandis House
    Bradbourne Drive
    MK7 8AJ Tilbrook Milton Keynes
    Buckinghamshire
    Amministratore
    Promandis House
    Bradbourne Drive
    MK7 8AJ Tilbrook Milton Keynes
    Buckinghamshire
    United KingdomBritish51776160030
    FLETCHER, Alan Thomas
    Promandis House
    Bradbourne Drive
    MK7 8AJ Tilbrook Milton Keynes
    Buckinghamshire
    Amministratore
    Promandis House
    Bradbourne Drive
    MK7 8AJ Tilbrook Milton Keynes
    Buckinghamshire
    United KingdomBritish14669590002
    HALPERN, Colin
    Promandis House
    Bradbourne Drive
    MK7 8AJ Tilbrook Milton Keynes
    Buckinghamshire
    Amministratore
    Promandis House
    Bradbourne Drive
    MK7 8AJ Tilbrook Milton Keynes
    Buckinghamshire
    United StatesAmerican112008300001
    HARGREAVES, Derek
    Greystones
    The Serpentine North
    L23 6TJ Blundellsands
    Liverpool Merseyside
    England
    Amministratore
    Greystones
    The Serpentine North
    L23 6TJ Blundellsands
    Liverpool Merseyside
    England
    British63245210001
    HARGREAVES, Neil Rowland
    102 Manor Road
    Crosby
    L23 7UU Liverpool
    Merseyside
    Amministratore
    102 Manor Road
    Crosby
    L23 7UU Liverpool
    Merseyside
    British8697030002
    KING, Andrea Dorothy
    45 Amberleigh Close
    Appleton Thorn
    WA4 4TD Warrington
    Cheshire
    Amministratore
    45 Amberleigh Close
    Appleton Thorn
    WA4 4TD Warrington
    Cheshire
    British27567210004
    LAHERT, Anthony Peter
    Woodside
    Hedgerley Hill
    SL2 3RL Hedgerley
    Berkshire
    Amministratore
    Woodside
    Hedgerley Hill
    SL2 3RL Hedgerley
    Berkshire
    United KingdomIrish79618120001
    NEWMAN, Francis David Mayow
    31 Springfield Park
    Twyford
    RG10 9JG Reading
    Berkshire
    Amministratore
    31 Springfield Park
    Twyford
    RG10 9JG Reading
    Berkshire
    United KingdomBritish31790420001
    RICHARDSON, Jonathan Charles
    Promandis House
    Bradbourne Drive
    MK7 8AJ Tilbrook Milton Keynes
    Buckinghamshire
    Amministratore
    Promandis House
    Bradbourne Drive
    MK7 8AJ Tilbrook Milton Keynes
    Buckinghamshire
    EnglandBritish118293300001
    SMITH, Stephen Anthony
    The Tudor House
    Week St Mary
    EX22 6UL Holsworthy
    Amministratore
    The Tudor House
    Week St Mary
    EX22 6UL Holsworthy
    United KingdomBritish6780200002
    STANFORD, Jeffery John
    17 Bowling Leys
    Middleton
    MK10 9BD Milton Keynes
    Buckinghamshire
    Amministratore
    17 Bowling Leys
    Middleton
    MK10 9BD Milton Keynes
    Buckinghamshire
    British68776690001
    UNDERWOOD, Paul Laurence
    Hill Barn 44a Wappenham Road
    Helmdon
    NN13 5QA Brackley
    Northamptonshire
    Amministratore
    Hill Barn 44a Wappenham Road
    Helmdon
    NN13 5QA Brackley
    Northamptonshire
    EnglandBritish81277620001
    URGO, Christopher John
    Promandis House
    Bradbourne Drive
    MK7 8AJ Tilbrook Milton Keynes
    Buckinghamshire
    Amministratore
    Promandis House
    Bradbourne Drive
    MK7 8AJ Tilbrook Milton Keynes
    Buckinghamshire
    UsaAmerican159423310001

    LEEDS PHOTOVISUAL LIMITED ha ipoteche?

    Ipoteche
    ClassificazioneDateStatoDettagli
    A registered charge
    Creato il 06 giu 2016
    Consegnato il 06 giu 2016
    In corso
    Breve descrizione
    Each security obligor charges and agrees to charge all of its present and future right, title and interest in and to the following assets which are at any time owned by it, or in which it from time to time has an interest:. (A) by way of first legal mortgage the specified real property;. (B) by way of first fixed charge:. (I) all real property and all interests in real property not charged by clause 5.1(a);. (Ii) all licences to enter upon or us land and the benefit of all other agreements relating to land; and. (Iii) the proceeds of sale of all real property other than specified real property;. (C) by way of first fixed charge the intellectual property (if any) specified in part 4 of schedule 3 (details of security assets);. (D) by way of first fixed charge all intellectual property (if any) not charged by clause 5.1(q).. "Specified real property" means the estates and interests in freehold, leasehold and other immovable property (if any) specified in part 1 of schedule 3 (details of security assets), together with:. (A) all buildings and fixtures (including trade fixtures) and fixed p&m at any time thereon;. (B) all easements, rights and agreements in respect thereof;. (C) the benefit of all covenants given in respect thereof; and. (D) any other real property which shawbrook may designate as "specified real property".. All defined terms are as defined in the composite guarantee and debenture.
    L'ipoteca flottante copre tutto:
    Contiene un'ipotesi negativa:
    Contiene un'ipoteca flottante:
    Contiene un'ipoteca fissa:
    Persone aventi diritto
    • Shawbrook Bank Limited T/a Shawbrook Business Credit
    Transazioni
    • 06 giu 2016Registrazione di un'ipoteca (MR01)
    Supplemental debenture to the debenture and
    Creato il 01 feb 2011
    Consegnato il 11 feb 2011
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from each loan party to the secured parties (or any of them) on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    The supplemental specified equipment, being: 1 canon eos 1DMKIV serial no 931001099, canon eos 7D, serial no 1580815795, 1 canon eos 7D, serial no 1580816048, and all spare parts and replacements for and all modificiations and additions to the supplemental specified equipment, see image for full details.
    Persone aventi diritto
    • Burdale Capital Finance, Inc. (As Administrative Agent and Trustee for the Secured Parties, the Agent)
    Transazioni
    • 11 feb 2011Registrazione di un'ipoteca (MG01)
    • 24 apr 2012Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (MG02)
    Loan and security agreement
    Creato il 30 giu 2009
    Consegnato il 14 lug 2009
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All sums due or to become due under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    Assigned pledged and granted all of its collateral see image for full details.
    Persone aventi diritto
    • Burdale Capital Finance Inc. as Administrative Agent and Trustee for the Secured Parties
    Transazioni
    • 14 lug 2009Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 24 apr 2012Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (MG02)
    Debenture
    Creato il 30 giu 2009
    Consegnato il 10 lug 2009
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from each loan party to the secured parties (or any of them) on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    Fixed and floating charge over all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, fixtures, fixed plant & machinery (for details of properties charged please refer to the form 395). see image for full details.
    Persone aventi diritto
    • Burdale Capital Finance, Inc., as Administrative Agent and Trustee for the Secured Parties
    Transazioni
    • 10 lug 2009Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 24 apr 2012Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (MG02)
    Legal mortgage
    Creato il 12 feb 1988
    Consegnato il 29 feb 1988
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    L/H property k/a land at orrell mount, hawthorne road bootle, merseyside and the proceeds of sale thereof. Floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment.
    Persone aventi diritto
    • National Westminster Bank PLC
    Transazioni
    • 29 feb 1988Registrazione di un'ipoteca
    • 23 mar 2006Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Legal charge
    Creato il 12 feb 1988
    Consegnato il 18 feb 1988
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    L/H land on the north easterly side of hawthorne road litherland lancashire. Together with all buildings and erections thereon and all fixtures whatsoever now or at any time hereafter affixed or attached to the property or any part thereof other than trade machinery as defined by section 5 of the bills of sale act 1878.
    Persone aventi diritto
    • Lombard North Central PLC
    Transazioni
    • 18 feb 1988Registrazione di un'ipoteca
    • 08 ago 1995Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Legal mortgage
    Creato il 09 ott 1987
    Consegnato il 15 ott 1987
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    F/H- 33/35 warbreck moor, walton, liverpool, merseyside and the proceeds of sale thereof.. Floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment.
    Persone aventi diritto
    • National Westminster Bank PLC
    Transazioni
    • 15 ott 1987Registrazione di un'ipoteca
    • 23 mar 2006Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Legal mortgage
    Creato il 30 set 1987
    Consegnato il 14 ott 1987
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    F/H-31 warbreck moor walton, liverpool, merseyside and the proceeds of sale thereof.. Floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment.
    Persone aventi diritto
    • National Westminster Bank PLC
    Transazioni
    • 14 ott 1987Registrazione di un'ipoteca
    • 23 mar 2006Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Mortgage debenture
    Creato il 02 gen 1987
    Consegnato il 07 gen 1987
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    A specific equitable charge over all freehold and leasehold properties and/or the proceeds of sale thereof fixed and floating charges over undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts and the benefits of any licences.
    Persone aventi diritto
    • National Westminster Bank PLC
    Transazioni
    • 07 gen 1987Registrazione di un'ipoteca
    • 23 mar 2006Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)

    Fonte dati

    • Companies House del Regno Unito
      Il registro ufficiale delle imprese nel Regno Unito, che fornisce l'accesso pubblico alle informazioni sulle imprese, come nomi, indirizzi, amministratori e depositi finanziari.
    • Licenza: CC0