BB REALISATIONS (2018) LIMITED

BB REALISATIONS (2018) LIMITED

  • Panoramica
  • Riepilogo
  • Scopo
  • Indirizzo
  • Denominazioni precedenti
  • Bilanci
  • Deposizioni
  • Amministratori
  • Persone con controllo significativo
  • Ipoteche
  • Insolvenza
  • Fonte dati
  • Panoramica

    Nome della societàBB REALISATIONS (2018) LIMITED
    Stato della societàSciolta
    Forma giuridicaSocietà a responsabilità limitata
    Numero di società 01801597
    GiurisdizioneInghilterra/Galles
    Data di costituzione
    Data di cessazione

    Qual è lo scopo di BB REALISATIONS (2018) LIMITED?

    • Commercio al dettaglio di bevande in negozi specializzati (47250) / Commercio all'ingrosso e al dettaglio; riparazione di autoveicoli e motocicli

    Dove si trova BB REALISATIONS (2018) LIMITED?

    Indirizzo della sede legale
    8th Floor Central Square
    29 Wellington Street
    LS1 4DL Leeds
    Indirizzo della sede legale non recapitabileNo

    Quali erano i nomi precedenti di BB REALISATIONS (2018) LIMITED?

    Denominazioni sociali precedenti
    Nome della societàDaA
    BARGAIN BOOZE LIMITED15 apr 199415 apr 1994
    SAVON DRAUGHT LIMITED19 nov 198419 nov 1984
    PETERAY LIMITED20 mar 198420 mar 1984

    Quali sono gli ultimi bilanci di BB REALISATIONS (2018) LIMITED?

    Ultimi bilanci
    Ultimi bilanci redatti al30 apr 2017

    Quali sono le ultime deposizioni per BB REALISATIONS (2018) LIMITED?

    Deposizioni
    DataDescrizioneDocumentoTipo

    Gazzetta ufficiale finale sciolta a seguito di liquidazione

    1 pagineGAZ2

    Avviso di passaggio da amministrazione a dissoluzione

    32 pagineAM23

    Rapporto di avanzamento dell'amministratore

    22 pagineAM10

    Rapporto di avanzamento dell'amministratore

    23 pagineAM10

    Avviso di proroga del periodo dell'amministrazione

    3 pagineAM19

    Rapporto di avanzamento dell'amministratore

    23 pagineAM10

    Rapporto di avanzamento dell'amministratore

    24 pagineAM10

    Avviso di proroga del periodo dell'amministrazione

    3 pagineAM19

    Rapporto di avanzamento dell'amministratore

    28 pagineAM10

    Avviso di proroga del periodo dell'amministrazione

    3 pagineAM19

    Rapporto di avanzamento dell'amministratore

    29 pagineAM10

    Avviso di nomina di un amministratore sostitutivo o aggiuntivo

    14 pagineAM11

    Nomina di un amministratore

    pagineAM01

    Avviso dell'ordinanza di revoca dell'amministratore dall'incarico

    14 pagineAM16

    Rapporto di avanzamento dell'amministratore

    28 pagineAM10

    Avviso dell'ordinanza di revoca dell'amministratore dall'incarico

    18 pagineAM16

    Rapporto di avanzamento dell'amministratore

    30 pagineAM10

    Notifica di approvazione tacita delle proposte

    4 pagineAM06

    Avviso di proroga del periodo dell'amministrazione

    4 pagineAM19

    Rapporto di avanzamento dell'amministratore

    45 pagineAM10

    Dichiarazione delle attività con il modulo AM02SOA

    24 pagineAM02

    Dichiarazione delle attività con il modulo AM02SOA

    24 pagineAM02

    Risoluzioni

    Resolutions
    2 pagineRESOLUTIONS
    Risoluzioni
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    change-of-name

    Risoluzione di cambio di nome della società il 17 apr 2018

    RES15

    Avviso di cambio di nome"

    2 pagineCONNOT

    Indirizzo della sede legale modificato da Weston Road Crewe Cheshire CW1 6BP a 8th Floor Central Square 29 Wellington Street Leeds LS1 4DL in data 30 apr 2018

    2 pagineAD01

    Chi sono gli amministratori di BB REALISATIONS (2018) LIMITED?

    Amministratori
    NomeNominato ilDimissioni ilRuoloIndirizzoIdentificazione della societàPaese di residenzaNazionalitàData di nascitaProfessioneNumero
    BAILEY, Beverley
    29 Wellington Street
    LS1 4DL Leeds
    8th Floor Central Square
    Amministratore
    29 Wellington Street
    LS1 4DL Leeds
    8th Floor Central Square
    United KingdomBritish172269670001
    BURCHELL, Kenton Paul
    29 Wellington Street
    LS1 4DL Leeds
    8th Floor Central Square
    Amministratore
    29 Wellington Street
    LS1 4DL Leeds
    8th Floor Central Square
    United KingdomBritish185864470001
    BURNETT, Adam Jonathon
    29 Wellington Street
    LS1 4DL Leeds
    8th Floor Central Square
    Amministratore
    29 Wellington Street
    LS1 4DL Leeds
    8th Floor Central Square
    United KingdomBritish170150800001
    MORAN, Mark
    Crewe
    CW1 6BP Cheshire
    Weston Road
    United Kingdom
    Amministratore
    Crewe
    CW1 6BP Cheshire
    Weston Road
    United Kingdom
    United KingdomBritish60066000008
    ROBINSON, David Peter
    Weston Road
    CW1 6BP Crewe
    Unit 1
    Cheshire
    United Kingdom
    Amministratore
    Weston Road
    CW1 6BP Crewe
    Unit 1
    Cheshire
    United Kingdom
    EnglandBritish217253080001
    SIMMONDS, Mark
    29 Wellington Street
    LS1 4DL Leeds
    8th Floor Central Square
    Amministratore
    29 Wellington Street
    LS1 4DL Leeds
    8th Floor Central Square
    EnglandBritish208740680001
    BLATCHFORD, Eric David
    21 Thornbrook
    Naas
    Kildare
    Ireland
    Segretario
    21 Thornbrook
    Naas
    Kildare
    Ireland
    British52322990002
    HODGSON, Peter Earl
    Weston Road
    Crewe
    CW1 6BP Cheshire
    Segretario
    Weston Road
    Crewe
    CW1 6BP Cheshire
    British76086790002
    HODGSON, Peter Earl
    Bramley
    Moss Lane, Madeley
    CW3 9ED Crewe
    Segretario
    Bramley
    Moss Lane, Madeley
    CW3 9ED Crewe
    British76086790002
    HUMPHREYS, Christopher Andrew
    Weston Road
    Crewe
    CW1 6BP Cheshire
    Segretario
    Weston Road
    Crewe
    CW1 6BP Cheshire
    188932680001
    MALLON, Susan Rebecca
    Weston Road
    Crewe
    CW1 6BP Cheshire
    Segretario
    Weston Road
    Crewe
    CW1 6BP Cheshire
    170168630001
    MAYOR, Robert John
    Gorsefield Barn
    Booth Lane
    CW10 0LE Middlewich
    Cheshire
    Segretario
    Gorsefield Barn
    Booth Lane
    CW10 0LE Middlewich
    Cheshire
    British101929260001
    RICHARDSON, Florence Dorothie Ann
    18 Joyce Avenue
    Foxrock
    18 Dublin
    Ireland
    Segretario
    18 Joyce Avenue
    Foxrock
    18 Dublin
    Ireland
    Irish49091210001
    ALLMAN, Denis Louis
    Troutbeck 4 Leopardstown Road
    Foxrock
    Dublin 18
    Ireland
    Amministratore
    Troutbeck 4 Leopardstown Road
    Foxrock
    Dublin 18
    Ireland
    Irish52332630001
    BLATCHFORD, Eric David
    21 Thornbrook
    Naas
    Kildare
    Ireland
    Amministratore
    21 Thornbrook
    Naas
    Kildare
    Ireland
    British52322990002
    CRABTREE, Mark
    Weston Road
    Crewe
    CW1 6BP Cheshire
    Amministratore
    Weston Road
    Crewe
    CW1 6BP Cheshire
    Great BritainBritish121416510005
    CRAWFORD, Leo John Anthony
    Rivendell 21 Offington Court
    Sutton
    13 Dublin
    13
    Ireland
    Amministratore
    Rivendell 21 Offington Court
    Sutton
    13 Dublin
    13
    Ireland
    Irish63846840001
    CRYER, Michael
    226 Coal Clough Lane
    BB11 5DH Burnley
    Lancashire
    Amministratore
    226 Coal Clough Lane
    BB11 5DH Burnley
    Lancashire
    EnglandBritish105499570001
    DASHPER HUGHES, Matthew Ramsay
    Weston Road
    Crewe
    CW1 6BP Cheshire
    Amministratore
    Weston Road
    Crewe
    CW1 6BP Cheshire
    United KingdomBritish88755670003
    DOCKERTY, Peter
    Weston Road
    Crewe
    CW1 6BP Cheshire
    Amministratore
    Weston Road
    Crewe
    CW1 6BP Cheshire
    United KingdomBritish190212950001
    GOODWIN, Anthony Roger
    The Old Vicarage Vicarage Lane
    Madeley
    CW3 9PQ Crewe
    Cheshire
    Amministratore
    The Old Vicarage Vicarage Lane
    Madeley
    CW3 9PQ Crewe
    Cheshire
    EnglandBritish18192130001
    GOODWIN, Jon Stuart
    Woodendale Cottage
    Maer Hills Baldwins Gate
    ST5 5EA Newcastle
    Staffs
    Amministratore
    Woodendale Cottage
    Maer Hills Baldwins Gate
    ST5 5EA Newcastle
    Staffs
    British18192140001
    HODGSON, Peter Earl
    Weston Road
    Crewe
    CW1 6BP Cheshire
    Amministratore
    Weston Road
    Crewe
    CW1 6BP Cheshire
    United KingdomBritish76086790002
    HUMPHREYS, Christopher Andrew
    Weston Road
    Crewe
    CW1 6BP Cheshire
    Amministratore
    Weston Road
    Crewe
    CW1 6BP Cheshire
    EnglandBritish245151040001
    HUNTER, Diana
    Weston Road
    Crewe
    CW1 6BP Cheshire
    Amministratore
    Weston Road
    Crewe
    CW1 6BP Cheshire
    EnglandBritish170154190002
    JONES, Amanda Jane
    Weston Road
    Crewe
    CW1 6BP Cheshire
    Amministratore
    Weston Road
    Crewe
    CW1 6BP Cheshire
    United KingdomBritish191755770001
    MALLON, Susan Rebecca
    Weston Road
    Crewe
    CW1 6BP Cheshire
    Amministratore
    Weston Road
    Crewe
    CW1 6BP Cheshire
    EnglandBritish170150330001
    MAYOR, Jacqueline
    Gorse Fields Barn Booth Lane
    CW10 0LE Middlewich
    Cheshire
    Amministratore
    Gorse Fields Barn Booth Lane
    CW10 0LE Middlewich
    Cheshire
    British3024590002
    MAYOR, Robert John
    Gorsefield Barn
    Booth Lane
    CW10 0LE Middlewich
    Cheshire
    Amministratore
    Gorsefield Barn
    Booth Lane
    CW10 0LE Middlewich
    Cheshire
    EnglandBritish101929260001
    MINNERY, Jason Mark
    Weston Road
    Crewe
    CW1 6BP Cheshire
    Amministratore
    Weston Road
    Crewe
    CW1 6BP Cheshire
    United KingdomBritish170151100001
    ODONNELL, John
    Residence 23
    Four Seasons Hotel
    Ballsbridge
    Dublin 4
    Ireland
    Amministratore
    Residence 23
    Four Seasons Hotel
    Ballsbridge
    Dublin 4
    Ireland
    IrelandIrish116667440002
    STANLEY, Timothy Wayne James
    Weston Road
    Crewe
    CW1 6BP Cheshire
    Amministratore
    Weston Road
    Crewe
    CW1 6BP Cheshire
    UkBritish110455010001
    STANLEY, Timothy Wayne James
    Weston Road
    Crewe
    CW1 6BP Cheshire
    Amministratore
    Weston Road
    Crewe
    CW1 6BP Cheshire
    United KingdomBritish88755680001
    WEBB, Keith Hamilton
    Weston Road
    Crewe
    CW1 6BP Cheshire
    Amministratore
    Weston Road
    Crewe
    CW1 6BP Cheshire
    WalesBritish128600690001
    WEEKS, Sarah Louise
    Weston Road
    Crewe
    CW1 6BP Cheshire
    Amministratore
    Weston Road
    Crewe
    CW1 6BP Cheshire
    United KingdomBritish170150660002

    Chi sono le persone con controllo significativo di BB REALISATIONS (2018) LIMITED?

    Persone con controllo significativo
    NomeNotificato ilIndirizzoCessato
    Crewe
    CW1 6BP Cheshire
    Weston Road
    United Kingdom
    06 apr 2016
    Crewe
    CW1 6BP Cheshire
    Weston Road
    United Kingdom
    No
    Forma giuridicaLimited By Shares
    Paese di registrazioneEngland And Wales
    Autorità legaleUnited Kingdom (England And Wales)
    Luogo di registrazioneCompanies House
    Numero di registrazione5501974
    Natura del controllo
    • La persona possiede, direttamente o indirettamente, più del 75% delle azioni della società.
    • La persona detiene, direttamente o indirettamente, più del 75% dei diritti di voto nella società.
    • La persona ha il diritto, direttamente o indirettamente, di nominare o rimuovere la maggioranza del consiglio di amministrazione della società.

    BB REALISATIONS (2018) LIMITED ha ipoteche?

    Ipoteche
    ClassificazioneDateStatoDettagli
    A registered charge
    Creato il 12 apr 2017
    Consegnato il 25 apr 2017
    In corso
    L'ipoteca flottante copre tutto:
    Contiene un'ipotesi negativa:
    Contiene un'ipoteca flottante:
    Contiene un'ipoteca fissa:
    Persone aventi diritto
    • Barclays Bank PLC (As Security Agent)
    Transazioni
    • 25 apr 2017Registrazione di un'ipoteca (MR01)
    A registered charge
    Creato il 08 lug 2016
    Consegnato il 22 lug 2016
    Soddisfatta integralmente
    L'ipoteca flottante copre tutto:
    Contiene un'ipotesi negativa:
    Contiene un'ipoteca flottante:
    Contiene un'ipoteca fissa:
    Persone aventi diritto
    • Rbs Invoice Finance Limited
    Transazioni
    • 22 lug 2016Registrazione di un'ipoteca (MR01)
    • 12 apr 2018Soddisfazione di un'ipoteca (MR04)
    A registered charge
    Creato il 08 lug 2016
    Consegnato il 21 lug 2016
    Soddisfatta integralmente
    L'ipoteca flottante copre tutto:
    Contiene un'ipotesi negativa:
    Contiene un'ipoteca flottante:
    Contiene un'ipoteca fissa:
    Persone aventi diritto
    • Rbs Invoice Finance Limited
    Transazioni
    • 21 lug 2016Registrazione di un'ipoteca (MR01)
    • 12 apr 2018Soddisfazione di un'ipoteca (MR04)
    A registered charge
    Creato il 09 ott 2015
    Consegnato il 15 ott 2015
    In corso
    L'ipoteca flottante copre tutto:
    Contiene un'ipotesi negativa:
    Contiene un'ipoteca flottante:
    Contiene un'ipoteca fissa:
    Persone aventi diritto
    • Barclays Bank PLC
    Transazioni
    • 15 ott 2015Registrazione di un'ipoteca (MR01)
    A registered charge
    Creato il 07 ott 2015
    Consegnato il 15 ott 2015
    In corso
    L'ipoteca flottante copre tutto:
    Contiene un'ipotesi negativa:
    Contiene un'ipoteca flottante:
    Contiene un'ipoteca fissa:
    Persone aventi diritto
    • The Royal Bank of Scotland PLC as Security Agent
    Transazioni
    • 15 ott 2015Registrazione di un'ipoteca (MR01)
    A registered charge
    Creato il 01 ago 2013
    Consegnato il 07 ago 2013
    Soddisfatta integralmente
    Breve descrizione
    Notification of addition to or amendment of charge.
    L'ipoteca flottante copre tutto:
    Contiene un'ipoteca flottante:
    Contiene un'ipoteca fissa:
    Persone aventi diritto
    • National Westminster Bank PLC
    Transazioni
    • 07 ago 2013Registrazione di un'ipoteca (MR01)
    • 08 mar 2016Soddisfazione di un'ipoteca (MR04)
    A registered charge
    Creato il 01 ago 2013
    Consegnato il 07 ago 2013
    Soddisfatta integralmente
    Breve descrizione
    Notification of addition to or amendment of charge.
    L'ipoteca flottante copre tutto:
    Contiene un'ipoteca flottante:
    Contiene un'ipoteca fissa:
    Persone aventi diritto
    • Rbs Invoice Finance Limited
    Transazioni
    • 07 ago 2013Registrazione di un'ipoteca (MR01)
    • 08 mar 2016Soddisfazione di un'ipoteca (MR04)
    Debenture
    Creato il 07 set 2012
    Consegnato il 12 set 2012
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from each chargor to all or any of the beneficiaries on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    Land on the south east side of moston road sandbach cheshire t/no CH438887, land on the west side of speedwell road parkhouse industrial estate newcastle-under-lyme staffordshire t/no SF409391 and land and buildings at weston road crewe t/no CH584704. Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery see image for full details.
    Persone aventi diritto
    • Allied Irish Banks PLC (As Security Agent)
    Transazioni
    • 12 set 2012Registrazione di un'ipoteca (MG01)
    • 03 ago 2013Soddisfazione di un'ipoteca (MR04)
    Account assignment
    Creato il 28 ago 2012
    Consegnato il 17 set 2012
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    The assigned assets being all monies from time to time credited to the receivablers account with a/c bank no 97006297 in the name of the assignor see image for full details.
    Persone aventi diritto
    • Aib Commercial Finance Limited
    Transazioni
    • 17 set 2012Registrazione di un'ipoteca (MG01)
    • 03 ago 2013Soddisfazione di un'ipoteca (MR04)
    Debenture
    Creato il 13 gen 2006
    Consegnato il 25 gen 2006
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to all or any of the beneficiaries on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    Land on the south east side of maston road, sandbach, cheshire t/no CH438887; land on the west side of speedwell road, parkhouse industrial estate, newcastle-under-lyme, staffordshire; land and buildings at weston road, crewe. Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Allied Irish Banks (In Its Capacity as the Security Agent for the Beneficiaries)
    Transazioni
    • 25 gen 2006Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 03 ago 2013Soddisfazione di un'ipoteca (MR04)
    Debenture
    Creato il 13 gen 2006
    Consegnato il 23 gen 2006
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company and any other present or future subsidiary of the borrower or of any company to the secured parties or any of them under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Eci Ventures Nominees Limited (Security Trustee)
    Transazioni
    • 23 gen 2006Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 03 ago 2013Soddisfazione di un'ipoteca (MR04)
    Debenture
    Creato il 13 gen 2006
    Consegnato il 21 gen 2006
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    All the book debts present and future of the company.
    Persone aventi diritto
    • Aib Commercial Services Limited
    Transazioni
    • 21 gen 2006Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 03 ago 2013Soddisfazione di un'ipoteca (MR04)
    Debenture
    Creato il 23 ago 2002
    Consegnato il 04 set 2002
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All money and liabilities due or to become due from the chargor to each beneficiary under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    Including (I) land at callington rd,saltash,cornwall; CL4873,CL62912 and CL6648 (part); (ii) units 1 to 5 springvale industrial estate,millbank way,sandbach; cheshire, CH327019,CH331073; (iii) 23 dividy rd,bucknall,stoke-on-trent,staffordshire; SF308045; see form 395 for details of other properties listed. Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Aib Capital Markets PLC,as Security Agent
    Transazioni
    • 04 set 2002Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 27 gen 2006Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Keyman insurance assignment
    Creato il 14 mar 1998
    Consegnato il 17 mar 1998
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee under or pursuant to a facility agreement dated 4TH march 1998 and each interest rate hedging agreement, the keyman insurance assignment, the guarantee and debentures and each other security document (as each such expression is defined in the facility agreement)
    Brevi particolari
    All rights, title and interest in and to the policies of life insurance by allied dunbar policy numbers 1572-25B-dms/1573-25B-dms for rj mayor and a j whittle for £500,000.
    Persone aventi diritto
    • National Westminster Bank PLC
    Transazioni
    • 17 mar 1998Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 17 ago 2002Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Guarantee and debenture
    Creato il 14 mar 1998
    Consegnato il 17 mar 1998
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company and/or goodwins of hanley limited to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    .. fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • National Westminster Bank PLC
    Transazioni
    • 17 mar 1998Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 17 ago 2002Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Legal mortgage
    Creato il 06 apr 1994
    Consegnato il 12 apr 1994
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    F/H property k/a premises at millbuck way off moston road elworth sandbach cheshire congleton t/no: ch 331073 and the proceeds of sale. Floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment and an assignment of the goodwill and connection of any business together with the full benefit of all licences.
    Persone aventi diritto
    • National Westminster Bank PLC
    Transazioni
    • 12 apr 1994Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 02 set 1997Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Legal mortgage
    Creato il 29 dic 1993
    Consegnato il 19 gen 1994
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    F/H property k/a 37, 39 and 41 wheelock street middlewich cheshire and the proceeds of sale thereof. Floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment and an assignment of the goodwill and connection of any business together with the full benefit of all licences.
    Persone aventi diritto
    • National Westminster Bank PLC
    Transazioni
    • 19 gen 1994Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 02 set 1997Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Mortgage
    Creato il 27 feb 1989
    Consegnato il 28 feb 1989
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    £34,000
    Brevi particolari
    F/H 2A queens drive sandbach cheshire.
    Persone aventi diritto
    • Alliance and Leicester Building Society
    Transazioni
    • 28 feb 1989Registrazione di un'ipoteca
    • 11 ott 1995Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Legal mortgage registered pursuant to an order of court dated 16/8/88
    Creato il 31 ago 1987
    Consegnato il 23 ago 1988
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    79-83, elton road, ettiley heath, sandbach, cheshire and/or the proceeds of sale thereof. Floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment.
    Persone aventi diritto
    • National Westminster Bank PLC
    Transazioni
    • 23 ago 1988Registrazione di un'ipoteca
    Legal mortgage registered pursuant to an order of court dated 16/8/88
    Creato il 31 ago 1987
    Consegnato il 23 ago 1988
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    58, heath road, sandbach, cheshire and/or the proceeds of sale thereof.. Floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment.
    Persone aventi diritto
    • National Westminster Bank PLC
    Transazioni
    • 23 ago 1988Registrazione di un'ipoteca
    • 02 set 1997Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Mortgage debenture
    Creato il 16 ott 1986
    Consegnato il 22 ott 1986
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    A specific equitable charge over all freehold and leasehold properties and/or the proceeds of sale thereof fixed and floating charges over undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts and the benefits of any licences.
    Persone aventi diritto
    • National Westminster Bank PLC
    Transazioni
    • 22 ott 1986Registrazione di un'ipoteca
    • 17 ago 2002Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Legal mortgage
    Creato il 13 mar 1986
    Consegnato il 19 mar 1986
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    The kings arms, 48, congleton road, sandbach, cheshire title no:- CH249563 and the proceeds of sale thereof.. Floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment.
    Persone aventi diritto
    • National Westminster Bank PLC
    Transazioni
    • 19 mar 1986Registrazione di un'ipoteca
    • 10 mar 1998Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Legal charge
    Creato il 09 set 1985
    Consegnato il 24 set 1985
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    £20,000 and all other monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the charge
    Brevi particolari
    The kings arms 48, congleton road, sandbach, cheshire.
    Persone aventi diritto
    • Boddingtons Breweries PLC
    Transazioni
    • 24 set 1985Registrazione di un'ipoteca
    • 10 mar 1998Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)

    BB REALISATIONS (2018) LIMITED ha procedimenti di insolvenza?

    Numero di praticaDateTipoProfessionistiAltro
    1
    DataTipo
    06 apr 2018Inizio dell'amministrazione
    17 apr 2023Fine dell'amministrazione
    In amministrazione
    NomeRuoloIndirizzoNominato ilCessato il
    Matthew Boyd Callaghan
    Pricewaterhousecoopers Llp 7 More London Riverside
    SE1 2RT London
    Praticante
    Pricewaterhousecoopers Llp 7 More London Riverside
    SE1 2RT London
    Ian David Green
    7 More London Riverside
    SE1 2RT London
    Praticante
    7 More London Riverside
    SE1 2RT London
    Peter David Dickens
    1 Hardman Square
    M3 3EB Manchester
    Praticante
    1 Hardman Square
    M3 3EB Manchester
    Mark James Tobias Banfield
    7 More London Riverside
    SE1 2RT London
    Praticante
    7 More London Riverside
    SE1 2RT London

    Fonte dati

    • Companies House del Regno Unito
      Il registro ufficiale delle imprese nel Regno Unito, che fornisce l'accesso pubblico alle informazioni sulle imprese, come nomi, indirizzi, amministratori e depositi finanziari.
    • Licenza: CC0