POSTERSCOPE IN THE NORTH LIMITED
Panoramica
| Nome della società | POSTERSCOPE IN THE NORTH LIMITED |
|---|---|
| Stato della società | Sciolta |
| Forma giuridica | Società a responsabilità limitata |
| Numero di società | 01803074 |
| Giurisdizione | Inghilterra/Galles |
| Data di costituzione | |
| Data di cessazione |
Riepilogo
| Ha PSCs super sicuri | No |
|---|---|
| Ha ipoteche | Sì |
| Ha una storia di insolvenza | No |
| La sede legale è in contestazione | No |
Qual è lo scopo di POSTERSCOPE IN THE NORTH LIMITED?
- Società inattiva (99999) / Attività di organizzazioni ed organismi extraterritoriali
Dove si trova POSTERSCOPE IN THE NORTH LIMITED?
| Indirizzo della sede legale | 10 Triton Street Regent'S Place NW1 3BF London United Kingdom |
|---|---|
| Indirizzo della sede legale non recapitabile | No |
Quali erano i nomi precedenti di POSTERSCOPE IN THE NORTH LIMITED?
| Nome della società | Da | A |
|---|---|---|
| HARRISON SALINSON IN THE NORTH LIMITED | 26 mar 1984 | 26 mar 1984 |
Quali sono gli ultimi bilanci di POSTERSCOPE IN THE NORTH LIMITED?
| Ultimi bilanci | |
|---|---|
| Ultimi bilanci redatti al | 31 dic 2014 |
Qual è lo stato dell'ultimo bilancio annuale per POSTERSCOPE IN THE NORTH LIMITED?
| Bilancio annuale |
|
|---|
Quali sono le ultime deposizioni per POSTERSCOPE IN THE NORTH LIMITED?
| Data | Descrizione | Documento | Tipo | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gazzetta Ufficiale finale sciolta per scioglimento volontario | 1 pagine | GAZ2(A) | ||||||||||
Prima Gazzetta Ufficiale per lo scioglimento volontario | 1 pagine | GAZ1(A) | ||||||||||
Richiesta di cancellazione della società dal registro | 3 pagine | DS01 | ||||||||||
Soddisfazione dell'onere 1 in pieno | 4 pagine | MR04 | ||||||||||
Soddisfazione dell'onere 3 in pieno | 4 pagine | MR04 | ||||||||||
Soddisfazione dell'onere 2 in pieno | 4 pagine | MR04 | ||||||||||
Conto per una società dormiente redatto al 31 dic 2014 | 9 pagine | AA | ||||||||||
Cessazione della carica di Patrick Richard Glydon come amministratore in data 22 mag 2015 | 1 pagine | TM01 | ||||||||||
Bilancio annuale redatto al 30 nov 2014 con elenco completo degli azionisti | 5 pagine | AR01 | ||||||||||
| ||||||||||||
Conto per una società dormiente redatto al 31 dic 2013 | 9 pagine | AA | ||||||||||
Dettagli del direttore cambiati per Mr Glenville Brooks Wilson il 30 apr 2012 | 2 pagine | CH01 | ||||||||||
Bilancio annuale redatto al 30 nov 2013 con elenco completo degli azionisti | 5 pagine | AR01 | ||||||||||
| ||||||||||||
Nomina di Claire Margaret Price come amministratore | 2 pagine | AP01 | ||||||||||
Conto per una società dormiente redatto al 31 dic 2012 | 9 pagine | AA | ||||||||||
Nomina di Mr Patrick Richard Glydon come amministratore | 2 pagine | AP01 | ||||||||||
Cessazione della carica di Peter Wallace come amministratore | 1 pagine | TM01 | ||||||||||
Bilancio annuale redatto al 30 nov 2012 con elenco completo degli azionisti | 4 pagine | AR01 | ||||||||||
Bilancio redatto al 31 dic 2011 | 15 pagine | AA | ||||||||||
Nomina di Mr Peter Gary Wallace come amministratore | 2 pagine | AP01 | ||||||||||
Nomina di Glen Brooks Wilson come amministratore | 2 pagine | AP01 | ||||||||||
Cessazione della carica di Steven Bond come amministratore | 1 pagine | TM01 | ||||||||||
Bilancio annuale redatto al 30 nov 2011 con elenco completo degli azionisti | 4 pagine | AR01 | ||||||||||
Cessazione della carica di Mark Holden come amministratore | 1 pagine | TM01 | ||||||||||
Nomina di Anne Rickard come amministratore | 2 pagine | AP01 | ||||||||||
Indirizzo della sede legale modificato da * 180 Great Portland Street London W1W 5QZ* in data 20 lug 2011 | 1 pagine | AD01 | ||||||||||
Chi sono gli amministratori di POSTERSCOPE IN THE NORTH LIMITED?
| Nome | Nominato il | Dimissioni il | Ruolo | Indirizzo | Identificazione della società | Paese di residenza | Nazionalità | Data di nascita | Professione | Numero |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MOBERLY, Andrew John | Segretario | Triton Street Regent's Place NW1 3BF London 10 United Kingdom United Kingdom | 153998270001 | |||||||
| PRICE, Claire Margaret | Amministratore | Triton Street Regent's Place NW1 3BF London 10 United Kingdom United Kingdom | England | British | 181956820001 | |||||
| RICKARD, Anne Teresa | Amministratore | Triton Street Regent's Place NW1 3BF London 10 United Kingdom United Kingdom | England | British | 49624130001 | |||||
| WILSON, Glen Brooks | Amministratore | Triton Street Regent's Place NW1 3BF London 10 United Kingdom United Kingdom | England | British | 53530020004 | |||||
| BLETSO, David Roy | Segretario | Ember Place Carleton Close KT10 8EE Esher Surrey | British | 105756170002 | ||||||
| CORE, Peter | Segretario | 37 Linhope Street NW1 6HU London | British | 42044680002 | ||||||
| GRIFFITHS, Matthew Lloyd | Segretario | 27 Barrow Green Road RH8 0NJ Oxted Surrey | British | 10140500002 | ||||||
| HOLGATE, Nicholas James | Segretario | 14 Chalcott Gardens KT6 5HJ Long Ditton Surrey | British | 181596610001 | ||||||
| O'REILLY, Kathryn | Segretario | Ramsden Road SW12 8RD London 111b United Kingdom | British | 148930100001 | ||||||
| SALINSON, Judith Rosemary | Segretario | 8c Grove End House Grove End Road NW8 9HN London | British | 39794240002 | ||||||
| THOMAS, Caroline Emma Roberts | Segretario | Broomsleigh Street NW6 1QQ London 5 United Kingdom | British | 148930190001 | ||||||
| BALL, Maggie | Amministratore | 98 Ridley Road Forest Gate E7 0LX London | British | 10140490001 | ||||||
| BLETSO, David Roy | Amministratore | Ember Place Carleton Close KT10 8EE Esher Surrey | United Kingdom | British | 105756170002 | |||||
| BOND, Steve Alan | Amministratore | Clover Hill House Coldharbour Road K14 6JN West Byfleet Surrey | England | British | 182585950001 | |||||
| DAVID, Julie | Amministratore | 4 Westlands Philips Rark Road M45 7FS Whitefields Manchester | British | 38902530001 | ||||||
| DAVID, Julie | Amministratore | 4 Westlands Philips Rark Road M45 7FS Whitefields Manchester | British | 38902530001 | ||||||
| GLYDON, Patrick Richard | Amministratore | Triton Street Regent's Place NW1 3BF London 10 United Kingdom United Kingdom | England | British | 110646220001 | |||||
| HARDY, Frances Jane Suzanne | Amministratore | Croft Cottage 4 Church Lane Rainow Macclesfield Cheshire | British | 21993590001 | ||||||
| HARRISON, David Ernest | Amministratore | Gretels Corner Grimms Hill HP16 9BA Great Missenden Buckinghamshire | British | 6181360001 | ||||||
| HOLDEN, Mark | Amministratore | 35 Denson Road Timperley WA15 6EB Altrincham Cheshire | United Kingdom | British | 40229460002 | |||||
| HOLGATE, Nicholas James | Amministratore | 14 Chalcott Gardens KT6 5HJ Long Ditton Surrey | United Kingdom | British | 181596610001 | |||||
| LEARY, Richard | Amministratore | 60 Marlborough Avenue Cheadle Hulme SK8 7AW Cheadle Cheshire | British | 16442090001 | ||||||
| RICKARD, Anne Teresa | Amministratore | The Gables Grove Hill HA1 3HE Harrow On The Hill Middlesex | England | British | 49624130001 | |||||
| SALINSON, Judith Rosemary | Amministratore | 8c Grove End House Grove End Road NW8 9HN London | England | British | 39794240002 | |||||
| SAUL, Gillian | Amministratore | 17 Bent Lane CW8 2RJ Crowton Cheshire | British | 47185590003 | ||||||
| SINCLAIR-SMITH, James | Amministratore | Moorfield 17 Moorfield Grove M33 3GF Sale Cheshire | British | 26147280001 | ||||||
| WALLACE, Peter Gary | Amministratore | Triton Street Regent's Place NW1 3BF London 10 United Kingdom United Kingdom | United Kingdom | British | 130701650001 |
POSTERSCOPE IN THE NORTH LIMITED ha ipoteche?
| Classificazione | Date | Stato | Dettagli | |
|---|---|---|---|---|
| Composite guarantee and debenture | Creato il 17 nov 1993 Consegnato il 24 nov 1993 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due or to become due from the company and/or all or any of the other companies named therein to the chargee under the terms of a facility agreement dated 10TH november 1993 and this charge | |
Brevi particolari All stocks shares and/or other securities of the companies specified in form 395. see the mortgage charge document for full details. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
| Supplemental composite guarantee & charge | Creato il 12 nov 1993 Consegnato il 25 nov 1993 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due or to become due from the company and/or all or any of the other companies named therein to the chargee under the terms of the "facilities" (as defined) and this charge | |
Brevi particolari All the company's stocks,shares and/or other securities as specified in form 395. see the mortgage charge document for full details. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
| Composite guarantee and charge | Creato il 14 set 1992 Consegnato il 25 set 1992 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due or to become due from the company and/or all or any of the other companies named therein to the chargee under the terms of the composite guarantee and charge and the facilities agreement dated 7TH may 1991 ( as defined) | |
Brevi particolari Floating charge over its undertaking property assets and rights stock in trade and by way of deposit ( see doc ref M103 for full details). | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
Fonte dati
- Companies House del Regno Unito
Il registro ufficiale delle imprese nel Regno Unito, che fornisce l'accesso pubblico alle informazioni sulle imprese, come nomi, indirizzi, amministratori e depositi finanziari. - Licenza: CC0