POSTERSCOPE IN THE NORTH LIMITED

POSTERSCOPE IN THE NORTH LIMITED

  • Panoramica
  • Riepilogo
  • Scopo
  • Indirizzo
  • Denominazioni precedenti
  • Bilanci
  • Bilancio annuale
  • Deposizioni
  • Amministratori
  • Ipoteche
  • Fonte dati
  • Panoramica

    Nome della societàPOSTERSCOPE IN THE NORTH LIMITED
    Stato della societàSciolta
    Forma giuridicaSocietà a responsabilità limitata
    Numero di società 01803074
    GiurisdizioneInghilterra/Galles
    Data di costituzione
    Data di cessazione

    Qual è lo scopo di POSTERSCOPE IN THE NORTH LIMITED?

    • Società inattiva (99999) / Attività di organizzazioni ed organismi extraterritoriali

    Dove si trova POSTERSCOPE IN THE NORTH LIMITED?

    Indirizzo della sede legale
    10 Triton Street
    Regent'S Place
    NW1 3BF London
    United Kingdom
    Indirizzo della sede legale non recapitabileNo

    Quali erano i nomi precedenti di POSTERSCOPE IN THE NORTH LIMITED?

    Denominazioni sociali precedenti
    Nome della societàDaA
    HARRISON SALINSON IN THE NORTH LIMITED26 mar 198426 mar 1984

    Quali sono gli ultimi bilanci di POSTERSCOPE IN THE NORTH LIMITED?

    Ultimi bilanci
    Ultimi bilanci redatti al31 dic 2014

    Qual è lo stato dell'ultimo bilancio annuale per POSTERSCOPE IN THE NORTH LIMITED?

    Bilancio annuale
    Ultimo bilancio annuale

    Quali sono le ultime deposizioni per POSTERSCOPE IN THE NORTH LIMITED?

    Deposizioni
    DataDescrizioneDocumentoTipo

    Gazzetta Ufficiale finale sciolta per scioglimento volontario

    1 pagineGAZ2(A)

    Prima Gazzetta Ufficiale per lo scioglimento volontario

    1 pagineGAZ1(A)

    Richiesta di cancellazione della società dal registro

    3 pagineDS01

    Soddisfazione dell'onere 1 in pieno

    4 pagineMR04

    Soddisfazione dell'onere 3 in pieno

    4 pagineMR04

    Soddisfazione dell'onere 2 in pieno

    4 pagineMR04

    Conto per una società dormiente redatto al 31 dic 2014

    9 pagineAA

    Cessazione della carica di Patrick Richard Glydon come amministratore in data 22 mag 2015

    1 pagineTM01

    Bilancio annuale redatto al 30 nov 2014 con elenco completo degli azionisti

    5 pagineAR01
    Deposizioni associate
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    capital11 dic 2014

    Stato del capitale al 11 dic 2014

    • Capitale: GBP 100
    SH01

    Conto per una società dormiente redatto al 31 dic 2013

    9 pagineAA

    Dettagli del direttore cambiati per Mr Glenville Brooks Wilson il 30 apr 2012

    2 pagineCH01

    Bilancio annuale redatto al 30 nov 2013 con elenco completo degli azionisti

    5 pagineAR01
    Deposizioni associate
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    capital03 dic 2013

    Stato del capitale al 03 dic 2013

    • Capitale: GBP 100
    SH01

    Nomina di Claire Margaret Price come amministratore

    2 pagineAP01

    Conto per una società dormiente redatto al 31 dic 2012

    9 pagineAA

    Nomina di Mr Patrick Richard Glydon come amministratore

    2 pagineAP01

    Cessazione della carica di Peter Wallace come amministratore

    1 pagineTM01

    Bilancio annuale redatto al 30 nov 2012 con elenco completo degli azionisti

    4 pagineAR01

    Bilancio redatto al 31 dic 2011

    15 pagineAA

    Nomina di Mr Peter Gary Wallace come amministratore

    2 pagineAP01

    Nomina di Glen Brooks Wilson come amministratore

    2 pagineAP01

    Cessazione della carica di Steven Bond come amministratore

    1 pagineTM01

    Bilancio annuale redatto al 30 nov 2011 con elenco completo degli azionisti

    4 pagineAR01

    Cessazione della carica di Mark Holden come amministratore

    1 pagineTM01

    Nomina di Anne Rickard come amministratore

    2 pagineAP01

    Indirizzo della sede legale modificato da * 180 Great Portland Street London W1W 5QZ* in data 20 lug 2011

    1 pagineAD01

    Chi sono gli amministratori di POSTERSCOPE IN THE NORTH LIMITED?

    Amministratori
    NomeNominato ilDimissioni ilRuoloIndirizzoIdentificazione della societàPaese di residenzaNazionalitàData di nascitaProfessioneNumero
    MOBERLY, Andrew John
    Triton Street
    Regent's Place
    NW1 3BF London
    10
    United Kingdom
    United Kingdom
    Segretario
    Triton Street
    Regent's Place
    NW1 3BF London
    10
    United Kingdom
    United Kingdom
    153998270001
    PRICE, Claire Margaret
    Triton Street
    Regent's Place
    NW1 3BF London
    10
    United Kingdom
    United Kingdom
    Amministratore
    Triton Street
    Regent's Place
    NW1 3BF London
    10
    United Kingdom
    United Kingdom
    EnglandBritish181956820001
    RICKARD, Anne Teresa
    Triton Street
    Regent's Place
    NW1 3BF London
    10
    United Kingdom
    United Kingdom
    Amministratore
    Triton Street
    Regent's Place
    NW1 3BF London
    10
    United Kingdom
    United Kingdom
    EnglandBritish49624130001
    WILSON, Glen Brooks
    Triton Street
    Regent's Place
    NW1 3BF London
    10
    United Kingdom
    United Kingdom
    Amministratore
    Triton Street
    Regent's Place
    NW1 3BF London
    10
    United Kingdom
    United Kingdom
    EnglandBritish53530020004
    BLETSO, David Roy
    Ember Place
    Carleton Close
    KT10 8EE Esher
    Surrey
    Segretario
    Ember Place
    Carleton Close
    KT10 8EE Esher
    Surrey
    British105756170002
    CORE, Peter
    37 Linhope Street
    NW1 6HU London
    Segretario
    37 Linhope Street
    NW1 6HU London
    British42044680002
    GRIFFITHS, Matthew Lloyd
    27 Barrow Green Road
    RH8 0NJ Oxted
    Surrey
    Segretario
    27 Barrow Green Road
    RH8 0NJ Oxted
    Surrey
    British10140500002
    HOLGATE, Nicholas James
    14 Chalcott Gardens
    KT6 5HJ Long Ditton
    Surrey
    Segretario
    14 Chalcott Gardens
    KT6 5HJ Long Ditton
    Surrey
    British181596610001
    O'REILLY, Kathryn
    Ramsden Road
    SW12 8RD London
    111b
    United Kingdom
    Segretario
    Ramsden Road
    SW12 8RD London
    111b
    United Kingdom
    British148930100001
    SALINSON, Judith Rosemary
    8c Grove End House
    Grove End Road
    NW8 9HN London
    Segretario
    8c Grove End House
    Grove End Road
    NW8 9HN London
    British39794240002
    THOMAS, Caroline Emma Roberts
    Broomsleigh Street
    NW6 1QQ London
    5
    United Kingdom
    Segretario
    Broomsleigh Street
    NW6 1QQ London
    5
    United Kingdom
    British148930190001
    BALL, Maggie
    98 Ridley Road
    Forest Gate
    E7 0LX London
    Amministratore
    98 Ridley Road
    Forest Gate
    E7 0LX London
    British10140490001
    BLETSO, David Roy
    Ember Place
    Carleton Close
    KT10 8EE Esher
    Surrey
    Amministratore
    Ember Place
    Carleton Close
    KT10 8EE Esher
    Surrey
    United KingdomBritish105756170002
    BOND, Steve Alan
    Clover Hill House
    Coldharbour Road
    K14 6JN West Byfleet
    Surrey
    Amministratore
    Clover Hill House
    Coldharbour Road
    K14 6JN West Byfleet
    Surrey
    EnglandBritish182585950001
    DAVID, Julie
    4 Westlands
    Philips Rark Road
    M45 7FS Whitefields
    Manchester
    Amministratore
    4 Westlands
    Philips Rark Road
    M45 7FS Whitefields
    Manchester
    British38902530001
    DAVID, Julie
    4 Westlands
    Philips Rark Road
    M45 7FS Whitefields
    Manchester
    Amministratore
    4 Westlands
    Philips Rark Road
    M45 7FS Whitefields
    Manchester
    British38902530001
    GLYDON, Patrick Richard
    Triton Street
    Regent's Place
    NW1 3BF London
    10
    United Kingdom
    United Kingdom
    Amministratore
    Triton Street
    Regent's Place
    NW1 3BF London
    10
    United Kingdom
    United Kingdom
    EnglandBritish110646220001
    HARDY, Frances Jane Suzanne
    Croft Cottage 4 Church Lane
    Rainow
    Macclesfield
    Cheshire
    Amministratore
    Croft Cottage 4 Church Lane
    Rainow
    Macclesfield
    Cheshire
    British21993590001
    HARRISON, David Ernest
    Gretels Corner Grimms Hill
    HP16 9BA Great Missenden
    Buckinghamshire
    Amministratore
    Gretels Corner Grimms Hill
    HP16 9BA Great Missenden
    Buckinghamshire
    British6181360001
    HOLDEN, Mark
    35 Denson Road
    Timperley
    WA15 6EB Altrincham
    Cheshire
    Amministratore
    35 Denson Road
    Timperley
    WA15 6EB Altrincham
    Cheshire
    United KingdomBritish40229460002
    HOLGATE, Nicholas James
    14 Chalcott Gardens
    KT6 5HJ Long Ditton
    Surrey
    Amministratore
    14 Chalcott Gardens
    KT6 5HJ Long Ditton
    Surrey
    United KingdomBritish181596610001
    LEARY, Richard
    60 Marlborough Avenue
    Cheadle Hulme
    SK8 7AW Cheadle
    Cheshire
    Amministratore
    60 Marlborough Avenue
    Cheadle Hulme
    SK8 7AW Cheadle
    Cheshire
    British16442090001
    RICKARD, Anne Teresa
    The Gables Grove Hill
    HA1 3HE Harrow On The Hill
    Middlesex
    Amministratore
    The Gables Grove Hill
    HA1 3HE Harrow On The Hill
    Middlesex
    EnglandBritish49624130001
    SALINSON, Judith Rosemary
    8c Grove End House
    Grove End Road
    NW8 9HN London
    Amministratore
    8c Grove End House
    Grove End Road
    NW8 9HN London
    EnglandBritish39794240002
    SAUL, Gillian
    17 Bent Lane
    CW8 2RJ Crowton
    Cheshire
    Amministratore
    17 Bent Lane
    CW8 2RJ Crowton
    Cheshire
    British47185590003
    SINCLAIR-SMITH, James
    Moorfield 17 Moorfield Grove
    M33 3GF Sale
    Cheshire
    Amministratore
    Moorfield 17 Moorfield Grove
    M33 3GF Sale
    Cheshire
    British26147280001
    WALLACE, Peter Gary
    Triton Street
    Regent's Place
    NW1 3BF London
    10
    United Kingdom
    United Kingdom
    Amministratore
    Triton Street
    Regent's Place
    NW1 3BF London
    10
    United Kingdom
    United Kingdom
    United KingdomBritish130701650001

    POSTERSCOPE IN THE NORTH LIMITED ha ipoteche?

    Ipoteche
    ClassificazioneDateStatoDettagli
    Composite guarantee and debenture
    Creato il 17 nov 1993
    Consegnato il 24 nov 1993
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company and/or all or any of the other companies named therein to the chargee under the terms of a facility agreement dated 10TH november 1993 and this charge
    Brevi particolari
    All stocks shares and/or other securities of the companies specified in form 395. see the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Societe Generale
    Transazioni
    • 24 nov 1993Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 11 set 2015Soddisfazione di un'ipoteca (MR04)
    Supplemental composite guarantee & charge
    Creato il 12 nov 1993
    Consegnato il 25 nov 1993
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company and/or all or any of the other companies named therein to the chargee under the terms of the "facilities" (as defined) and this charge
    Brevi particolari
    All the company's stocks,shares and/or other securities as specified in form 395. see the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Samuel Montagu & Co.Limited
    Transazioni
    • 25 nov 1993Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 11 set 2015Soddisfazione di un'ipoteca (MR04)
    Composite guarantee and charge
    Creato il 14 set 1992
    Consegnato il 25 set 1992
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company and/or all or any of the other companies named therein to the chargee under the terms of the composite guarantee and charge and the facilities agreement dated 7TH may 1991 ( as defined)
    Brevi particolari
    Floating charge over its undertaking property assets and rights stock in trade and by way of deposit ( see doc ref M103 for full details).
    Persone aventi diritto
    • Samuel Montagu & Co. Limitedas Trustee and Agent for the Banks
    Transazioni
    • 25 set 1992Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 11 set 2015Soddisfazione di un'ipoteca (MR04)

    Fonte dati

    • Companies House del Regno Unito
      Il registro ufficiale delle imprese nel Regno Unito, che fornisce l'accesso pubblico alle informazioni sulle imprese, come nomi, indirizzi, amministratori e depositi finanziari.
    • Licenza: CC0