MANITOWOC (UK) LIMITED

MANITOWOC (UK) LIMITED

  • Panoramica
  • Riepilogo
  • Scopo
  • Indirizzo
  • Denominazioni precedenti
  • Bilanci
  • Deposizioni
  • Amministratori
  • Persone con controllo significativo
  • Ipoteche
  • Fonte dati
  • Panoramica

    Nome della societàMANITOWOC (UK) LIMITED
    Stato della societàSciolta
    Forma giuridicaSocietà a responsabilità limitata
    Numero di società 01803796
    GiurisdizioneInghilterra/Galles
    Data di costituzione
    Data di cessazione

    Qual è lo scopo di MANITOWOC (UK) LIMITED?

    • Società inattiva (99999) / Attività di organizzazioni ed organismi extraterritoriali

    Dove si trova MANITOWOC (UK) LIMITED?

    Indirizzo della sede legale
    C/O Womble Bond Dickinson (Uk) Llp The Spark
    Drayman's Way, Newcastle Helix
    NE4 5DE Newcastle Upon Tyne
    United Kingdom
    Indirizzo della sede legale non recapitabileNo

    Quali erano i nomi precedenti di MANITOWOC (UK) LIMITED?

    Denominazioni sociali precedenti
    Nome della societàDaA
    S & W BERISFORD LIMITED14 set 199214 set 1992
    BERISFORD NOMINEES LIMITED08 mag 198908 mag 1989
    S. & W. BERISFORD (NOMINEES) LIMITED03 mag 198403 mag 1984
    FINCHVOTE LIMITED28 mar 198428 mar 1984

    Quali sono gli ultimi bilanci di MANITOWOC (UK) LIMITED?

    Ultimi bilanci
    Ultimi bilanci redatti al31 dic 2020

    Quali sono le ultime deposizioni per MANITOWOC (UK) LIMITED?

    Deposizioni
    DataDescrizioneDocumentoTipo

    Gazzetta Ufficiale finale sciolta per scioglimento volontario

    1 pagineGAZ2(A)

    Indirizzo della sede legale modificato da St Ann's Wharf 112 Quayside Newcastle upon Tyne NE1 3DX a C/O Womble Bond Dickinson (Uk) Llp the Spark Drayman's Way, Newcastle Helix Newcastle upon Tyne NE4 5DE in data 05 lug 2022

    1 pagineAD01

    Nomina di Delphine Guinand come amministratore in data 16 mag 2022

    2 pagineAP01

    Cessazione della carica di Thomas Lee Doerr come amministratore in data 16 mag 2022

    1 pagineTM01

    Nomina di Brian Patrick Regan come amministratore in data 22 apr 2022

    2 pagineAP01

    Cessazione della carica di David Antoniuk come amministratore in data 22 apr 2022

    1 pagineTM01

    Prima Gazzetta Ufficiale per lo scioglimento volontario

    1 pagineGAZ1(A)

    Richiesta di cancellazione della società dal registro

    3 pagineDS01

    Dichiarazione di conformità presentata il 20 nov 2021 senza aggiornamenti

    3 pagineCS01

    Conti modificati per una società dormiente redatti al 31 dic 2020

    8 pagineAAMD

    Conto per una società dormiente redatto al 31 dic 2020

    2 pagineAA

    Conto per una società dormiente redatto al 31 dic 2019

    8 pagineAA

    Dichiarazione di conformità presentata il 20 nov 2020 senza aggiornamenti

    3 pagineCS01

    Dichiarazione di conformità presentata il 20 nov 2019 senza aggiornamenti

    3 pagineCS01

    Conto per una società dormiente redatto al 31 dic 2018

    8 pagineAA

    Modifica dei dettagli di Manitowoc Group (Uk) Limited come persona con controllo significativo il 05 set 2019

    2 paginePSC05

    Dichiarazione di conformità presentata il 20 nov 2018 senza aggiornamenti

    3 pagineCS01

    Conto per una società dormiente redatto al 31 dic 2017

    8 pagineAA

    Nomina di David Antoniuk come amministratore in data 30 nov 2017

    2 pagineAP01

    Nomina di Thomas Lee Doerr come amministratore in data 30 nov 2017

    2 pagineAP01

    Cessazione della carica di Louis Frederick Raymond come amministratore in data 27 nov 2017

    1 pagineTM01

    Cessazione della carica di Graham Philip Brisley Veal come amministratore in data 30 nov 2017

    1 pagineTM01

    Cessazione della carica di Adrian David Gray come amministratore in data 30 nov 2017

    1 pagineTM01

    Dichiarazione di conformità presentata il 20 nov 2017 con aggiornamenti

    4 pagineCS01

    Bilancio redatto al 31 dic 2016

    13 pagineAA

    Chi sono gli amministratori di MANITOWOC (UK) LIMITED?

    Amministratori
    NomeNominato ilDimissioni ilRuoloIndirizzoIdentificazione della societàPaese di residenzaNazionalitàData di nascitaProfessioneNumero
    PRIMA SECRETARY LIMITED
    More London Riverside
    SE1 2AU London
    4
    England
    Segretario
    More London Riverside
    SE1 2AU London
    4
    England
    Tipo di documento di identificazioneSocietà a responsabilità limitata del Regno Unito
    Numero di registrazione4363143
    94529700001
    GUINAND, Delphine
    66 Chemin Du Moulin Carron
    69570
    Dardilly
    Mcg France
    France
    Amministratore
    66 Chemin Du Moulin Carron
    69570
    Dardilly
    Mcg France
    France
    FranceFrenchSenior Emea Legal Council296711020001
    REGAN, Brian Patrick
    One Park Plaza
    11270 West Park Plaza, Suite 1000
    Milwaukee
    The Manitowoc Company, Inc
    United States
    Amministratore
    One Park Plaza
    11270 West Park Plaza, Suite 1000
    Milwaukee
    The Manitowoc Company, Inc
    United States
    United StatesAmericanVp And Corporate Controller295367970001
    BURROWES, Rosemary Anne
    108c Bramley Road
    Oakwood
    N14 4HT London
    Segretario
    108c Bramley Road
    Oakwood
    N14 4HT London
    British49687740001
    HOOPER, David Ross
    Long Mynd Burchetts Green Lane
    Burchetts Green
    SL6 3QW Maidenhead
    Berkshire
    Segretario
    Long Mynd Burchetts Green Lane
    Burchetts Green
    SL6 3QW Maidenhead
    Berkshire
    British17023730001
    SYMS, Rhonda Sneddon
    2 Swallow Rise
    Knaphill
    GU21 2LG Woking
    Surrey
    Segretario
    2 Swallow Rise
    Knaphill
    GU21 2LG Woking
    Surrey
    British16978550002
    ANTONIUK, David
    112 Quayside
    NE1 3DX Newcastle Upon Tyne
    St Ann's Wharf
    Amministratore
    112 Quayside
    NE1 3DX Newcastle Upon Tyne
    St Ann's Wharf
    United StatesAmericanDirector240868140001
    BLADES, Kevin Nicholas
    Hatch Farm
    Bossingham Road
    CT4 6AQ Stelling Minnis
    Kent
    Amministratore
    Hatch Farm
    Bossingham Road
    CT4 6AQ Stelling Minnis
    Kent
    EnglandBritishAccountant79449700002
    CUTHBERTSON, George Brian
    39 The Gardens
    WD1 3DN Watford
    Hertfordshire
    Amministratore
    39 The Gardens
    WD1 3DN Watford
    Hertfordshire
    United KingdomBritishCorporate Treasurer6996370001
    DOERR, Thomas Lee
    112 Quayside
    NE1 3DX Newcastle Upon Tyne
    St Ann's Wharf
    Amministratore
    112 Quayside
    NE1 3DX Newcastle Upon Tyne
    St Ann's Wharf
    United StatesAmericanSolicitor240868220001
    DOERR, Thomas
    Hillborow Road
    KT10 9UD Esher
    Newleigh House
    Surrey
    Amministratore
    Hillborow Road
    KT10 9UD Esher
    Newleigh House
    Surrey
    United StatesSolicitor134081280001
    FINDLER, Jonathan Paul
    Westwood House
    Heathfield Avenue
    SL5 0AL Ascot
    Berkshire
    Amministratore
    Westwood House
    Heathfield Avenue
    SL5 0AL Ascot
    Berkshire
    BritishFinance Director45532880003
    GILL, Martin John
    24 Parkwood Road
    Wimbledon
    SW19 7AQ London
    Amministratore
    24 Parkwood Road
    Wimbledon
    SW19 7AQ London
    EnglandBritishFinance Manager58291030001
    GORDON, Alastair Neil
    64 Castelnau
    SW13 9EX London
    Amministratore
    64 Castelnau
    SW13 9EX London
    EnglandBritishChartered Accountant61620710001
    GRAY, Adrian David
    Quayside
    NE1 3DX Newcastle Upon Tyne
    St Ann's Wharf 112
    Amministratore
    Quayside
    NE1 3DX Newcastle Upon Tyne
    St Ann's Wharf 112
    United KingdomBritishAccountant146072380001
    HOOPER, David Ross
    Mill Road
    SL7 1UA Marlow
    6 Millbank
    Buckinghamshire
    Amministratore
    Mill Road
    SL7 1UA Marlow
    6 Millbank
    Buckinghamshire
    BritishCompany Secretary17023730002
    JONES, Maurice Delon
    1650 Westbury Court
    Manitowoc
    Wisconsin 54220
    Usa
    Amministratore
    1650 Westbury Court
    Manitowoc
    Wisconsin 54220
    Usa
    UsaAmericanCompany Director134328700001
    KACHMER, Michael James
    Marywood Trail
    60187 Wheaton
    14
    Illinois
    United States
    Amministratore
    Marywood Trail
    60187 Wheaton
    14
    Illinois
    United States
    United StatesAmericanCompany Director136570610001
    O'CONNOR, Patrick Finbarr
    66 Cumberland Mills Square
    Saunders Ness Road
    E14 3BJ Isle Of Dogs
    London
    Amministratore delegato nominato
    66 Cumberland Mills Square
    Saunders Ness Road
    E14 3BJ Isle Of Dogs
    London
    British/Irish900010100001
    RAYMOND, Louis Frederick
    South 44th Street
    54220 Manitowoc
    2400
    Wisconsin
    Usa
    Amministratore
    South 44th Street
    54220 Manitowoc
    2400
    Wisconsin
    Usa
    United StatesAmericanAttorney208080730001
    STUART, Charles Murray
    Longacre Guildford Road
    Chobham
    GU24 8EA Woking
    Surrey
    Amministratore
    Longacre Guildford Road
    Chobham
    GU24 8EA Woking
    Surrey
    BritishCompany Director/Consultant36073540001
    VEAL, Graham Philip Brisley
    112 Quayside
    NE1 3DX Newcastle Upon Tyne
    St Anns Wharf
    United Kingdom
    Amministratore
    112 Quayside
    NE1 3DX Newcastle Upon Tyne
    St Anns Wharf
    United Kingdom
    EnglandBritishBusiness Development Director43215170003
    WILSON, Andrew George Richard
    Cononley Hall
    Main Street Cononley
    BD20 8LJ Skipton
    West Yorkshire
    Amministratore
    Cononley Hall
    Main Street Cononley
    BD20 8LJ Skipton
    West Yorkshire
    BritishAccountant47433990002
    WILTSHIRE, Harold Phillip
    Dipley Mill
    Dipley
    RG27 8JP Hartley Wintney
    Hampshire
    Amministratore
    Dipley Mill
    Dipley
    RG27 8JP Hartley Wintney
    Hampshire
    BritishCompany Director930220001
    BERISFORD (OVERSEAS) LIMITED
    112 Quayside
    NE1 3DX Newcastle Upon Tyne
    St Ann's Wharf
    United Kingdom
    Amministratore
    112 Quayside
    NE1 3DX Newcastle Upon Tyne
    St Ann's Wharf
    United Kingdom
    Tipo di documento di identificazioneSEE
    Numero di registrazione331247
    75310650003
    BERISFORD (OVERSEAS) LIMITED
    Washington House
    40-41 Conduit Street
    W1S 2YQ London
    Amministratore
    Washington House
    40-41 Conduit Street
    W1S 2YQ London
    75310650002
    BERISFORD HOLDINGS LIMITED
    1 Baker Street
    W1M 1AA London
    Amministratore
    1 Baker Street
    W1M 1AA London
    40239460002
    BERISFORD PROPERTY(INVESTMENTS) LIMITED
    1 Baker Street
    W1M 1AA London
    Amministratore
    1 Baker Street
    W1M 1AA London
    29257590003

    Chi sono le persone con controllo significativo di MANITOWOC (UK) LIMITED?

    Persone con controllo significativo
    NomeNotificato ilIndirizzoCessato
    Network 421
    Radclive Road
    MK18 4FD Gawcott
    Manitowoc House
    Buckinghamshire
    United Kingdom
    27 lug 2017
    Network 421
    Radclive Road
    MK18 4FD Gawcott
    Manitowoc House
    Buckinghamshire
    United Kingdom
    No
    Forma giuridicaLimited By Shares
    Paese di registrazioneEngland
    Autorità legaleUnited Kingdom (England)
    Luogo di registrazioneCompanies House
    Numero di registrazione109849
    Natura del controllo
    • La persona possiede, direttamente o indirettamente, più del 75% delle azioni della società.
    • La persona detiene, direttamente o indirettamente, più del 75% dei diritti di voto nella società.
    • La persona ha il diritto, direttamente o indirettamente, di nominare o rimuovere la maggioranza del consiglio di amministrazione della società.
    112 Quayside
    NE1 3DX Newcastle Upon Tyne
    St Ann's Wharf
    United Kingdom
    15 lug 2016
    112 Quayside
    NE1 3DX Newcastle Upon Tyne
    St Ann's Wharf
    United Kingdom
    Forma giuridicaLimited By Shares
    Paese di registrazioneEngland
    Autorità legaleUnited Kingdom (England)
    Luogo di registrazioneCompanies House
    Numero di registrazione2992272
    Natura del controllo
    • La persona possiede, direttamente o indirettamente, più del 75% delle azioni della società.
    • La persona detiene, direttamente o indirettamente, più del 75% dei diritti di voto nella società.
    • La persona ha il diritto, direttamente o indirettamente, di nominare o rimuovere la maggioranza del consiglio di amministrazione della società.

    MANITOWOC (UK) LIMITED ha ipoteche?

    Ipoteche
    ClassificazioneDateStatoDettagli
    Second supplemental security agreement, which is supplemental to the security agreement, dated 20TH november 2001 as supplemented by a supplemental security agreement dated 20TH february 2002
    Creato il 11 apr 2002
    Consegnato il 25 apr 2002
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from each obligor to the finance party under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    The f/h property 13 lower bristol road bath t/n AV190171, l/h property 42 west street gravesend t/n K702855, f/h property 51 bath street gravensend t/n K709759 (for details of further properties charged please refer to form 395). fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Persone aventi diritto
    • The Royal Bank of Scotland PLC (The Facility Agent)
    Transazioni
    • 25 apr 2002Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 01 mar 2005Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Supplemental security agreement between, amongst others, the charging company and the facility agent which is supplemental to the security agreement dated 20 november 2001 between the chargors and the facility agent
    Creato il 20 feb 2002
    Consegnato il 08 mar 2002
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due of each obligor to any finance party under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • The Royal Bank of Scotland PLC (The Facility Agent)
    Transazioni
    • 08 mar 2002Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 01 mar 2005Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Security agreement between the chargor and the royal bank of scotland the (facility agent)
    Creato il 20 nov 2001
    Consegnato il 30 nov 2001
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All present and future obligations and liabilities (whether actual or contingent and whether owed jointly or severally or in any other capacity whatsoever) of each chargor to any finance party under each finance document
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • The Royal Bank of Scotland PLC
    Transazioni
    • 30 nov 2001Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 01 mar 2005Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Pledge agreement
    Creato il 13 ago 1999
    Consegnato il 27 ago 1999
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All obligations due or to become due from each credit party from time to time to the facility agent, each issuing bank, the lenders or any of them or their respective affiliates under any credit document or secured hedge agreement
    Brevi particolari
    All investment property: all right, title and interest of the company in all shares of capital stock owned by any us subsidiary ,the pledge agreement and the certificates, the collateral account together with all amounts on deposit from time to time in such deposit account. All books, records, ledger cards, files, computer programs, tapes, discs and related data processing software that at any time evidence or contain information relating to any of the collateral. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Barclays Bank PLC, as Facility Agent
    Transazioni
    • 27 ago 1999Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 22 ago 2001Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)

    Fonte dati

    • Companies House del Regno Unito
      Il registro ufficiale delle imprese nel Regno Unito, che fornisce l'accesso pubblico alle informazioni sulle imprese, come nomi, indirizzi, amministratori e depositi finanziari.
    • Licenza: CC0