MANITOWOC (UK) LIMITED
Panoramica
Nome della società | MANITOWOC (UK) LIMITED |
---|---|
Stato della società | Sciolta |
Forma giuridica | Società a responsabilità limitata |
Numero di società | 01803796 |
Giurisdizione | Inghilterra/Galles |
Data di costituzione | |
Data di cessazione |
Riepilogo
Ha PSCs super sicuri | No |
---|---|
Ha ipoteche | Sì |
Ha una storia di insolvenza | No |
La sede legale è in contestazione | No |
Qual è lo scopo di MANITOWOC (UK) LIMITED?
- Società inattiva (99999) / Attività di organizzazioni ed organismi extraterritoriali
Dove si trova MANITOWOC (UK) LIMITED?
Indirizzo della sede legale | C/O Womble Bond Dickinson (Uk) Llp The Spark Drayman's Way, Newcastle Helix NE4 5DE Newcastle Upon Tyne United Kingdom |
---|---|
Indirizzo della sede legale non recapitabile | No |
Quali erano i nomi precedenti di MANITOWOC (UK) LIMITED?
Nome della società | Da | A |
---|---|---|
S & W BERISFORD LIMITED | 14 set 1992 | 14 set 1992 |
BERISFORD NOMINEES LIMITED | 08 mag 1989 | 08 mag 1989 |
S. & W. BERISFORD (NOMINEES) LIMITED | 03 mag 1984 | 03 mag 1984 |
FINCHVOTE LIMITED | 28 mar 1984 | 28 mar 1984 |
Quali sono gli ultimi bilanci di MANITOWOC (UK) LIMITED?
Ultimi bilanci | |
---|---|
Ultimi bilanci redatti al | 31 dic 2020 |
Quali sono le ultime deposizioni per MANITOWOC (UK) LIMITED?
Data | Descrizione | Documento | Tipo | |
---|---|---|---|---|
Gazzetta Ufficiale finale sciolta per scioglimento volontario | 1 pagine | GAZ2(A) | ||
Indirizzo della sede legale modificato da St Ann's Wharf 112 Quayside Newcastle upon Tyne NE1 3DX a C/O Womble Bond Dickinson (Uk) Llp the Spark Drayman's Way, Newcastle Helix Newcastle upon Tyne NE4 5DE in data 05 lug 2022 | 1 pagine | AD01 | ||
Nomina di Delphine Guinand come amministratore in data 16 mag 2022 | 2 pagine | AP01 | ||
Cessazione della carica di Thomas Lee Doerr come amministratore in data 16 mag 2022 | 1 pagine | TM01 | ||
Nomina di Brian Patrick Regan come amministratore in data 22 apr 2022 | 2 pagine | AP01 | ||
Cessazione della carica di David Antoniuk come amministratore in data 22 apr 2022 | 1 pagine | TM01 | ||
Prima Gazzetta Ufficiale per lo scioglimento volontario | 1 pagine | GAZ1(A) | ||
Richiesta di cancellazione della società dal registro | 3 pagine | DS01 | ||
Dichiarazione di conformità presentata il 20 nov 2021 senza aggiornamenti | 3 pagine | CS01 | ||
Conti modificati per una società dormiente redatti al 31 dic 2020 | 8 pagine | AAMD | ||
Conto per una società dormiente redatto al 31 dic 2020 | 2 pagine | AA | ||
Conto per una società dormiente redatto al 31 dic 2019 | 8 pagine | AA | ||
Dichiarazione di conformità presentata il 20 nov 2020 senza aggiornamenti | 3 pagine | CS01 | ||
Dichiarazione di conformità presentata il 20 nov 2019 senza aggiornamenti | 3 pagine | CS01 | ||
Conto per una società dormiente redatto al 31 dic 2018 | 8 pagine | AA | ||
Modifica dei dettagli di Manitowoc Group (Uk) Limited come persona con controllo significativo il 05 set 2019 | 2 pagine | PSC05 | ||
Dichiarazione di conformità presentata il 20 nov 2018 senza aggiornamenti | 3 pagine | CS01 | ||
Conto per una società dormiente redatto al 31 dic 2017 | 8 pagine | AA | ||
Nomina di David Antoniuk come amministratore in data 30 nov 2017 | 2 pagine | AP01 | ||
Nomina di Thomas Lee Doerr come amministratore in data 30 nov 2017 | 2 pagine | AP01 | ||
Cessazione della carica di Louis Frederick Raymond come amministratore in data 27 nov 2017 | 1 pagine | TM01 | ||
Cessazione della carica di Graham Philip Brisley Veal come amministratore in data 30 nov 2017 | 1 pagine | TM01 | ||
Cessazione della carica di Adrian David Gray come amministratore in data 30 nov 2017 | 1 pagine | TM01 | ||
Dichiarazione di conformità presentata il 20 nov 2017 con aggiornamenti | 4 pagine | CS01 | ||
Bilancio redatto al 31 dic 2016 | 13 pagine | AA | ||
Chi sono gli amministratori di MANITOWOC (UK) LIMITED?
Nome | Nominato il | Dimissioni il | Ruolo | Indirizzo | Identificazione della società | Paese di residenza | Nazionalità | Data di nascita | Professione | Numero | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PRIMA SECRETARY LIMITED | Segretario | More London Riverside SE1 2AU London 4 England |
| 94529700001 | ||||||||||
GUINAND, Delphine | Amministratore | 66 Chemin Du Moulin Carron 69570 Dardilly Mcg France France | France | French | Senior Emea Legal Council | 296711020001 | ||||||||
REGAN, Brian Patrick | Amministratore | One Park Plaza 11270 West Park Plaza, Suite 1000 Milwaukee The Manitowoc Company, Inc United States | United States | American | Vp And Corporate Controller | 295367970001 | ||||||||
BURROWES, Rosemary Anne | Segretario | 108c Bramley Road Oakwood N14 4HT London | British | 49687740001 | ||||||||||
HOOPER, David Ross | Segretario | Long Mynd Burchetts Green Lane Burchetts Green SL6 3QW Maidenhead Berkshire | British | 17023730001 | ||||||||||
SYMS, Rhonda Sneddon | Segretario | 2 Swallow Rise Knaphill GU21 2LG Woking Surrey | British | 16978550002 | ||||||||||
ANTONIUK, David | Amministratore | 112 Quayside NE1 3DX Newcastle Upon Tyne St Ann's Wharf | United States | American | Director | 240868140001 | ||||||||
BLADES, Kevin Nicholas | Amministratore | Hatch Farm Bossingham Road CT4 6AQ Stelling Minnis Kent | England | British | Accountant | 79449700002 | ||||||||
CUTHBERTSON, George Brian | Amministratore | 39 The Gardens WD1 3DN Watford Hertfordshire | United Kingdom | British | Corporate Treasurer | 6996370001 | ||||||||
DOERR, Thomas Lee | Amministratore | 112 Quayside NE1 3DX Newcastle Upon Tyne St Ann's Wharf | United States | American | Solicitor | 240868220001 | ||||||||
DOERR, Thomas | Amministratore | Hillborow Road KT10 9UD Esher Newleigh House Surrey | United States | Solicitor | 134081280001 | |||||||||
FINDLER, Jonathan Paul | Amministratore | Westwood House Heathfield Avenue SL5 0AL Ascot Berkshire | British | Finance Director | 45532880003 | |||||||||
GILL, Martin John | Amministratore | 24 Parkwood Road Wimbledon SW19 7AQ London | England | British | Finance Manager | 58291030001 | ||||||||
GORDON, Alastair Neil | Amministratore | 64 Castelnau SW13 9EX London | England | British | Chartered Accountant | 61620710001 | ||||||||
GRAY, Adrian David | Amministratore | Quayside NE1 3DX Newcastle Upon Tyne St Ann's Wharf 112 | United Kingdom | British | Accountant | 146072380001 | ||||||||
HOOPER, David Ross | Amministratore | Mill Road SL7 1UA Marlow 6 Millbank Buckinghamshire | British | Company Secretary | 17023730002 | |||||||||
JONES, Maurice Delon | Amministratore | 1650 Westbury Court Manitowoc Wisconsin 54220 Usa | Usa | American | Company Director | 134328700001 | ||||||||
KACHMER, Michael James | Amministratore | Marywood Trail 60187 Wheaton 14 Illinois United States | United States | American | Company Director | 136570610001 | ||||||||
O'CONNOR, Patrick Finbarr | Amministratore delegato nominato | 66 Cumberland Mills Square Saunders Ness Road E14 3BJ Isle Of Dogs London | British/Irish | 900010100001 | ||||||||||
RAYMOND, Louis Frederick | Amministratore | South 44th Street 54220 Manitowoc 2400 Wisconsin Usa | United States | American | Attorney | 208080730001 | ||||||||
STUART, Charles Murray | Amministratore | Longacre Guildford Road Chobham GU24 8EA Woking Surrey | British | Company Director/Consultant | 36073540001 | |||||||||
VEAL, Graham Philip Brisley | Amministratore | 112 Quayside NE1 3DX Newcastle Upon Tyne St Anns Wharf United Kingdom | England | British | Business Development Director | 43215170003 | ||||||||
WILSON, Andrew George Richard | Amministratore | Cononley Hall Main Street Cononley BD20 8LJ Skipton West Yorkshire | British | Accountant | 47433990002 | |||||||||
WILTSHIRE, Harold Phillip | Amministratore | Dipley Mill Dipley RG27 8JP Hartley Wintney Hampshire | British | Company Director | 930220001 | |||||||||
BERISFORD (OVERSEAS) LIMITED | Amministratore | 112 Quayside NE1 3DX Newcastle Upon Tyne St Ann's Wharf United Kingdom |
| 75310650003 | ||||||||||
BERISFORD (OVERSEAS) LIMITED | Amministratore | Washington House 40-41 Conduit Street W1S 2YQ London | 75310650002 | |||||||||||
BERISFORD HOLDINGS LIMITED | Amministratore | 1 Baker Street W1M 1AA London | 40239460002 | |||||||||||
BERISFORD PROPERTY(INVESTMENTS) LIMITED | Amministratore | 1 Baker Street W1M 1AA London | 29257590003 |
Chi sono le persone con controllo significativo di MANITOWOC (UK) LIMITED?
Nome | Notificato il | Indirizzo | Cessato | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Manitowoc Group (Uk) Limited | 27 lug 2017 | Network 421 Radclive Road MK18 4FD Gawcott Manitowoc House Buckinghamshire United Kingdom | No | ||||||||||
| |||||||||||||
Natura del controllo
| |||||||||||||
Enodis International Limited | 15 lug 2016 | 112 Quayside NE1 3DX Newcastle Upon Tyne St Ann's Wharf United Kingdom | Sì | ||||||||||
| |||||||||||||
Natura del controllo
|
MANITOWOC (UK) LIMITED ha ipoteche?
Classificazione | Date | Stato | Dettagli | |
---|---|---|---|---|
Second supplemental security agreement, which is supplemental to the security agreement, dated 20TH november 2001 as supplemented by a supplemental security agreement dated 20TH february 2002 | Creato il 11 apr 2002 Consegnato il 25 apr 2002 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due or to become due from each obligor to the finance party under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Brevi particolari The f/h property 13 lower bristol road bath t/n AV190171, l/h property 42 west street gravesend t/n K702855, f/h property 51 bath street gravensend t/n K709759 (for details of further properties charged please refer to form 395). fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
Supplemental security agreement between, amongst others, the charging company and the facility agent which is supplemental to the security agreement dated 20 november 2001 between the chargors and the facility agent | Creato il 20 feb 2002 Consegnato il 08 mar 2002 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due or to become due of each obligor to any finance party under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Brevi particolari Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
Security agreement between the chargor and the royal bank of scotland the (facility agent) | Creato il 20 nov 2001 Consegnato il 30 nov 2001 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All present and future obligations and liabilities (whether actual or contingent and whether owed jointly or severally or in any other capacity whatsoever) of each chargor to any finance party under each finance document | |
Brevi particolari Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
Pledge agreement | Creato il 13 ago 1999 Consegnato il 27 ago 1999 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All obligations due or to become due from each credit party from time to time to the facility agent, each issuing bank, the lenders or any of them or their respective affiliates under any credit document or secured hedge agreement | |
Brevi particolari All investment property: all right, title and interest of the company in all shares of capital stock owned by any us subsidiary ,the pledge agreement and the certificates, the collateral account together with all amounts on deposit from time to time in such deposit account. All books, records, ledger cards, files, computer programs, tapes, discs and related data processing software that at any time evidence or contain information relating to any of the collateral. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
|
Fonte dati
- Companies House del Regno Unito
Il registro ufficiale delle imprese nel Regno Unito, che fornisce l'accesso pubblico alle informazioni sulle imprese, come nomi, indirizzi, amministratori e depositi finanziari. - Licenza: CC0