PROJECT MARY REALISATIONS LIMITED

PROJECT MARY REALISATIONS LIMITED

  • Panoramica
  • Riepilogo
  • Scopo
  • Indirizzo
  • Denominazioni precedenti
  • Bilanci
  • Deposizioni
  • Amministratori
  • Ipoteche
  • Insolvenza
  • Fonte dati
  • Panoramica

    Nome della societàPROJECT MARY REALISATIONS LIMITED
    Stato della societàSciolta
    Forma giuridicaSocietà a responsabilità limitata
    Numero di società 01804716
    GiurisdizioneInghilterra/Galles
    Data di costituzione
    Data di cessazione

    Qual è lo scopo di PROJECT MARY REALISATIONS LIMITED?

    • formatura e lavorazione del vetro piano (23120) / Industrie manifatturiere

    Dove si trova PROJECT MARY REALISATIONS LIMITED?

    Indirizzo della sede legale
    9th Floor 3 Hardman Street
    M3 3HF Manchester
    Indirizzo della sede legale non recapitabileNo

    Quali erano i nomi precedenti di PROJECT MARY REALISATIONS LIMITED?

    Denominazioni sociali precedenti
    Nome della societàDaA
    KITE GLASS LIMITED31 mar 200631 mar 2006
    EFCO LIMITED21 mag 198421 mag 1984
    CHALKCIRCLE LIMITED30 mar 198430 mar 1984

    Quali sono gli ultimi bilanci di PROJECT MARY REALISATIONS LIMITED?

    Ultimi bilanci
    Ultimi bilanci redatti al31 dic 2011

    Quali sono le ultime deposizioni per PROJECT MARY REALISATIONS LIMITED?

    Deposizioni
    DataDescrizioneDocumentoTipo

    Gazzetta ufficiale finale sciolta a seguito di liquidazione

    1 pagineGAZ2

    Ritorno della riunione finale in una liquidazione volontaria dei creditori

    18 pagineLIQ14

    Dichiarazione dei ricevimenti e dei pagamenti dei liquidatori fino a 07 ago 2017

    15 pagineLIQ03

    Dichiarazione dei ricevimenti e dei pagamenti dei liquidatori fino a 07 ago 2016

    15 pagine4.68

    Dichiarazione dei ricevimenti e dei pagamenti dei liquidatori fino a 07 ago 2015

    16 pagine4.68

    Nomina di un liquidatore volontario

    1 pagine600

    Rapporto di avanzamento dell'amministratore fino a 08 ago 2014

    19 pagine2.24B

    Avviso di passaggio da amministrazione a liquidazione volontaria dei creditori

    1 pagine2.34B

    Nomina di un amministratore

    2.12B

    Dimissioni di un amministratore

    1 pagine2.38B

    Indirizzo della sede legale modificato da * Arkwright House Parsonage Gardens Manchester M3 2LF* in data 07 mar 2014

    2 pagineAD01

    Rapporto di avanzamento dell'amministratore fino a 12 feb 2014

    17 pagine2.24B

    Dichiarazione delle attività con il modulo 2.14B/2.15B

    10 pagine2.16B

    Risultato della riunione dei creditori

    2 pagine2.23B

    Indirizzo della sede legale modificato da * 29 Avro Way Brooklands Business Park Weybridge Surrey KT13 0YZ* in data 27 set 2013

    2 pagineAD01

    Dichiarazione della proposta dell'amministratore

    33 pagine2.17B

    Nomina di un amministratore

    1 pagine2.12B

    Certificato di cambio di nome

    Company name changed kite glass LIMITED\certificate issued on 19/08/13
    3 pagineCERTNM
    Deposizioni associate
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    change-of-name19 ago 2013

    Risoluzione di cambio di nome della società il 13 ago 2013

    RES15

    Avviso di cambio di nome"

    2 pagineCONNOT

    Bilancio annuale redatto al 06 ott 2012 con elenco completo degli azionisti

    6 pagineAR01
    Deposizioni associate
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    capital01 nov 2012

    Stato del capitale al 01 nov 2012

    • Capitale: GBP 8,006,750
    SH01

    Bilancio per una piccola impresa redatto al 31 dic 2011

    6 pagineAA

    Secondo deposito di AR01 precedentemente inviato alla Camera di Commercio aggiornato al 06 ott 2011

    17 pagineRP04

    Bilancio annuale redatto al 06 ott 2011 con elenco completo degli azionisti

    7 pagineAR01
    Note
    DataNota
    11 set 2012A second filed AR01 was registered on the 11 September 2012

    Cessazione della carica di Nicholas Bostock Smith come segretario

    1 pagineTM02

    Risoluzioni

    Resolutions
    1 pagineRESOLUTIONS
    Risoluzioni
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    capital

    Risoluzioni

    Company business 22/06/2011
    RES13

    Chi sono gli amministratori di PROJECT MARY REALISATIONS LIMITED?

    Amministratori
    NomeNominato ilDimissioni ilRuoloIndirizzoIdentificazione della societàPaese di residenzaNazionalitàData di nascitaProfessioneNumero
    NYS, Theofiel Joannes
    Rietstraat 7/2
    8400 Oostende
    FOREIGN Belgium
    Amministratore
    Rietstraat 7/2
    8400 Oostende
    FOREIGN Belgium
    BelgiumBelgian61916960002
    REED, Leroy Felix
    3 Hardman Street
    M3 3HF Manchester
    9th Floor
    Amministratore
    3 Hardman Street
    M3 3HF Manchester
    9th Floor
    United KingdomBritish112412170001
    SEYNAEVE, Geraldine
    Eksterenberg 50
    Essene Affligem
    1790
    Belgium
    Amministratore
    Eksterenberg 50
    Essene Affligem
    1790
    Belgium
    BelgiumBelgian135686140001
    BOSTOCK SMITH, Nicholas
    29 Avro Way
    Brooklands Business Park
    KT13 0YZ Weybridge
    Surrey
    Segretario
    29 Avro Way
    Brooklands Business Park
    KT13 0YZ Weybridge
    Surrey
    British112412260001
    CAMPBELL, Carol
    55 Alpha Road
    KT5 8RU Surbiton
    Surrey
    Segretario
    55 Alpha Road
    KT5 8RU Surbiton
    Surrey
    British70049080002
    GRAY, Tim
    10 Ferry Road
    KT7 0XZ Thames Ditton
    Surrey
    Segretario
    10 Ferry Road
    KT7 0XZ Thames Ditton
    Surrey
    British87216190001
    WOOD, Martin James
    Rosemary Cottage 1 Vyne Road
    Sherborne St John
    RG24 9HX Basingstoke
    Hampshire
    Segretario
    Rosemary Cottage 1 Vyne Road
    Sherborne St John
    RG24 9HX Basingstoke
    Hampshire
    British45073950001
    APPLIN, David Jonathon
    Whiteways
    Tangmere Road, Tangmere
    PO20 6HW Chichester
    West Sussex
    Amministratore
    Whiteways
    Tangmere Road, Tangmere
    PO20 6HW Chichester
    West Sussex
    British64050710001
    CLEDWYN-DAVIES, Denys Norman
    Long Meadow Duckington Lane
    Broxton
    CH3 9HS Chester
    Cheshire
    Amministratore
    Long Meadow Duckington Lane
    Broxton
    CH3 9HS Chester
    Cheshire
    British30931460001
    HARRIS, Helmut Werner
    41 Highland Drive
    GU13 8TH Fleet
    Hampshire
    Amministratore
    41 Highland Drive
    GU13 8TH Fleet
    Hampshire
    British28866820001
    LEON, Jack Ronald
    Sefton Hockering Road
    GU22 7HG Woking
    Surrey
    Amministratore
    Sefton Hockering Road
    GU22 7HG Woking
    Surrey
    British17315360001
    MURRAY, Keith Alexander
    5 Barricane
    GU21 7RB Woking
    Surrey
    Amministratore
    5 Barricane
    GU21 7RB Woking
    Surrey
    EnglandBritish111744600001
    NYS, Theofiel Joannes
    Mechelbaan 510
    2870 Putte
    Belgium
    Amministratore
    Mechelbaan 510
    2870 Putte
    Belgium
    Belgian61916960001
    SEYNAEVE, Geraldine
    Eksterenberg 50
    Essene Affligem
    1790
    Belgium
    Amministratore
    Eksterenberg 50
    Essene Affligem
    1790
    Belgium
    BelgiumBelgian135686140001
    SEYNAEVE, Jean-Pierre Arthur Marie
    Seyntexlaan 2
    8700 Tielt
    FOREIGN Belgium
    Amministratore
    Seyntexlaan 2
    8700 Tielt
    FOREIGN Belgium
    Belgian61917020001
    VERHOEVEN, Robert Joseph
    Halve Maanstraat 24
    2890 Sint-Amands
    FOREIGN Belgium
    Amministratore
    Halve Maanstraat 24
    2890 Sint-Amands
    FOREIGN Belgium
    Belgian61917120001
    VICKERS, Kenneth
    32 Francis Way
    GU15 1EX Camberley
    Surrey
    Amministratore
    32 Francis Way
    GU15 1EX Camberley
    Surrey
    British69739400002
    WOOD, Martin James
    Rosemary Cottage 1 Vyne Road
    Sherborne St John
    RG24 9HX Basingstoke
    Hampshire
    Amministratore
    Rosemary Cottage 1 Vyne Road
    Sherborne St John
    RG24 9HX Basingstoke
    Hampshire
    EnglandBritish45073950001
    BMT NV
    Kortrijksesteenweg 1097 B
    Sint-Denijs-Westrem
    9051
    Belgium
    Amministratore
    Kortrijksesteenweg 1097 B
    Sint-Denijs-Westrem
    9051
    Belgium
    132095170001
    EUROVLAS NV
    8700 Tielt
    Seyntexlaan 3
    Belgium
    Amministratore
    8700 Tielt
    Seyntexlaan 3
    Belgium
    130904300001

    PROJECT MARY REALISATIONS LIMITED ha ipoteche?

    Ipoteche
    ClassificazioneDateStatoDettagli
    Debenture
    Creato il 25 gen 1999
    Consegnato il 03 feb 1999
    In corso
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    .. fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Kbc Bank N.V.
    Transazioni
    • 03 feb 1999Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 04 dic 1999Dichiarazione che parte o tutta la proprietà di un onere fluttuante è stata liberata (403b)
    Composite guarantee and debenture
    Creato il 01 lug 1997
    Consegnato il 11 lug 1997
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from any group company (as therein defined) to the chargee on any account whatsoever whether pursuant to the guarantee (as therein defined) or otherwise
    Brevi particolari
    F/H land k/a unit h shilton industrial estate rugby warwickshire t/n WK330199, the fixed assets as described in part iii of the form M395. Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transazioni
    • 11 lug 1997Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 26 nov 1999Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Legal charge
    Creato il 31 gen 1994
    Consegnato il 09 feb 1994
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    F/H property k/a unit h shilton industrial estate rugby warwickshire with all fixtures and fittings. Together with all fixtures and fittings now or at any time hereafter on the property. The benefits of all rights licences and the goodwill of the mortgagor in relation to the business from time to time carried on at the property.
    Persone aventi diritto
    • Midland Bank PLC
    Transazioni
    • 09 feb 1994Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 11 lug 1997Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Charge
    Creato il 10 apr 1992
    Consegnato il 14 apr 1992
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever supplemental to a fixed & floating charge d/d 30/06/86
    Brevi particolari
    All goodwill & uncalled capital....see form 395 for full details.
    Persone aventi diritto
    • Midland Bank PLC
    Transazioni
    • 14 apr 1992Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 11 lug 1997Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Collateral chattel mortgage
    Creato il 22 gen 1990
    Consegnato il 25 gen 1990
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from efco holdings limited to the chargeee on any account whatsoever.
    Brevi particolari
    By way of assignment of the plant machinery chattels or other equipment: serial no. 88015426 - billco 60 "eh washing machine come with pre-spray unit. Located at forsyth road, sheerwater, woking, surrey GU21 5RZ. Together with additions alterations accessories replacements and renewals of component parts thereto (please see doc M395 for full details).
    Persone aventi diritto
    • 3I PLC
    Transazioni
    • 25 gen 1990Registrazione di un'ipoteca
    • 11 lug 1997Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Collateral chattel mortgage
    Creato il 14 giu 1988
    Consegnato il 17 giu 1988
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from efco billco limited to the chargee on any account whatsoever.
    Brevi particolari
    The plant machinery chattels or other equipment with any part or parts thereof and all additions alterations accessories (please see doc for full details).
    Persone aventi diritto
    • Investors in Industry PLC
    Transazioni
    • 17 giu 1988Registrazione di un'ipoteca
    • 11 lug 1997Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Collateral debenture
    Creato il 14 giu 1988
    Consegnato il 17 giu 1988
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from efco billco limited to the chargee on any account whatsoever.
    Brevi particolari
    (Please see doc for full details). Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Persone aventi diritto
    • Investors in Industry PLC
    Transazioni
    • 17 giu 1988Registrazione di un'ipoteca
    • 11 lug 1997Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Fixed and floating charge
    Creato il 30 giu 1986
    Consegnato il 07 lug 1986
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Fixed & floating charge over the undertaking and all property and assets present and future including book debts. Uncalled capital.
    Persone aventi diritto
    • Midland Bank PLC
    Transazioni
    • 07 lug 1986Registrazione di un'ipoteca
    • 11 lug 1997Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Guarantee & debenture
    Creato il 17 lug 1984
    Consegnato il 26 lug 1984
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company and/or efco-billco limited to the chargee on any account whatsoever.
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Persone aventi diritto
    • Barclays Bank PLC
    Transazioni
    • 26 lug 1984Registrazione di un'ipoteca
    Debenture
    Creato il 17 lug 1984
    Consegnato il 23 lug 1984
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Persone aventi diritto
    • Investors in Industry PLC.
    Transazioni
    • 23 lug 1984Registrazione di un'ipoteca
    Mortgage debenture
    Creato il 31 mag 1984
    Consegnato il 06 giu 1984
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee
    Brevi particolari
    A) all estates or interests in any f/h or l/h properties b) all stocks and shares c) all book debts d) the goodwill of the company e) the undertaking of the company (see doc M11 for full details).
    Persone aventi diritto
    • Manufactures Hanover Trust Company.
    Transazioni
    • 06 giu 1984Registrazione di un'ipoteca

    PROJECT MARY REALISATIONS LIMITED ha procedimenti di insolvenza?

    Numero di praticaDateTipoProfessionistiAltro
    1
    DataTipo
    13 ago 2013Inizio dell'amministrazione
    08 ago 2014Fine dell'amministrazione
    In amministrazione
    NomeRuoloIndirizzoNominato ilCessato il
    Jeremy Nigel Ian Woodside
    Arkwright House Parsonage Gardens
    M3 2LF Manchester
    Praticante
    Arkwright House Parsonage Gardens
    M3 2LF Manchester
    Christopher Ratten
    Baker Tilly Business Services Limited
    3 Hardman Street
    M3 3HF Manchester
    Praticante
    Baker Tilly Business Services Limited
    3 Hardman Street
    M3 3HF Manchester
    Christopher Benjamin Barrett
    Rsm Tenon Restructuring Arkwright House
    Parsonage Gardens
    M3 2LF Manchester
    Praticante
    Rsm Tenon Restructuring Arkwright House
    Parsonage Gardens
    M3 2LF Manchester
    2
    DataTipo
    08 ago 2014Inizio della liquidazione
    06 lug 2018Data di scioglimento
    Liquidazione volontaria dei creditori
    NomeRuoloIndirizzoNominato ilCessato il
    Christopher Ratten
    Baker Tilly Business Services Limited
    3 Hardman Street
    M3 3HF Manchester
    Liquidatore proposto
    Baker Tilly Business Services Limited
    3 Hardman Street
    M3 3HF Manchester
    Jeremy Nigel Ian Woodside
    Baker Tilly Business Services Limited
    3 Hardman Street
    M3 3HF Manchester
    Liquidatore proposto
    Baker Tilly Business Services Limited
    3 Hardman Street
    M3 3HF Manchester
    Jeremy Nigel Ian Woodside
    Baker Tilly Business Services Limited
    3 Hardman Street
    M3 3HF Manchester
    Praticante
    Baker Tilly Business Services Limited
    3 Hardman Street
    M3 3HF Manchester
    Christopher Ratten
    Baker Tilly Business Services Limited
    3 Hardman Street
    M3 3HF Manchester
    Praticante
    Baker Tilly Business Services Limited
    3 Hardman Street
    M3 3HF Manchester

    Fonte dati

    • Companies House del Regno Unito
      Il registro ufficiale delle imprese nel Regno Unito, che fornisce l'accesso pubblico alle informazioni sulle imprese, come nomi, indirizzi, amministratori e depositi finanziari.
    • Licenza: CC0