GROSVENOR PRESS INTERNATIONAL LIMITED

GROSVENOR PRESS INTERNATIONAL LIMITED

  • Panoramica
  • Riepilogo
  • Scopo
  • Indirizzo
  • Bilanci
  • Deposizioni
  • Amministratori
  • Ipoteche
  • Fonte dati
  • Panoramica

    Nome della societàGROSVENOR PRESS INTERNATIONAL LIMITED
    Stato della societàSciolta
    Forma giuridicaSocietà a responsabilità limitata
    Numero di società 01805442
    GiurisdizioneInghilterra/Galles
    Data di costituzione
    Data di cessazione

    Qual è lo scopo di GROSVENOR PRESS INTERNATIONAL LIMITED?

    • (7499) /

    Dove si trova GROSVENOR PRESS INTERNATIONAL LIMITED?

    Indirizzo della sede legale
    Mortimer House
    37-41 Mortimer Street
    W1T 3JH London
    Indirizzo della sede legale non recapitabileNo

    Quali sono gli ultimi bilanci di GROSVENOR PRESS INTERNATIONAL LIMITED?

    Ultimi bilanci
    Ultimi bilanci redatti al31 dic 2009

    Quali sono le ultime deposizioni per GROSVENOR PRESS INTERNATIONAL LIMITED?

    Deposizioni
    DataDescrizioneDocumentoTipo

    Gazzetta Ufficiale finale sciolta per scioglimento volontario

    1 pagineGAZ2(A)

    Prima Gazzetta Ufficiale per lo scioglimento volontario

    1 pagineGAZ1(A)

    Richiesta di cancellazione della società dal registro

    3 pagineDS01

    legacy

    1 pagineCAP-SS

    Stato del capitale al 23 dic 2010

    • Capitale: GBP 1
    4 pagineSH19

    Risoluzioni

    Resolutions
    2 pagineRESOLUTIONS
    Risoluzioni
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    capital

    Risoluzione di riduzione del capitale sociale emesso

    RES06

    Dettagli del direttore cambiati per Mr Adam Christopher Walker il 05 ott 2010

    2 pagineCH01

    Dettagli del segretario cambiati per Miss Julie Louise Wilson il 27 set 2010

    1 pagineCH03

    Conto per una società dormiente redatto al 31 dic 2009

    8 pagineAA

    Dettagli del direttore cambiati per John William Burton il 11 ago 2010

    2 pagineCH01

    Bilancio annuale redatto al 01 giu 2010 con elenco completo degli azionisti

    6 pagineAR01

    Nomina di Rachel Jacobs come amministratore

    2 pagineAP01

    Nomina di Gareth Richard Wright come amministratore

    2 pagineAP01

    Dettagli del direttore cambiati per Mark Henry Kerswell il 02 dic 2009

    2 pagineCH01

    Dettagli del segretario cambiati per Miss Julie Louise Wilson il 02 dic 2009

    1 pagineCH03

    Dettagli del direttore cambiati per Adam Christopher Walker il 27 nov 2009

    2 pagineCH01

    Bilancio redatto al 31 dic 2008

    5 pagineAA

    legacy

    2 pagine288a

    legacy

    3 pagine363a

    Bilancio redatto al 31 dic 2007

    5 pagineAA

    legacy

    1 pagine288c

    legacy

    3 pagine363a

    legacy

    3 pagine288a

    legacy

    1 pagine288b

    legacy

    1 pagine288a

    Chi sono gli amministratori di GROSVENOR PRESS INTERNATIONAL LIMITED?

    Amministratori
    NomeNominato ilDimissioni ilRuoloIndirizzoIdentificazione della societàPaese di residenzaNazionalitàData di nascitaProfessioneNumero
    WOOLLARD, Julie Louise
    37/41 Mortimer Street
    W1T 3JH London
    Mortimer House
    England
    Segretario
    37/41 Mortimer Street
    W1T 3JH London
    Mortimer House
    England
    British139159370002
    BURTON, John William
    Mortimer House
    37-41 Mortimer Street
    W1T 3JH London
    Amministratore
    Mortimer House
    37-41 Mortimer Street
    W1T 3JH London
    United KingdomBritish113684810001
    JACOBS, Rachel Elizabeth
    37/41 Mortimer Street
    W1T 3JH London
    Mortimer House
    England
    Amministratore
    37/41 Mortimer Street
    W1T 3JH London
    Mortimer House
    England
    United KingdomBritish92334500004
    KERSWELL, Mark Henry
    37/41 Mortimer Street
    W1T 3JH London
    Mortimer House
    England
    Amministratore
    37/41 Mortimer Street
    W1T 3JH London
    Mortimer House
    England
    EnglandBritish82609620003
    RIGBY, Peter Stephen
    Appledown House
    The Croft
    GL7 4BB Fairford
    Gloucestershire
    Amministratore
    Appledown House
    The Croft
    GL7 4BB Fairford
    Gloucestershire
    EnglandBritish69164290002
    WALKER, Adam Christopher
    37/41 Mortimer Street
    W1T 3JH London
    Mortimer House
    England
    Amministratore
    37/41 Mortimer Street
    W1T 3JH London
    Mortimer House
    England
    SwitzerlandBritish129368430002
    WRIGHT, Gareth Richard
    37/41 Mortimer Street
    W1T 3JH London
    Mortimer House
    England
    Amministratore
    37/41 Mortimer Street
    W1T 3JH London
    Mortimer House
    England
    United KingdomBritish131115190001
    CALLABY, Andrea Mary
    5 Thornton Drive
    CO4 5WB Colchester
    Essex
    Segretario
    5 Thornton Drive
    CO4 5WB Colchester
    Essex
    British70352690002
    HAYWARD, Pearl Catherine
    60 Idmiston Square
    KT4 7SY Worcester Park
    Surrey
    Segretario
    60 Idmiston Square
    KT4 7SY Worcester Park
    Surrey
    British61319730001
    LODGE, David William
    19 Windermere Drive
    CM7 8UB Braintree
    Essex
    Segretario
    19 Windermere Drive
    CM7 8UB Braintree
    Essex
    British10640040001
    PEACH, Inez Mary
    Silverwood Station Road
    Semley
    SP7 9AH Shaftesbury
    Dorset
    Segretario
    Silverwood Station Road
    Semley
    SP7 9AH Shaftesbury
    Dorset
    British9976010001
    RICHMOND, Sonia Anna
    8 Viscount Gardens
    KT14 6HE Byfleet
    Surrey
    Segretario
    8 Viscount Gardens
    KT14 6HE Byfleet
    Surrey
    British118535490002
    WHITE, Teresa Catherine
    2 Cuckoo Dene
    W7 3DP London
    Segretario
    2 Cuckoo Dene
    W7 3DP London
    British65724350001
    WITHERS, John Martin
    High Trees Farm
    2 Lexden Road West Bergholt
    CO6 3BT Colchester
    Essex
    Segretario
    High Trees Farm
    2 Lexden Road West Bergholt
    CO6 3BT Colchester
    Essex
    British41682250002
    CROPPER, Anthony Graham
    Meadow House
    Moules Lane Hadstock
    CB21 4PD Cambridge
    Cambridgeshire
    Amministratore
    Meadow House
    Moules Lane Hadstock
    CB21 4PD Cambridge
    Cambridgeshire
    EnglandBritish8664640001
    FOYE, Anthony Martin
    Lynwood
    White Lane
    RG26 5TN Hannington
    Hampshire
    Amministratore
    Lynwood
    White Lane
    RG26 5TN Hannington
    Hampshire
    United KingdomBritish99515780001
    GILBERTSON, David Stuart
    Casa Maria
    Spaniard's End Hampstead
    NW3 7JG London
    Amministratore
    Casa Maria
    Spaniard's End Hampstead
    NW3 7JG London
    United KingdomBritish10921820004
    RIDINGS, Stephen
    10a Belsize Park Gardens
    NW3 London
    Amministratore
    10a Belsize Park Gardens
    NW3 London
    British45198530001
    WILKINSON, James Henry
    2 The Nursery
    Sutton Courtenay
    OX14 4UA Abingdon
    Oxfordshire
    Amministratore
    2 The Nursery
    Sutton Courtenay
    OX14 4UA Abingdon
    Oxfordshire
    United KingdomBritish56006210002
    WITHERS, John Martin
    High Trees Farm
    2 Lexden Road West Bergholt
    CO6 3BT Colchester
    Essex
    Amministratore
    High Trees Farm
    2 Lexden Road West Bergholt
    CO6 3BT Colchester
    Essex
    British41682250002
    WYLES, Rhona Irene
    43 Blomfield Road
    W9 2PF London
    Amministratore
    43 Blomfield Road
    W9 2PF London
    British51215380001

    GROSVENOR PRESS INTERNATIONAL LIMITED ha ipoteche?

    Ipoteche
    ClassificazioneDateStatoDettagli
    Deed of charge
    Creato il 22 nov 1990
    Consegnato il 11 dic 1990
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company and/or all or any of the other companies named therein to the chargee under the terms of the financing documents (as defined in the charge)
    Brevi particolari
    (See M182 for full details). Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Persone aventi diritto
    • Morgan Guaranty Trust Companyof New York (As Agent)
    • Hill Samuel Bank Limited
    Transazioni
    • 11 dic 1990Registrazione di un'ipoteca
    • 06 dic 1994Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Debenture
    Creato il 06 feb 1990
    Consegnato il 14 feb 1990
    In corso
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    All bookdebts of the company present & future.
    Persone aventi diritto
    • Ulster Factors Limited
    Transazioni
    • 14 feb 1990Registrazione di un'ipoteca
    Letter of set off
    Creato il 27 set 1985
    Consegnato il 02 ott 1985
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Any sum or sums for the time being standing to the credit of any present or future account of the company with lloyds bank PLC.
    Persone aventi diritto
    • Lloyds Bank PLC
    Transazioni
    • 02 ott 1985Registrazione di un'ipoteca
    Letter of set off
    Creato il 26 ott 1984
    Consegnato il 31 ott 1984
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee
    Brevi particolari
    Any sum on sums for the time being standing to the credit of any present or future account of the company, with lloyds bank PLC.
    Persone aventi diritto
    • Lloyds Bank PLC
    Transazioni
    • 31 ott 1984Registrazione di un'ipoteca
    Trust deed
    Creato il 23 mag 1984
    Consegnato il 05 giu 1984
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    £1,400,000 and all monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of a trust deed dated 23 may 84.
    Brevi particolari
    All assets with present and future including uncalled capital by way of floating charge.
    Persone aventi diritto
    • Grosvenor Press PLC
    Transazioni
    • 05 giu 1984Registrazione di un'ipoteca
    Trust deed
    Creato il 23 mag 1984
    Consegnato il 05 giu 1984
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    £1,400,000 and all monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of a trust deed dated 23 may 84.
    Brevi particolari
    All f/h and l/h property of the company and all buildings and structures erected thereon and all fixtures and fittings and effects.
    Persone aventi diritto
    • Albion Trust Limited
    Transazioni
    • 05 giu 1984Registrazione di un'ipoteca

    Fonte dati

    • Companies House del Regno Unito
      Il registro ufficiale delle imprese nel Regno Unito, che fornisce l'accesso pubblico alle informazioni sulle imprese, come nomi, indirizzi, amministratori e depositi finanziari.
    • Licenza: CC0