DANE MOTOR COMPANY (CHESTER) LIMITED
Panoramica
| Nome della società | DANE MOTOR COMPANY (CHESTER) LIMITED |
|---|---|
| Stato della società | Sciolta |
| Forma giuridica | Società a responsabilità limitata |
| Numero di società | 01807840 |
| Giurisdizione | Inghilterra/Galles |
| Data di costituzione | |
| Data di cessazione |
Riepilogo
| Ha PSCs super sicuri | No |
|---|---|
| Ha ipoteche | Sì |
| Ha una storia di insolvenza | No |
| La sede legale è in contestazione | No |
Qual è lo scopo di DANE MOTOR COMPANY (CHESTER) LIMITED?
- Vendita al dettaglio di autovetture nuove (45111) / Commercio all'ingrosso e al dettaglio; riparazione di autoveicoli e motocicli
- Manutenzione e riparazione di autoveicoli (45200) / Commercio all'ingrosso e al dettaglio; riparazione di autoveicoli e motocicli
- Commercio all'ingrosso di parti e accessori per autoveicoli (45310) / Commercio all'ingrosso e al dettaglio; riparazione di autoveicoli e motocicli
Dove si trova DANE MOTOR COMPANY (CHESTER) LIMITED?
| Indirizzo della sede legale | First Floor Unit 3140 Park Square Solihull Parkway Birmingham Business Park B37 7YN Birmingham |
|---|---|
| Indirizzo della sede legale non recapitabile | No |
Quali erano i nomi precedenti di DANE MOTOR COMPANY (CHESTER) LIMITED?
| Nome della società | Da | A |
|---|---|---|
| DANE MOTOR COMPANY (MOLD) LIMITED | 11 apr 1984 | 11 apr 1984 |
Quali sono gli ultimi bilanci di DANE MOTOR COMPANY (CHESTER) LIMITED?
| Ultimi bilanci | |
|---|---|
| Ultimi bilanci redatti al | 31 dic 2019 |
Quali sono le ultime deposizioni per DANE MOTOR COMPANY (CHESTER) LIMITED?
| Data | Descrizione | Documento | Tipo | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gazzetta Ufficiale finale sciolta per scioglimento volontario | 1 pagine | GAZ2(A) | ||||||||||
Prima Gazzetta Ufficiale per lo scioglimento volontario | 1 pagine | GAZ1(A) | ||||||||||
Richiesta di cancellazione della società dal registro | 1 pagine | DS01 | ||||||||||
Conto per una società dormiente redatto al 31 dic 2019 | 5 pagine | AA | ||||||||||
Dichiarazione di conformità presentata il 05 mag 2020 senza aggiornamenti | 3 pagine | CS01 | ||||||||||
Cessazione della carica di Thomas Andrew Dale come amministratore in data 29 gen 2020 | 1 pagine | TM01 | ||||||||||
Conto per una società dormiente redatto al 31 dic 2018 | 5 pagine | AA | ||||||||||
Cessazione della carica di Elizabeth Louise Hancox come amministratore in data 20 set 2019 | 1 pagine | TM01 | ||||||||||
Nomina di Mr Thomas Andrew Dale come amministratore in data 04 lug 2019 | 2 pagine | AP01 | ||||||||||
Cessazione della carica di Anton Clive Jeary come amministratore in data 04 lug 2019 | 1 pagine | TM01 | ||||||||||
Dichiarazione di conformità presentata il 05 mag 2019 senza aggiornamenti | 3 pagine | CS01 | ||||||||||
Nomina di Dr Elizabeth Louise Hancox come amministratore in data 01 nov 2018 | 2 pagine | AP01 | ||||||||||
Cessazione della carica di Claire Louise Catlin come amministratore in data 21 set 2018 | 1 pagine | TM01 | ||||||||||
Dettagli del direttore cambiati per Mrs Claire Louise Catlin il 01 set 2018 | 2 pagine | CH01 | ||||||||||
Conto per una società dormiente redatto al 31 dic 2017 | 5 pagine | AA | ||||||||||
Dichiarazione di conformità presentata il 05 mag 2018 senza aggiornamenti | 3 pagine | CS01 | ||||||||||
Modifica dei dettagli di European Motor Holdings Limited come persona con controllo significativo il 01 apr 2018 | 5 pagine | PSC05 | ||||||||||
Dettagli del segretario cambiati per Inchcape Uk Corporate Management Limited il 01 apr 2018 | 3 pagine | CH04 | ||||||||||
Indirizzo della sede legale modificato da Inchcape House Langford Lane Kidlington Oxford OX5 1HT a First Floor Unit 3140 Park Square Solihull Parkway Birmingham Business Park Birmingham B37 7YN in data 09 apr 2018 | 2 pagine | AD01 | ||||||||||
Conto per una società dormiente redatto al 31 dic 2016 | 5 pagine | AA | ||||||||||
Dichiarazione di conformità presentata il 05 mag 2017 con aggiornamenti | 5 pagine | CS01 | ||||||||||
Conto per una società dormiente redatto al 31 dic 2015 | 5 pagine | AA | ||||||||||
Nomina di Mrs Claire Louise Catlin come amministratore in data 23 set 2016 | 2 pagine | AP01 | ||||||||||
Bilancio annuale redatto al 05 mag 2016 con elenco completo degli azionisti | 4 pagine | AR01 | ||||||||||
| ||||||||||||
Dettagli del direttore cambiati per Mr Martin Peter Wheatley il 29 gen 2016 | 3 pagine | CH01 | ||||||||||
Chi sono gli amministratori di DANE MOTOR COMPANY (CHESTER) LIMITED?
| Nome | Nominato il | Dimissioni il | Ruolo | Indirizzo | Identificazione della società | Paese di residenza | Nazionalità | Data di nascita | Professione | Numero | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| INCHCAPE UK CORPORATE MANAGEMENT LIMITED | Segretario | Park Square Solihull Parkway Birmingham Business Park OX5 1HT Birmingham First Floor Unit 3140 United Kingdom |
| 100307260072 | ||||||||||
| WHEATLEY, Martin Peter | Amministratore | Park Square Solihull Parkway Birmingham Business Park B37 7YN Birmingham First Floor Unit 3140 | England | British | 55180460002 | |||||||||
| BEACHAM, Mark Derrick | Segretario | Austwick Lane Emerson Valley MK4 2DR Milton Keynes 11 Buckinghamshire United Kingdom | British | 135313320001 | ||||||||||
| BIRCH, James Edward | Amministratore | Waters Reach Mill Lane Little Budworth CW6 9DB Tarporley Cheshire | English | 25690560001 | ||||||||||
| CATLIN, Claire Louise | Amministratore | Park Square Solihull Parkway Birmingham Business Park B37 7YN Birmingham First Floor Unit 3140 | England | British | 270101940001 | |||||||||
| DALE, Thomas Andrew | Amministratore | Park Square Solihull Parkway Birmingham Business Park B37 7YN Birmingham First Floor Unit 3140 | United Kingdom | British | 260286850001 | |||||||||
| HANCOX, Elizabeth Louise, Dr | Amministratore | Park Square Solihull Parkway Birmingham Business Park B37 7YN Birmingham First Floor Unit 3140 | United Kingdom | British | 210216760001 | |||||||||
| JEARY, Anton Clive | Amministratore | Park Square Solihull Parkway Birmingham Business Park B37 7YN Birmingham First Floor Unit 3140 | England | British | 169892630001 | |||||||||
| LOCK, Spencer | Amministratore | The Dower House Itchen Abbas SO21 1BQ Winchester Hampshire | England | British | 92493930001 | |||||||||
| MCCLUSKEY, Ross | Amministratore | Langford Lane Kidlington OX5 1HT Oxford Inchcape House | United Kingdom | British | 165677350002 | |||||||||
| MCCORMACK, Connor | Amministratore | New College House Alchester Road OX26 1UN Chesterton Oxfordshire | United Kingdom | British | 108832810002 | |||||||||
| PALMER, Richard Terence | Amministratore | Littlethorpe Cleeve Road RG8 9BJ Goring | England | British | 16571890002 | |||||||||
| RONCHETTI, Marc Arthur | Amministratore | New Road Croxley Green WD3 3EP Rickmansworth 22 Hertfordshire | England | British | 123180830001 | |||||||||
| WILSON, Ann Chrisette | Amministratore | The Kingswood Ridgemount Road SL5 9RW Sunningdale Berkshire | England | British | 14811650002 |
Chi sono le persone con controllo significativo di DANE MOTOR COMPANY (CHESTER) LIMITED?
| Nome | Notificato il | Indirizzo | Cessato | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| European Motor Holdings Limited | 06 apr 2016 | Solihull Parkway Birmingham Business Park B37 7YN Birmingham First Floor Unit 3140 Park Square United Kingdom | No | ||||||||||
| |||||||||||||
Natura del controllo
| |||||||||||||
DANE MOTOR COMPANY (CHESTER) LIMITED ha ipoteche?
| Classificazione | Date | Stato | Dettagli | |
|---|---|---|---|---|
| Third party legal charge | Creato il 16 feb 1999 Consegnato il 27 feb 1999 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due or to become due from normand motor group limited to the chargee on any account whatsoever | |
Brevi particolari South side of sealand road chester t/no: CH407347. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
| Legal charge | Creato il 22 dic 1997 Consegnato il 08 gen 1998 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due or to become due from the company and/or normand motor group limited to the chargee on any account whatsoever | |
Brevi particolari All that l/h land on the south side of sealand road chester cheshire t/no.CH407347. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
| Debenture | Creato il 05 mag 1994 Consegnato il 10 mag 1994 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due or to become due from the company to the chargee | |
Brevi particolari All those monies which may from time to time be owing to the company by V.A.G. (united kingdom) limited in respect of refunds of monies paid by or by the direction of the company to V.A.G. (united kingdom) limited by way of deposit on the acquisition of motor vehicles on a consignment basis. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
| Debenture | Creato il 04 nov 1991 Consegnato il 18 nov 1991 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever under the terms of the facility letter dated 28/10/91 | |
Brevi particolari For full details see form 395 tc ref.M14. Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
| Single debenture | Creato il 27 mag 1988 Consegnato il 02 giu 1988 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Brevi particolari Including heritable property and assets in scotland. Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
| Legal charge | Creato il 21 gen 1986 Consegnato il 02 mag 1986 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Brevi particolari F/H property being land & buildings on the south west side of sealand road chester. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
| Charge | Creato il 09 gen 1986 Consegnato il 15 gen 1986 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due or to become due from the company to the chargee | |
Brevi particolari All the chargors property of whatsoever nature & wheresoever situate both present & future (inc un-called capital) see doc M9. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
| Debenture | Creato il 24 gen 1985 Consegnato il 01 feb 1985 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due or to become due from the company to the chargee | |
Brevi particolari All monies from time to timearing to the company by V.A.G. (united kingdom) limited in respect of refunds paid by way of deposit on acquisition of motor vehicles on a consignment basis (see doc M8). | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
Fonte dati
- Companies House del Regno Unito
Il registro ufficiale delle imprese nel Regno Unito, che fornisce l'accesso pubblico alle informazioni sulle imprese, come nomi, indirizzi, amministratori e depositi finanziari. - Licenza: CC0