SYMONDS CIDER & ENGLISH WINE COMPANY LIMITED
Panoramica
| Nome della società | SYMONDS CIDER & ENGLISH WINE COMPANY LIMITED |
|---|---|
| Stato della società | Sciolta |
| Forma giuridica | Società a responsabilità limitata |
| Numero di società | 01809366 |
| Giurisdizione | Inghilterra/Galles |
| Data di costituzione | |
| Data di cessazione |
Riepilogo
| Ha PSCs super sicuri | No |
|---|---|
| Ha ipoteche | Sì |
| Ha una storia di insolvenza | No |
| La sede legale è in contestazione | No |
Qual è lo scopo di SYMONDS CIDER & ENGLISH WINE COMPANY LIMITED?
- Produzione di sidro e altri vini di frutta (11030) / Industrie manifatturiere
Dove si trova SYMONDS CIDER & ENGLISH WINE COMPANY LIMITED?
| Indirizzo della sede legale | Elsley Court 20-22 Great Titchfield Street W1W 8BE London |
|---|---|
| Indirizzo della sede legale non recapitabile | No |
Quali erano i nomi precedenti di SYMONDS CIDER & ENGLISH WINE COMPANY LIMITED?
| Nome della società | Da | A |
|---|---|---|
| BASKMIST LIMITED | 17 apr 1984 | 17 apr 1984 |
Quali sono gli ultimi bilanci di SYMONDS CIDER & ENGLISH WINE COMPANY LIMITED?
| Ultimi bilanci | |
|---|---|
| Ultimi bilanci redatti al | 31 dic 2013 |
Qual è lo stato dell'ultimo bilancio annuale per SYMONDS CIDER & ENGLISH WINE COMPANY LIMITED?
| Bilancio annuale |
|
|---|
Quali sono le ultime deposizioni per SYMONDS CIDER & ENGLISH WINE COMPANY LIMITED?
| Data | Descrizione | Documento | Tipo | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gazzetta Ufficiale finale sciolta per scioglimento volontario | 1 pagine | GAZ2(A) | ||||||||||
Prima Gazzetta Ufficiale per lo scioglimento volontario | 1 pagine | GAZ1(A) | ||||||||||
Richiesta di cancellazione della società dal registro | 3 pagine | DS01 | ||||||||||
legacy | 2 pagine | SH20 | ||||||||||
Stato del capitale al 08 dic 2014
| 4 pagine | SH19 | ||||||||||
legacy | 2 pagine | CAP-SS | ||||||||||
Risoluzioni Resolutions | 1 pagine | RESOLUTIONS | ||||||||||
| ||||||||||||
Nomina di Mr Josephus Petrus Adrianus Van Der Burg come amministratore in data 06 ott 2014 | 2 pagine | AP01 | ||||||||||
Nomina di Mr Malcolm Dunn come amministratore in data 06 ott 2014 | 2 pagine | AP01 | ||||||||||
Nomina di Mr David Michael Forde come amministratore in data 06 ott 2014 | 2 pagine | AP01 | ||||||||||
Cessazione della carica di Anne Louise Oliver come amministratore in data 06 ott 2014 | 1 pagine | TM01 | ||||||||||
Cessazione della carica di Sean Michael Paterson come amministratore in data 08 ott 2014 | 1 pagine | TM01 | ||||||||||
Cessazione della carica di Anne Louise Oliver come segretario in data 06 ott 2014 | 1 pagine | TM02 | ||||||||||
Bilancio redatto al 31 dic 2013 | 10 pagine | AA | ||||||||||
Bilancio annuale redatto al 27 mar 2014 con elenco completo degli azionisti | 6 pagine | AR01 | ||||||||||
Dettagli del segretario cambiati per Mrs Anne Louise Oliver il 01 apr 2014 | 1 pagine | CH03 | ||||||||||
Dettagli del direttore cambiati per Mr Sean Michael Paterson il 01 apr 2014 | 2 pagine | CH01 | ||||||||||
Dettagli del direttore cambiati per Mrs Kelly Taylor-Welsh il 01 apr 2014 | 2 pagine | CH01 | ||||||||||
Dettagli del direttore cambiati per Mrs Anne Louise Oliver il 01 apr 2014 | 2 pagine | CH01 | ||||||||||
Bilancio redatto al 31 dic 2012 | 10 pagine | AA | ||||||||||
Bilancio annuale redatto al 27 mar 2013 con elenco completo degli azionisti | 4 pagine | AR01 | ||||||||||
Dettagli del direttore cambiati per Mrs Kelly Taylor-Welsh il 01 ago 2012 | 2 pagine | CH01 | ||||||||||
Bilancio redatto al 31 dic 2011 | 10 pagine | AA | ||||||||||
Bilancio annuale redatto al 27 mar 2012 con elenco completo degli azionisti | 5 pagine | AR01 | ||||||||||
Cessazione della carica di John Charles Low come amministratore in data 31 mar 2012 | 1 pagine | TM01 | ||||||||||
Chi sono gli amministratori di SYMONDS CIDER & ENGLISH WINE COMPANY LIMITED?
| Nome | Nominato il | Dimissioni il | Ruolo | Indirizzo | Identificazione della società | Paese di residenza | Nazionalità | Data di nascita | Professione | Numero |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DUNN, Malcolm James Shiel | Amministratore | Broadway Park South Gyle Broadway EH12 9JZ Edinburgh 3-4 Scotland | Scotland | British | 191401290001 | |||||
| FORDE, David Michael | Amministratore | Broadway Park South Gyle Broadway EH12 9JZ Edinburgh 3-4 Scotland | Ireland | Irish | 178655370001 | |||||
| TAYLOR-WELSH, Kelly | Amministratore | Broadway Park South Gyle Broadway EH12 9JZ Edinburgh 3-4 Scotland | United Kingdom | British | 167915590003 | |||||
| VAN DER BURG, Josephus Petrus Adrianus | Amministratore | Broadway Park South Gyle Broadway EH12 9JZ Edinburgh 3-4 Scotland | Scotland | Dutch | 167853370002 | |||||
| AVES, Simon Howard | Segretario | Swanston Gardens EH10 1DJ Edinburgh 5 | British | 132259650001 | ||||||
| OLIVER, Anne Louise | Segretario | Broadway Park South Gyle Broadway EH12 9JZ Edinburgh 3-4 Scotland | British | 132910690001 | ||||||
| STEBBINGS, William George | Segretario | Burghill HR4 7RX Hereford The Forge Herefordshire | British | 129413480001 | ||||||
| STEVENS, Mark | Segretario | 75 Wallace Mill Gardens EH53 0BG Mid Calder West Lothian | British | 80951870003 | ||||||
| AITCHISON, Nicholas Martin Leslie | Amministratore | Lower Barn Llancloudy HR2 8QR Hereford Herefordshire | British | 6195750001 | ||||||
| AVES, Simon Howard | Amministratore | Swanston Gardens EH10 1DJ Edinburgh 5 | Scotland | British | 132259650001 | |||||
| BOND, Denis Joseph Christopher | Amministratore | Cricket Cottage Churchfield Cradley Malvern Worcestershire | British | 26007550001 | ||||||
| BROWN, Colin Carlyle Campbell | Amministratore | Little Bower 10 Nuns Walk GU25 4RT Virginia Water Surrey | British | 61755350001 | ||||||
| CRAWSHAY, William John Julian | Amministratore | The Old Vicarage NE41 8AT Wylam Northumberland | United Kingdom | British | 79182280001 | |||||
| DOOBAR, Mark Simon | Amministratore | 105 Canada Way Lower Wick WR2 4DG Worcester | British | 34501450002 | ||||||
| EGGLETON, Jonathan Philip | Amministratore | Court Leet Church Road GL17 0LL Longhope Gloucestershire | British | 83396140001 | ||||||
| FREER, Nigel | Amministratore | Stoneham House Maund Common Bodenham HR1 3JB Hereford Herefordshire | British | 59149820001 | ||||||
| FURSE, Timothy Machin | Amministratore | Rock House Fownhope HR1 4NT Herefordshire | British | 32520640003 | ||||||
| GREGORY, Trevor John | Amministratore | The Hollies HR2 8JE Llanwarne Herefordshire | United Kingdom | British | 106240790001 | |||||
| HARRINGTON, Robert Arthur | Amministratore | The Field House Back Lane Beckford GL20 7AF Tewkesbury Gloucestershire | British | 9899150004 | ||||||
| HITCHINER, Christopher David | Amministratore | Dunan House Clehonger HR2 9SF Hereford Herefordshire | United Kingdom | British | 71528270003 | |||||
| HODDER, Anthony Mark | Amministratore | New End Cottage Canon Pyon HR4 8NY Hereford | British | 60326120001 | ||||||
| HUGHES, Michael John | Amministratore | 3 Ailsa Road TW1 1QJ Twickenham Middlesex | United Kingdom | British | 101949350001 | |||||
| JAMET, Jean Francois | Amministratore | 3 Sion Hill Place BA1 5SJ Bath | England | French | 83396080001 | |||||
| KIRKHOPE, Ian | Amministratore | Vineyard Hill House 34 Vineyard Road HR1 1TT Hereford | British | 37450060001 | ||||||
| LOW, John Charles | Amministratore | 20-22 Great Titchfield Street W1W 8BE London Elsley Court United Kingdom | United Kingdom | British | 162758370001 | |||||
| OLIVER, Anne Louise | Amministratore | Broadway Park South Gyle Broadway EH12 9JZ Edinburgh 3-4 Scotland | United Kingdom | British | 132910690001 | |||||
| PATERSON, Sean Michael | Amministratore | Broadway Park South Gyle Broadway EH12 9JZ Edinburgh 3-4 Scotland | Scotland | British | 141021760002 | |||||
| PAYNE, William John | Amministratore | Ashby House 1 Bridge Street TW18 4TP Staines Middlesex | Scotland | British | 136005370001 | |||||
| PENNYCOOK, Richard John | Amministratore | Sherington Place MK16 9PD Sherington Buckinghamshire | British | 87825540001 | ||||||
| RUDGARD, John Kennish | Amministratore | Claremont Court Swainshill HR4 7PU Hereford Herefordshire | British | 17349320001 | ||||||
| STEBBINGS, William George | Amministratore | Burghill HR4 7RX Hereford The Forge Herefordshire | British | 129413480001 | ||||||
| STEVENS, Mark | Amministratore | 75 Wallace Mill Gardens EH53 0BG Mid Calder West Lothian | British | 80951870003 | ||||||
| SYMONDS, Neville Richard | Amministratore | Drakewell Stoke Lacy HR7 4HG Bromyard Herefordshire | United Kingdom | British | 9899170001 | |||||
| TEDFORD, Craig | Amministratore | Ashby House 1 Bridge Street TW18 4TP Staines Middlesex | United Kingdom | British | 106867030001 | |||||
| TEMPLEMAN, Miles Howard | Amministratore | Whitmore Farm Church Road GU20 6BH Windlesham Surrey | United Kingdom | British | 15411870001 |
SYMONDS CIDER & ENGLISH WINE COMPANY LIMITED ha ipoteche?
| Classificazione | Date | Stato | Dettagli | |
|---|---|---|---|---|
| Security agreement | Creato il 15 gen 2003 Consegnato il 22 gen 2003 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due or to become due from the group or any member or the group to any creditor under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Brevi particolari All that f/h land k/a the land and buildings lying to the north of eign street, land at the junction of whitecross street and plough lane in the parish of all saints within the city of hereford numbered 111 and 111A, land k/a kings acre sports ground pentland gardens hereford and wells t/n HE9350 (for further properties charged refer to the form 395). fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
| Debenture | Creato il 17 set 1986 Consegnato il 08 ott 1986 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito £5,000,000 and all monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Brevi particolari F/H property at stoke comprising factory premises adjoining land the plough garage and public house. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
Fonte dati
- Companies House del Regno Unito
Il registro ufficiale delle imprese nel Regno Unito, che fornisce l'accesso pubblico alle informazioni sulle imprese, come nomi, indirizzi, amministratori e depositi finanziari. - Licenza: CC0