SYMONDS CIDER & ENGLISH WINE COMPANY LIMITED

SYMONDS CIDER & ENGLISH WINE COMPANY LIMITED

  • Panoramica
  • Riepilogo
  • Scopo
  • Indirizzo
  • Denominazioni precedenti
  • Bilanci
  • Bilancio annuale
  • Deposizioni
  • Amministratori
  • Ipoteche
  • Fonte dati
  • Panoramica

    Nome della societàSYMONDS CIDER & ENGLISH WINE COMPANY LIMITED
    Stato della societàSciolta
    Forma giuridicaSocietà a responsabilità limitata
    Numero di società 01809366
    GiurisdizioneInghilterra/Galles
    Data di costituzione
    Data di cessazione

    Qual è lo scopo di SYMONDS CIDER & ENGLISH WINE COMPANY LIMITED?

    • Produzione di sidro e altri vini di frutta (11030) / Industrie manifatturiere

    Dove si trova SYMONDS CIDER & ENGLISH WINE COMPANY LIMITED?

    Indirizzo della sede legale
    Elsley Court
    20-22 Great Titchfield Street
    W1W 8BE London
    Indirizzo della sede legale non recapitabileNo

    Quali erano i nomi precedenti di SYMONDS CIDER & ENGLISH WINE COMPANY LIMITED?

    Denominazioni sociali precedenti
    Nome della societàDaA
    BASKMIST LIMITED17 apr 198417 apr 1984

    Quali sono gli ultimi bilanci di SYMONDS CIDER & ENGLISH WINE COMPANY LIMITED?

    Ultimi bilanci
    Ultimi bilanci redatti al31 dic 2013

    Qual è lo stato dell'ultimo bilancio annuale per SYMONDS CIDER & ENGLISH WINE COMPANY LIMITED?

    Bilancio annuale
    Ultimo bilancio annuale

    Quali sono le ultime deposizioni per SYMONDS CIDER & ENGLISH WINE COMPANY LIMITED?

    Deposizioni
    DataDescrizioneDocumentoTipo

    Gazzetta Ufficiale finale sciolta per scioglimento volontario

    1 pagineGAZ2(A)

    Prima Gazzetta Ufficiale per lo scioglimento volontario

    1 pagineGAZ1(A)

    Richiesta di cancellazione della società dal registro

    3 pagineDS01

    legacy

    2 pagineSH20

    Stato del capitale al 08 dic 2014

    • Capitale: GBP 1
    4 pagineSH19

    legacy

    2 pagineCAP-SS

    Risoluzioni

    Resolutions
    1 pagineRESOLUTIONS
    Risoluzioni
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    capital

    Risoluzione di riduzione del capitale sociale emesso

    RES06

    Nomina di Mr Josephus Petrus Adrianus Van Der Burg come amministratore in data 06 ott 2014

    2 pagineAP01

    Nomina di Mr Malcolm Dunn come amministratore in data 06 ott 2014

    2 pagineAP01

    Nomina di Mr David Michael Forde come amministratore in data 06 ott 2014

    2 pagineAP01

    Cessazione della carica di Anne Louise Oliver come amministratore in data 06 ott 2014

    1 pagineTM01

    Cessazione della carica di Sean Michael Paterson come amministratore in data 08 ott 2014

    1 pagineTM01

    Cessazione della carica di Anne Louise Oliver come segretario in data 06 ott 2014

    1 pagineTM02

    Bilancio redatto al 31 dic 2013

    10 pagineAA

    Bilancio annuale redatto al 27 mar 2014 con elenco completo degli azionisti

    6 pagineAR01

    Dettagli del segretario cambiati per Mrs Anne Louise Oliver il 01 apr 2014

    1 pagineCH03

    Dettagli del direttore cambiati per Mr Sean Michael Paterson il 01 apr 2014

    2 pagineCH01

    Dettagli del direttore cambiati per Mrs Kelly Taylor-Welsh il 01 apr 2014

    2 pagineCH01

    Dettagli del direttore cambiati per Mrs Anne Louise Oliver il 01 apr 2014

    2 pagineCH01

    Bilancio redatto al 31 dic 2012

    10 pagineAA

    Bilancio annuale redatto al 27 mar 2013 con elenco completo degli azionisti

    4 pagineAR01

    Dettagli del direttore cambiati per Mrs Kelly Taylor-Welsh il 01 ago 2012

    2 pagineCH01

    Bilancio redatto al 31 dic 2011

    10 pagineAA

    Bilancio annuale redatto al 27 mar 2012 con elenco completo degli azionisti

    5 pagineAR01

    Cessazione della carica di John Charles Low come amministratore in data 31 mar 2012

    1 pagineTM01

    Chi sono gli amministratori di SYMONDS CIDER & ENGLISH WINE COMPANY LIMITED?

    Amministratori
    NomeNominato ilDimissioni ilRuoloIndirizzoIdentificazione della societàPaese di residenzaNazionalitàData di nascitaProfessioneNumero
    DUNN, Malcolm James Shiel
    Broadway Park
    South Gyle Broadway
    EH12 9JZ Edinburgh
    3-4
    Scotland
    Amministratore
    Broadway Park
    South Gyle Broadway
    EH12 9JZ Edinburgh
    3-4
    Scotland
    ScotlandBritish191401290001
    FORDE, David Michael
    Broadway Park
    South Gyle Broadway
    EH12 9JZ Edinburgh
    3-4
    Scotland
    Amministratore
    Broadway Park
    South Gyle Broadway
    EH12 9JZ Edinburgh
    3-4
    Scotland
    IrelandIrish178655370001
    TAYLOR-WELSH, Kelly
    Broadway Park
    South Gyle Broadway
    EH12 9JZ Edinburgh
    3-4
    Scotland
    Amministratore
    Broadway Park
    South Gyle Broadway
    EH12 9JZ Edinburgh
    3-4
    Scotland
    United KingdomBritish167915590003
    VAN DER BURG, Josephus Petrus Adrianus
    Broadway Park
    South Gyle Broadway
    EH12 9JZ Edinburgh
    3-4
    Scotland
    Amministratore
    Broadway Park
    South Gyle Broadway
    EH12 9JZ Edinburgh
    3-4
    Scotland
    ScotlandDutch167853370002
    AVES, Simon Howard
    Swanston Gardens
    EH10 1DJ Edinburgh
    5
    Segretario
    Swanston Gardens
    EH10 1DJ Edinburgh
    5
    British132259650001
    OLIVER, Anne Louise
    Broadway Park
    South Gyle Broadway
    EH12 9JZ Edinburgh
    3-4
    Scotland
    Segretario
    Broadway Park
    South Gyle Broadway
    EH12 9JZ Edinburgh
    3-4
    Scotland
    British132910690001
    STEBBINGS, William George
    Burghill
    HR4 7RX Hereford
    The Forge
    Herefordshire
    Segretario
    Burghill
    HR4 7RX Hereford
    The Forge
    Herefordshire
    British129413480001
    STEVENS, Mark
    75 Wallace Mill Gardens
    EH53 0BG Mid Calder
    West Lothian
    Segretario
    75 Wallace Mill Gardens
    EH53 0BG Mid Calder
    West Lothian
    British80951870003
    AITCHISON, Nicholas Martin Leslie
    Lower Barn
    Llancloudy
    HR2 8QR Hereford
    Herefordshire
    Amministratore
    Lower Barn
    Llancloudy
    HR2 8QR Hereford
    Herefordshire
    British6195750001
    AVES, Simon Howard
    Swanston Gardens
    EH10 1DJ Edinburgh
    5
    Amministratore
    Swanston Gardens
    EH10 1DJ Edinburgh
    5
    ScotlandBritish132259650001
    BOND, Denis Joseph Christopher
    Cricket Cottage
    Churchfield Cradley
    Malvern
    Worcestershire
    Amministratore
    Cricket Cottage
    Churchfield Cradley
    Malvern
    Worcestershire
    British26007550001
    BROWN, Colin Carlyle Campbell
    Little Bower
    10 Nuns Walk
    GU25 4RT Virginia Water
    Surrey
    Amministratore
    Little Bower
    10 Nuns Walk
    GU25 4RT Virginia Water
    Surrey
    British61755350001
    CRAWSHAY, William John Julian
    The Old Vicarage
    NE41 8AT Wylam
    Northumberland
    Amministratore
    The Old Vicarage
    NE41 8AT Wylam
    Northumberland
    United KingdomBritish79182280001
    DOOBAR, Mark Simon
    105 Canada Way
    Lower Wick
    WR2 4DG Worcester
    Amministratore
    105 Canada Way
    Lower Wick
    WR2 4DG Worcester
    British34501450002
    EGGLETON, Jonathan Philip
    Court Leet
    Church Road
    GL17 0LL Longhope
    Gloucestershire
    Amministratore
    Court Leet
    Church Road
    GL17 0LL Longhope
    Gloucestershire
    British83396140001
    FREER, Nigel
    Stoneham House
    Maund Common Bodenham
    HR1 3JB Hereford
    Herefordshire
    Amministratore
    Stoneham House
    Maund Common Bodenham
    HR1 3JB Hereford
    Herefordshire
    British59149820001
    FURSE, Timothy Machin
    Rock House
    Fownhope
    HR1 4NT Herefordshire
    Amministratore
    Rock House
    Fownhope
    HR1 4NT Herefordshire
    British32520640003
    GREGORY, Trevor John
    The Hollies
    HR2 8JE Llanwarne
    Herefordshire
    Amministratore
    The Hollies
    HR2 8JE Llanwarne
    Herefordshire
    United KingdomBritish106240790001
    HARRINGTON, Robert Arthur
    The Field House
    Back Lane Beckford
    GL20 7AF Tewkesbury
    Gloucestershire
    Amministratore
    The Field House
    Back Lane Beckford
    GL20 7AF Tewkesbury
    Gloucestershire
    British9899150004
    HITCHINER, Christopher David
    Dunan House
    Clehonger
    HR2 9SF Hereford
    Herefordshire
    Amministratore
    Dunan House
    Clehonger
    HR2 9SF Hereford
    Herefordshire
    United KingdomBritish71528270003
    HODDER, Anthony Mark
    New End Cottage
    Canon Pyon
    HR4 8NY Hereford
    Amministratore
    New End Cottage
    Canon Pyon
    HR4 8NY Hereford
    British60326120001
    HUGHES, Michael John
    3 Ailsa Road
    TW1 1QJ Twickenham
    Middlesex
    Amministratore
    3 Ailsa Road
    TW1 1QJ Twickenham
    Middlesex
    United KingdomBritish101949350001
    JAMET, Jean Francois
    3 Sion Hill Place
    BA1 5SJ Bath
    Amministratore
    3 Sion Hill Place
    BA1 5SJ Bath
    EnglandFrench83396080001
    KIRKHOPE, Ian
    Vineyard Hill House
    34 Vineyard Road
    HR1 1TT Hereford
    Amministratore
    Vineyard Hill House
    34 Vineyard Road
    HR1 1TT Hereford
    British37450060001
    LOW, John Charles
    20-22 Great Titchfield Street
    W1W 8BE London
    Elsley Court
    United Kingdom
    Amministratore
    20-22 Great Titchfield Street
    W1W 8BE London
    Elsley Court
    United Kingdom
    United KingdomBritish162758370001
    OLIVER, Anne Louise
    Broadway Park
    South Gyle Broadway
    EH12 9JZ Edinburgh
    3-4
    Scotland
    Amministratore
    Broadway Park
    South Gyle Broadway
    EH12 9JZ Edinburgh
    3-4
    Scotland
    United KingdomBritish132910690001
    PATERSON, Sean Michael
    Broadway Park
    South Gyle Broadway
    EH12 9JZ Edinburgh
    3-4
    Scotland
    Amministratore
    Broadway Park
    South Gyle Broadway
    EH12 9JZ Edinburgh
    3-4
    Scotland
    ScotlandBritish141021760002
    PAYNE, William John
    Ashby House
    1 Bridge Street
    TW18 4TP Staines
    Middlesex
    Amministratore
    Ashby House
    1 Bridge Street
    TW18 4TP Staines
    Middlesex
    ScotlandBritish136005370001
    PENNYCOOK, Richard John
    Sherington Place
    MK16 9PD Sherington
    Buckinghamshire
    Amministratore
    Sherington Place
    MK16 9PD Sherington
    Buckinghamshire
    British87825540001
    RUDGARD, John Kennish
    Claremont Court
    Swainshill
    HR4 7PU Hereford
    Herefordshire
    Amministratore
    Claremont Court
    Swainshill
    HR4 7PU Hereford
    Herefordshire
    British17349320001
    STEBBINGS, William George
    Burghill
    HR4 7RX Hereford
    The Forge
    Herefordshire
    Amministratore
    Burghill
    HR4 7RX Hereford
    The Forge
    Herefordshire
    British129413480001
    STEVENS, Mark
    75 Wallace Mill Gardens
    EH53 0BG Mid Calder
    West Lothian
    Amministratore
    75 Wallace Mill Gardens
    EH53 0BG Mid Calder
    West Lothian
    British80951870003
    SYMONDS, Neville Richard
    Drakewell
    Stoke Lacy
    HR7 4HG Bromyard
    Herefordshire
    Amministratore
    Drakewell
    Stoke Lacy
    HR7 4HG Bromyard
    Herefordshire
    United KingdomBritish9899170001
    TEDFORD, Craig
    Ashby House
    1 Bridge Street
    TW18 4TP Staines
    Middlesex
    Amministratore
    Ashby House
    1 Bridge Street
    TW18 4TP Staines
    Middlesex
    United KingdomBritish106867030001
    TEMPLEMAN, Miles Howard
    Whitmore Farm Church Road
    GU20 6BH Windlesham
    Surrey
    Amministratore
    Whitmore Farm Church Road
    GU20 6BH Windlesham
    Surrey
    United KingdomBritish15411870001

    SYMONDS CIDER & ENGLISH WINE COMPANY LIMITED ha ipoteche?

    Ipoteche
    ClassificazioneDateStatoDettagli
    Security agreement
    Creato il 15 gen 2003
    Consegnato il 22 gen 2003
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the group or any member or the group to any creditor under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    All that f/h land k/a the land and buildings lying to the north of eign street, land at the junction of whitecross street and plough lane in the parish of all saints within the city of hereford numbered 111 and 111A, land k/a kings acre sports ground pentland gardens hereford and wells t/n HE9350 (for further properties charged refer to the form 395). fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • The Royal Bank of Scotland PLC, as Intercreditor Agent
    Transazioni
    • 22 gen 2003Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 30 lug 2003Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Debenture
    Creato il 17 set 1986
    Consegnato il 08 ott 1986
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    £5,000,000 and all monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    F/H property at stoke comprising factory premises adjoining land the plough garage and public house. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Greenhall Whitley PLC
    Transazioni
    • 08 ott 1986Registrazione di un'ipoteca
    • 25 ago 1988Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)

    Fonte dati

    • Companies House del Regno Unito
      Il registro ufficiale delle imprese nel Regno Unito, che fornisce l'accesso pubblico alle informazioni sulle imprese, come nomi, indirizzi, amministratori e depositi finanziari.
    • Licenza: CC0