LEASECONTRACTS LIMITED

LEASECONTRACTS LIMITED

  • Panoramica
  • Riepilogo
  • Scopo
  • Indirizzo
  • Denominazioni precedenti
  • Bilanci
  • Deposizioni
  • Amministratori
  • Persone con controllo significativo
  • Ipoteche
  • Insolvenza
  • Fonte dati
  • Panoramica

    Nome della societàLEASECONTRACTS LIMITED
    Stato della societàSciolta
    Forma giuridicaSocietà a responsabilità limitata
    Numero di società 01810100
    GiurisdizioneInghilterra/Galles
    Data di costituzione
    Data di cessazione

    Qual è lo scopo di LEASECONTRACTS LIMITED?

    • Vendita al dettaglio di autovetture nuove (45111) / Commercio all'ingrosso e al dettaglio; riparazione di autoveicoli e motocicli

    Dove si trova LEASECONTRACTS LIMITED?

    Indirizzo della sede legale
    1 More London Place
    SE1 2AF London
    Indirizzo della sede legale non recapitabileNo

    Quali erano i nomi precedenti di LEASECONTRACTS LIMITED?

    Denominazioni sociali precedenti
    Nome della societàDaA
    JORDANS 160 PUBLIC LIMITED COMPANY18 apr 198418 apr 1984

    Quali sono gli ultimi bilanci di LEASECONTRACTS LIMITED?

    Ultimi bilanci
    Ultimi bilanci redatti al31 dic 2017

    Quali sono le ultime deposizioni per LEASECONTRACTS LIMITED?

    Deposizioni
    DataDescrizioneDocumentoTipo

    Gazzetta ufficiale finale sciolta a seguito di liquidazione

    1 pagineGAZ2

    Ritorno della riunione finale in una liquidazione volontaria dei membri

    11 pagineLIQ13

    Dichiarazione dei ricevimenti e dei pagamenti dei liquidatori fino a 25 set 2023

    9 pagineLIQ03

    Dichiarazione dei ricevimenti e dei pagamenti dei liquidatori fino a 25 set 2022

    9 pagineLIQ03

    Dichiarazione dei ricevimenti e dei pagamenti dei liquidatori fino a 25 set 2021

    9 pagineLIQ03

    Dichiarazione dei ricevimenti e dei pagamenti dei liquidatori fino a 25 set 2020

    9 pagineLIQ03

    I registri sono stati trasferiti al luogo di ispezione registrato Oakwood Corporate Services Limited 3rd Floor 1 Ashley Road Altrincham Cheshire WA14 2DT

    2 pagineAD03

    L'indirizzo di ispezione del registro è stato modificato da The Ark 201 Talgarth Road London W6 8BJ United Kingdom a Oakwood Corporate Services Limited 3rd Floor 1 Ashley Road Altrincham Cheshire WA14 2DT

    2 pagineAD02

    Indirizzo della sede legale modificato da 3rd Floor 1 Ashley Road Altrincham Cheshire WA14 2DT United Kingdom a 1 More London Place London SE1 2AF in data 17 ott 2019

    2 pagineAD01

    Dichiarazione di solvibilità

    5 pagineLIQ01

    Nomina di un liquidatore volontario

    3 pagine600

    Risoluzioni

    Resolutions
    1 pagineRESOLUTIONS
    Risoluzioni
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    liquidation

    Risoluzione speciale per la liquidazione al 26 set 2019

    LRESSP

    Nomina di Oakwood Corporate Secretary Limited come segretario in data 23 lug 2019

    2 pagineAP04

    Notifica di Key Leasing Limited come persona con controllo significativo il 23 lug 2019

    2 paginePSC02

    Cessazione di Ige Usa Investments Limited come persona con controllo significativo il 23 lug 2019

    1 paginePSC07

    Dichiarazione di conformità presentata il 11 giu 2019 con aggiornamenti

    4 pagineCS01

    Dettagli del direttore cambiati per Norris Andrew Geldard il 04 feb 2019

    2 pagineCH01

    Modifica dei dettagli di Ige Usa Investments come persona con controllo significativo il 23 nov 2018

    2 paginePSC05

    Cessazione della carica di Anthony William Greenway come amministratore in data 30 set 2018

    1 pagineTM01

    Nomina di Norris Andrew Geldard come amministratore in data 10 set 2018

    2 pagineAP01

    Nomina di Mr Paul Stewart Girling come amministratore in data 10 set 2018

    2 pagineAP01

    Bilancio redatto al 31 dic 2017

    20 pagineAA

    Indirizzo della sede legale modificato da The Ark 201 Talgarth Road London W6 8BJ United Kingdom a 3rd Floor 1 Ashley Road Altrincham Cheshire WA14 2DT in data 17 ago 2018

    1 pagineAD01

    Dichiarazione di conformità presentata il 11 giu 2018 con aggiornamenti

    5 pagineCS01

    Notifica di Ige Usa Investments come persona con controllo significativo il 06 apr 2016

    2 paginePSC02

    Chi sono gli amministratori di LEASECONTRACTS LIMITED?

    Amministratori
    NomeNominato ilDimissioni ilRuoloIndirizzoIdentificazione della societàPaese di residenzaNazionalitàData di nascitaProfessioneNumero
    OAKWOOD CORPORATE SECRETARY LIMITED
    1 Ashley Road
    WA14 2DT Altrincham
    3rd Floor
    Cheshire
    United Kingdom
    Segretario
    1 Ashley Road
    WA14 2DT Altrincham
    3rd Floor
    Cheshire
    United Kingdom
    Tipo di documento di identificazioneSocietà a responsabilità limitata del Regno Unito
    Numero di registrazione7038430
    146358090001
    GELDARD, Norris Andrew
    Century Way, Thorpe Park Business Park
    Colton
    LS15 8ZA Leeds
    1200
    West Yorkshire
    United Kingdom
    Amministratore
    Century Way, Thorpe Park Business Park
    Colton
    LS15 8ZA Leeds
    1200
    West Yorkshire
    United Kingdom
    United KingdomBritish244576750001
    GIRLING, Paul Stewart
    More London Place
    SE1 2AF London
    1
    Amministratore
    More London Place
    SE1 2AF London
    1
    United KingdomBritish225432580001
    ABBOTT, Courtenay
    Old Hall Road
    M33 2GS Sale, Cheshire
    Dovecote House
    England
    United Kingdom
    Segretario
    Old Hall Road
    M33 2GS Sale, Cheshire
    Dovecote House
    England
    United Kingdom
    172560620001
    COOK, Michael Frederick
    Cracknut Hill House Haye Lane
    Mappleborough Green
    B80 7DS Studley
    Warwickshire
    Segretario
    Cracknut Hill House Haye Lane
    Mappleborough Green
    B80 7DS Studley
    Warwickshire
    British45103500001
    ESSEX, Alicia
    Old Hall Road
    Sale
    M33 2GZ Cheshire
    Segretario
    Old Hall Road
    Sale
    M33 2GZ Cheshire
    British55569560002
    FRENCH, Ann
    201 Talgarth Road
    W6 8BJ London
    The Ark
    United Kingdom
    Segretario
    201 Talgarth Road
    W6 8BJ London
    The Ark
    United Kingdom
    161504050001
    JOHNSON, Paul Robert
    Old Hall Road
    M33 2GS Sale, Cheshire
    Dovecote House
    England
    United Kingdom
    Segretario
    Old Hall Road
    M33 2GS Sale, Cheshire
    Dovecote House
    England
    United Kingdom
    British106143590001
    KERSHAW, Simon John
    40 Sandacre Road
    M23 1AP Manchester
    Lancashire
    Segretario
    40 Sandacre Road
    M23 1AP Manchester
    Lancashire
    British106236300001
    PATMORE, Ian Robert
    Spring Bank Farm
    Lodge Lane
    OL13 0BJ Bacup
    Lancashire
    Segretario
    Spring Bank Farm
    Lodge Lane
    OL13 0BJ Bacup
    Lancashire
    British64498630002
    PEERMOHAMED, Zahra
    Old Hall Road
    M33 2GS Sale, Cheshire
    Dovecote House
    England
    Segretario
    Old Hall Road
    M33 2GS Sale, Cheshire
    Dovecote House
    England
    192967230001
    RYLATT, Diane
    Little Bouts Farmhouse Bouts Lane
    Inkberrow
    WR7 4HP Worcester
    Worcestershire
    Segretario
    Little Bouts Farmhouse Bouts Lane
    Inkberrow
    WR7 4HP Worcester
    Worcestershire
    British46068950001
    TAYLOR, Timothy John
    4 Thorngrove Road
    SK9 1DD Wilmslow
    Cheshire
    Segretario
    4 Thorngrove Road
    SK9 1DD Wilmslow
    Cheshire
    British42497260001
    A G SECRETARIAL LIMITED
    100 Barbirolli Square
    M2 3AB Manchester
    Segretario
    100 Barbirolli Square
    M2 3AB Manchester
    90084920001
    COBBETTS (SECRETARIAL) LIMITED
    Ship Canal House
    King Street
    M2 4WB Manchester
    Segretario
    Ship Canal House
    King Street
    M2 4WB Manchester
    86546820001
    ANDERSON, Roger
    12 Blueberry Road
    Bowdon
    WA14 3LT Altrincham
    Cheshire
    Amministratore
    12 Blueberry Road
    Bowdon
    WA14 3LT Altrincham
    Cheshire
    British60138290001
    BECQUE, Geoffrey Frederick
    Clayfield House
    Danzey-Green Tanworth In Arden
    B94 5BG Solihull
    West Midlands
    Amministratore
    Clayfield House
    Danzey-Green Tanworth In Arden
    B94 5BG Solihull
    West Midlands
    United KingdomBritish14428770001
    BURR, Jonathan Charles
    15 Leicester Road
    Hale
    WA15 9QA Altrincham
    Cheshire
    Amministratore
    15 Leicester Road
    Hale
    WA15 9QA Altrincham
    Cheshire
    EnglandBritish49902210001
    CHAPMAN, Mark Andrew
    3 Fern Bank
    WA11 8DZ Rainford
    Merseyside
    Amministratore
    3 Fern Bank
    WA11 8DZ Rainford
    Merseyside
    British54283410002
    CHAPMAN, Mark Andrew
    16 Harrison Drive
    WA11 8HZ Rainford
    Merseyside
    Amministratore
    16 Harrison Drive
    WA11 8HZ Rainford
    Merseyside
    British54283410001
    COOK, Michael Frederick
    Cracknut Hill House Haye Lane
    Mappleborough Green
    B80 7DS Studley
    Warwickshire
    Amministratore
    Cracknut Hill House Haye Lane
    Mappleborough Green
    B80 7DS Studley
    Warwickshire
    EnglandBritish45103500001
    D'ADDA, Alessandro Pietro
    Thatched Lodge Bell Bank
    High St Welford On Avon
    CV37 8EA Stratford Upon Avon
    Warwickshire
    Amministratore
    Thatched Lodge Bell Bank
    High St Welford On Avon
    CV37 8EA Stratford Upon Avon
    Warwickshire
    EnglandBritish47772540001
    DOWLING, Christopher Bruce
    Rutland House
    Rutland Gardens
    SW7 1BX Knightsbridge
    London
    Amministratore
    Rutland House
    Rutland Gardens
    SW7 1BX Knightsbridge
    London
    Australian28868820001
    DUFF, Paul Anthony
    6 Newby Drive
    Gatley
    SK8 4EJ Cheadle
    Cheshire
    Amministratore
    6 Newby Drive
    Gatley
    SK8 4EJ Cheadle
    Cheshire
    British122035530001
    FARRAR, Daniel
    The Coach House Gravel Lane
    SK9 6EG Wilmslow
    Cheshire
    Amministratore
    The Coach House Gravel Lane
    SK9 6EG Wilmslow
    Cheshire
    British42497200001
    FITZPATRICK, Hugh Alan Taylor
    Old Hall Road
    M33 2GS Sale, Cheshire
    Dovecote House
    England
    United Kingdom
    Amministratore
    Old Hall Road
    M33 2GS Sale, Cheshire
    Dovecote House
    England
    United Kingdom
    United KingdomBritish139406230001
    FORD, Toby Duncan
    Trinity Square
    23-59 Staines Road
    TW3 3HF Hounslow
    Meridian
    Middlesex
    Amministratore
    Trinity Square
    23-59 Staines Road
    TW3 3HF Hounslow
    Meridian
    Middlesex
    United KingdomBritish148654320001
    GREEN, Richard William
    Richborough House
    Sandy Lane Sunningdale
    SL5 0ND Ascot
    Berkshire
    Amministratore
    Richborough House
    Sandy Lane Sunningdale
    SL5 0ND Ascot
    Berkshire
    British121346530001
    GREENWAY, Anthony William
    1 Ashley Road
    WA14 2DT Altrincham
    3rd Floor
    Cheshire
    United Kingdom
    Amministratore
    1 Ashley Road
    WA14 2DT Altrincham
    3rd Floor
    Cheshire
    United Kingdom
    United KingdomBritish202871130001
    HUDDART, Steven John
    Old Hall Road
    M33 2GS Sale, Cheshire
    Dovecote House
    England
    Amministratore
    Old Hall Road
    M33 2GS Sale, Cheshire
    Dovecote House
    England
    EnglandEnglish191546760001
    JEANS, Roderick Manning
    1 Penelope Gardens
    Wickhamford
    WR11 6SG Evesham
    Worcestershire
    Amministratore
    1 Penelope Gardens
    Wickhamford
    WR11 6SG Evesham
    Worcestershire
    British50601570001
    JENKINS, John Michael
    Trinity Square
    23/59 Staines Road
    TW3 3HF Hounslow
    Meridian
    Middlesex
    England
    Amministratore
    Trinity Square
    23/59 Staines Road
    TW3 3HF Hounslow
    Meridian
    Middlesex
    England
    EnglandBritish115008010001
    KILLEEN, Gary Francis Paul
    Old Hall Road
    M33 2GS Sale, Cheshire
    Dovecote House
    England
    United Kingdom
    Amministratore
    Old Hall Road
    M33 2GS Sale, Cheshire
    Dovecote House
    England
    United Kingdom
    EnglandEnglish81330540001
    LANGDON, Michael Robert Finch
    29 Sumner Place
    SW7 3NT London
    Amministratore
    29 Sumner Place
    SW7 3NT London
    EnglandBritish1483050001
    LOMAS, Paul John
    12 Burwardsley Way
    Kingsmead
    CW9 8WN Northwich
    Cheshire
    Amministratore
    12 Burwardsley Way
    Kingsmead
    CW9 8WN Northwich
    Cheshire
    United KingdomBritish127596100001

    Chi sono le persone con controllo significativo di LEASECONTRACTS LIMITED?

    Persone con controllo significativo
    NomeNotificato ilIndirizzoCessato
    1 Ashley Road
    WA14 2DT Altrincham
    3rd Floor
    Cheshire
    United Kingdom
    23 lug 2019
    1 Ashley Road
    WA14 2DT Altrincham
    3rd Floor
    Cheshire
    United Kingdom
    No
    Forma giuridicaLimited By Shares
    Paese di registrazioneEngland
    Autorità legaleUnited Kingdom (England)
    Luogo di registrazioneCompanies House
    Numero di registrazione1500252
    Natura del controllo
    • La persona possiede, direttamente o indirettamente, più del 75% delle azioni della società.
    • La persona detiene, direttamente o indirettamente, più del 75% dei diritti di voto nella società.
    • La persona ha il diritto, direttamente o indirettamente, di nominare o rimuovere la maggioranza del consiglio di amministrazione della società.
    1 Ashley Road
    WA14 2DT Altrincham
    3rd Floor
    Cheshire
    United Kingdom
    06 apr 2016
    1 Ashley Road
    WA14 2DT Altrincham
    3rd Floor
    Cheshire
    United Kingdom
    Forma giuridicaLimited By Shares
    Paese di registrazioneEngland And Wales
    Autorità legaleUnited Kingdom (England And Wales)
    Luogo di registrazioneCompanies House
    Numero di registrazione3255766
    Natura del controllo
    • La persona possiede, direttamente o indirettamente, più del 75% delle azioni della società.
    • La persona detiene, direttamente o indirettamente, più del 75% dei diritti di voto nella società.
    • La persona ha il diritto, direttamente o indirettamente, di nominare o rimuovere la maggioranza del consiglio di amministrazione della società.

    LEASECONTRACTS LIMITED ha ipoteche?

    Ipoteche
    ClassificazioneDateStatoDettagli
    Charge agreement
    Creato il 02 ago 1995
    Consegnato il 08 ago 1995
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    £404,822.57 and all other monies due from the company to the chargee pursuant to the terms of the charge agreement
    Brevi particolari
    All the rights and interests of the company under the agreements date 7/6/95 contract no 1030474 vehicle hire agreement model vauxhall brava 2.5I a/c no 34. see the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Lloyds Bowmaker Limited
    Transazioni
    • 08 ago 1995Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 18 mar 2003Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Charge agreement
    Creato il 02 ago 1995
    Consegnato il 08 ago 1995
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    £45,553.63 and all other monies due from the company to the chargee pursuant to the terms of the charge agreement
    Brevi particolari
    All the rights and interests of the company under the agreements :- date 2.6.95 contract no 1030728 vehicle hire agreement model ford transit 2.5 regn no M289 yhj a/c/no 22. see the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Lloyds Bowmaker Limited
    Transazioni
    • 08 ago 1995Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 18 mar 2003Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Charge agreement
    Creato il 02 ago 1995
    Consegnato il 08 ago 1995
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    £160,099.17 and all monies due or to become due from the company to the chargee under the charge agreement
    Brevi particolari
    All the rights and interests of the company under the agreements. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Lloyds Bowmaker Limited
    Transazioni
    • 08 ago 1995Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 18 mar 2003Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Charge agreement
    Creato il 02 ago 1995
    Consegnato il 08 ago 1995
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    £349,787.92 and all monies due or to become due from the company to the chargee under the charge agreement
    Brevi particolari
    All the rights title and interests of the company under the agreements. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Lloyds Bowmaker Limited
    Transazioni
    • 08 ago 1995Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 18 mar 2003Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Charge agreement
    Creato il 02 ago 1995
    Consegnato il 08 ago 1995
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    £87,116.29 and all monies due or to become due from the company to the chargee under the charge agreement
    Brevi particolari
    All the rights and interests of the company under the agreements. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Lloyds Bowmaker Limited
    Transazioni
    • 08 ago 1995Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 18 mar 2003Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Charge agreement
    Creato il 02 ago 1995
    Consegnato il 08 ago 1995
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    £13,933.14 and all monies due or to become due from the company to the chargee under the charge agreement
    Brevi particolari
    All the rights of the company under the agreements specified. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Lloyds Bowmaker Limited
    Transazioni
    • 08 ago 1995Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 18 mar 2003Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Charge agreement
    Creato il 02 ago 1995
    Consegnato il 08 ago 1995
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    £27,772.02 and all monies due or to become due from the company to the chargee under the charge agreement
    Brevi particolari
    All the rights and interests of the company under the agreements specified. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Lloyds Bowmaker Limited
    Transazioni
    • 08 ago 1995Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 18 mar 2003Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    First charge
    Creato il 28 giu 1995
    Consegnato il 12 lug 1995
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the facility letter dated 12TH december 1994 and/or this charge
    Brevi particolari
    The company assigns and charges to the bank by way of first fixed legal charge:- (I) all the benefits rights and title of the company in the contracts; and (ii) each and every motor vehicle from time to time subject of the contracts (the "motor vehicles"). See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Singer & Friedlander Limited
    Transazioni
    • 12 lug 1995Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 03 set 2004Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Certificate of assignment
    Creato il 26 giu 1995
    Consegnato il 01 lug 1995
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee pursuant to the terms of a hire purchase agreement dated 3/11/94
    Brevi particolari
    All rights benefits and interest present and future in and to the sub-hire agreements :- sub-hirer sony united kingdom limited ford mondeo 2OI glx h/back regn no M301 mpd. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Sovereign Finances PLC
    Transazioni
    • 01 lug 1995Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 03 set 2004Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Certificate of assignment
    Creato il 04 mag 1995
    Consegnato il 09 mag 1995
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee pursuant to the terms of a hire purchase agreement dated 3/11/94
    Brevi particolari
    All rights benefits and interest present and future in and to sub-hire agreements made between various sub-hirers. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Sovereign Finance PLC
    Transazioni
    • 09 mag 1995Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 03 set 2004Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Certificate of assignment
    Creato il 19 apr 1995
    Consegnato il 26 apr 1995
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee pursuant to the terms of the agreemnts
    Brevi particolari
    All monies due and to become due to the company under the sub-hire agreements the benefit of all guarantees :- customer no 021766 schedule no 000015 agreement no 01/308/01/513884 reg no M29 eea rover 214SE1 41 customer ref 1028472. see the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Nws Bank PLC
    Transazioni
    • 26 apr 1995Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 03 set 2004Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Charge agreement
    Creato il 23 mar 1995
    Consegnato il 08 apr 1995
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    £222,479.54 and all other monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the charge agreement
    Brevi particolari
    All the rights title and interest of the company in the attached schedule contract no 1027675 agreement vehicle contract purchase reg no M217 odp make rover 2.0I. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Lloyds Bowmaker Limited
    Transazioni
    • 08 apr 1995Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 18 mar 2003Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Charge agreement
    Creato il 23 mar 1995
    Consegnato il 29 mar 1995
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    £221,528.88 and all other moneys due or to become due from the company to lloyds bowmaker limited under the terms of the agreement
    Brevi particolari
    All the rights title and interest of the company in and under the agreements ,as specified in the schedule. All monies now or hereafter to become payable under the said agreements, the vehicles comprised in and the subject of the said agreements,all monies from time to time payable under any insurance payable in respect of the said vehicles. Please see doc for further details,.
    Persone aventi diritto
    • Lloyds Bowmaker Limited
    Transazioni
    • 29 mar 1995Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 29 mar 1995Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 18 mar 2003Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Charge agreement
    Creato il 23 mar 1995
    Consegnato il 29 mar 1995
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    £75,555.25 and all other monies due or to become due from the company to lloyds bowmaker limited under or pursuant to the terms of the agreement
    Brevi particolari
    All rights title and interest in and under the said agreements ,all monies now or hereafter to become payable under the agreements, the vehicles comprised in and the subject of the said agreements, all monies from time to time payable under the insurance in respect of the said vehicles. Please see doc for further details,.
    Persone aventi diritto
    • Lloyds Bowmaker Limited
    Transazioni
    • 29 mar 1995Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 18 mar 2003Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Charge agreement
    Creato il 23 mar 1995
    Consegnato il 29 mar 1995
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    £229,169.13 together with all other monies due or to become due from the company to lloyds bowmaker limited under the terms of the agreement
    Brevi particolari
    Specific charge over all the rights and interests of the company under the agreements specified in the schedule, all monies now or hereafter to become payable under the said agreements , the vehicles comprised in and the subject of the said agreements, all insurances payable in respect of the said vehicles. Please see doc for further details.
    Persone aventi diritto
    • Lloyds Bowmaker Limited
    Transazioni
    • 29 mar 1995Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 18 mar 2003Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Certificate of assignment
    Creato il 09 dic 1994
    Consegnato il 22 dic 1994
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee pursuant to the terms of the agreements
    Brevi particolari
    All monies due and to become due to the company under the sub-hire agreements specified in the schedule to the form 395. see the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Nws Bank PLC
    Transazioni
    • 22 dic 1994Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 03 set 2004Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Master assignment
    Creato il 05 dic 1994
    Consegnato il 22 dic 1994
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee pursuant to the terms of the agrements
    Brevi particolari
    All monies due and to become due to the company under the sub-hire agreements specified in the schedules attached to the form 395 entered into pursuant to the master assignment.
    Persone aventi diritto
    • Nws Bank PLC
    Transazioni
    • 22 dic 1994Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 03 set 2004Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Charge agreement
    Creato il 25 nov 1994
    Consegnato il 02 dic 1994
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    £359,353.33 and all other monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the charge agreement
    Brevi particolari
    All the rights and interests of the company under the agreements date-22.9.94, Contract no.-1025575, Type of agreement-vehicle contract purchase, period of agt-48, reg no-M113 xow, make/model-honda civic. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Lloyds Bowmaker Limited
    Transazioni
    • 02 dic 1994Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 18 mar 2003Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Charge agreement
    Creato il 25 nov 1994
    Consegnato il 02 dic 1994
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    £135,919.45 and all other monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the charge
    Brevi particolari
    All the rights and interests of the company under the agreements date-8.11.94, Contract no-1025865, type of agreement-vehicle contract purchase, period of agt-42, reg no-M108 njb, make/model-renault 19. see the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Lloyds Bowmaker Limited
    Transazioni
    • 02 dic 1994Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 18 mar 2003Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Charge agreement
    Creato il 25 nov 1994
    Consegnato il 02 dic 1994
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    £36,467.67 and all other monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the charge agreement
    Brevi particolari
    All the rights and interests of the company under the agreements date-25.10.94, Contract no.-1026204, Type of agreement-schedule to master agreement, period of agt-12, reg no.-M791 jpf, make/model-rover 200 1.4I. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Lloyds Bowmaker Limited
    Transazioni
    • 02 dic 1994Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 18 mar 2003Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Charge agreement
    Creato il 25 nov 1994
    Consegnato il 02 dic 1994
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    £58,680.10 and all other monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the charge agreement
    Brevi particolari
    All the rights and interests of the company under the agreements date-28.9.94, Contract no.-1026224, Type of agreement-vehicle hire agreement, period of agt-24, reg no.-L416 kto, make/model-vw passat. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Lloyds Bowmaker Limited
    Transazioni
    • 02 dic 1994Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 18 mar 2003Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Charge agreement
    Creato il 25 nov 1994
    Consegnato il 02 dic 1994
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    £47,047.49 and all other monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the charge agreement
    Brevi particolari
    All the rights and interests of the company under the agreements date-18.10.94, Contract no-1026870, type of agreement-vehicle hire agreement, period of agt-28, reg no.-L753JCF, make/model-vauxhall frontera. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Lloyds Bowmaker Limited
    Transazioni
    • 02 dic 1994Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 18 mar 2003Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Charge agreement
    Creato il 25 nov 1994
    Consegnato il 02 dic 1994
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    £270,688.25 and all other monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the charge agreement
    Brevi particolari
    All the rights and interests of the company under the agreements date-9.11.94, Contract no.-1027231, Type of agreement-vehicle hire agreement, period of agt-36, reg no.-L688 sav, make/model-rover 600 2.01. see the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Lloyds Bowmaker Limited
    Transazioni
    • 02 dic 1994Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 18 mar 2003Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Master assignment and certificte of assignment
    Creato il 03 nov 1994
    Consegnato il 04 nov 1994
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of a hire purchase agreement of even date
    Brevi particolari
    All rights benefit and interest present and future in and 70 sub-hiring agreements :- ford granada 2.01 scorpio 4 dr saloon sin auto. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Sovereign Finance PLC
    Transazioni
    • 04 nov 1994Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 03 set 2004Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Charge agreement
    Creato il 13 lug 1994
    Consegnato il 16 lug 1994
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    £107,344.53 and all other monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the charge agreement.
    Brevi particolari
    All the rights and interests of the company under the agreements specified in the attached schedule. All monies now or hereafter to become payable under the said agreements. The vehicles comprised in and the subject of the said agreements as specified in the said schedule, and all monies from time to time payable under any insurance in respect of the said vehicles. The terms applicable to the charge agreement restrict the creation of any other charge whatsoever over the charged property.
    Persone aventi diritto
    • Lloyds Bowmaker Limited
    Transazioni
    • 16 lug 1994Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 18 mar 2003Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)

    LEASECONTRACTS LIMITED ha procedimenti di insolvenza?

    Numero di praticaDateTipoProfessionistiAltro
    1
    DataTipo
    11 giu 2024Data prevista di scioglimento
    26 set 2019Inizio della liquidazione
    Liquidazione volontaria dei soci
    NomeRuoloIndirizzoNominato ilCessato il
    Samantha Keen
    1 More London Place
    SE1 2AF London
    Praticante
    1 More London Place
    SE1 2AF London
    Richard Barker
    1 More London Place
    SE1 2AF London
    Praticante
    1 More London Place
    SE1 2AF London

    Fonte dati

    • Companies House del Regno Unito
      Il registro ufficiale delle imprese nel Regno Unito, che fornisce l'accesso pubblico alle informazioni sulle imprese, come nomi, indirizzi, amministratori e depositi finanziari.
    • Licenza: CC0