LS HOWARD CENTRE WELWYN LIMITED
Panoramica
Nome della società | LS HOWARD CENTRE WELWYN LIMITED |
---|---|
Stato della società | Sciolta |
Forma giuridica | Società a responsabilità limitata |
Numero di società | 01813848 |
Giurisdizione | Inghilterra/Galles |
Data di costituzione | |
Data di cessazione |
Riepilogo
Ha PSCs super sicuri | No |
---|---|
Ha ipoteche | Sì |
Ha una storia di insolvenza | No |
La sede legale è in contestazione | No |
Qual è lo scopo di LS HOWARD CENTRE WELWYN LIMITED?
- Altre locazioni e gestioni di immobili propri o in affitto (68209) / Attività immobiliari
Dove si trova LS HOWARD CENTRE WELWYN LIMITED?
Indirizzo della sede legale | 100 Victoria Street SW1E 5JL London United Kingdom |
---|---|
Indirizzo della sede legale non recapitabile | No |
Quali erano i nomi precedenti di LS HOWARD CENTRE WELWYN LIMITED?
Nome della società | Da | A |
---|---|---|
HOWARD CENTRE PROPERTIES LIMITED | 05 ago 1988 | 05 ago 1988 |
B K PROPERTY DEVELOPMENTS LIMITED | 31 lug 1984 | 31 lug 1984 |
CREWSTYLE LIMITED | 04 mag 1984 | 04 mag 1984 |
Quali sono gli ultimi bilanci di LS HOWARD CENTRE WELWYN LIMITED?
Ultimi bilanci | |
---|---|
Ultimi bilanci redatti al | 31 mar 2019 |
Quali sono le ultime deposizioni per LS HOWARD CENTRE WELWYN LIMITED?
Data | Descrizione | Documento | Tipo | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gazzetta Ufficiale finale sciolta per scioglimento volontario | 1 pagine | GAZ2(A) | ||||||||||
Prima Gazzetta Ufficiale per lo scioglimento volontario | 1 pagine | GAZ1(A) | ||||||||||
Richiesta di cancellazione della società dal registro | 1 pagine | DS01 | ||||||||||
Cessazione della carica di Ls Director Limited come amministratore in data 22 set 2020 | 1 pagine | TM01 | ||||||||||
Cessazione della carica di Land Securities Management Services Limited come amministratore in data 22 set 2020 | 1 pagine | TM01 | ||||||||||
Dichiarazione di conformità presentata il 06 gen 2020 senza aggiornamenti | 3 pagine | CS01 | ||||||||||
Conto per una società dormiente redatto al 31 mar 2019 | 6 pagine | AA | ||||||||||
Soddisfazione dell'onere 2 in pieno | 5 pagine | MR04 | ||||||||||
Dichiarazione di conformità presentata il 09 feb 2019 con aggiornamenti | 4 pagine | CS01 | ||||||||||
Conto per una società dormiente redatto al 31 mar 2018 | 5 pagine | AA | ||||||||||
Dichiarazione di conformità presentata il 09 feb 2018 con aggiornamenti | 4 pagine | CS01 | ||||||||||
Cessazione della carica di Louise Miller come amministratore in data 01 gen 2018 | 1 pagine | TM01 | ||||||||||
Nomina di Mrs Elizabeth Miles come amministratore in data 01 gen 2018 | 2 pagine | AP01 | ||||||||||
Bilancio redatto al 31 mar 2017 | 14 pagine | AA | ||||||||||
Cessazione della carica di Michael Arnaouti come amministratore in data 31 mar 2017 | 1 pagine | TM01 | ||||||||||
Nomina di Louise Miller come amministratore in data 01 mar 2017 | 2 pagine | AP01 | ||||||||||
Dichiarazione di conformità presentata il 21 feb 2017 con aggiornamenti | 6 pagine | CS01 | ||||||||||
Dettagli del direttore cambiati per Mr Michael Arnaouti il 16 gen 2017 | 2 pagine | CH01 | ||||||||||
Dettagli del direttore cambiati per Land Securities Management Services Limited il 10 gen 2017 | 1 pagine | CH02 | ||||||||||
Dettagli del direttore cambiati per Ls Director Limited il 10 gen 2017 | 1 pagine | CH02 | ||||||||||
Dettagli del segretario cambiati per Ls Company Secretaries Limited il 10 gen 2017 | 1 pagine | CH04 | ||||||||||
Indirizzo della sede legale modificato da 5 Strand London WC2N 5AF a 100 Victoria Street London SW1E 5JL in data 10 gen 2017 | 1 pagine | AD01 | ||||||||||
Bilancio redatto al 31 mar 2016 | 13 pagine | AA | ||||||||||
Bilancio annuale redatto al 31 mar 2016 con elenco completo degli azionisti | 5 pagine | AR01 | ||||||||||
| ||||||||||||
Dettagli del direttore cambiati per Land Securities Management Services Limited il 01 apr 2015 | 1 pagine | CH02 | ||||||||||
Chi sono gli amministratori di LS HOWARD CENTRE WELWYN LIMITED?
Nome | Nominato il | Dimissioni il | Ruolo | Indirizzo | Identificazione della società | Paese di residenza | Nazionalità | Data di nascita | Professione | Numero | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LS COMPANY SECRETARIES LIMITED | Segretario | Victoria Street SW1E 5JL London 100 United Kingdom |
| 159674790001 | ||||||||||
MILES, Elizabeth | Amministratore | Victoria Street SW1E 5JL London 100 United Kingdom | United Kingdom | British | Solicitor | 235498150001 | ||||||||
DUDGEON, Peter Maxwell | Segretario | 41 Links Road KT17 3PP Epsom Surrey | British | Company Secretary | 14674480002 | |||||||||
PROBERT, John Robert | Segretario | 1 Meitner Close Bramley RG26 5NQ Tadley Hampshire | British | 34786610001 | ||||||||||
ARNAOUTI, Michael | Amministratore | Victoria Street SW1E 5JL London 100 United Kingdom | United Kingdom | British | Company Secretary | 539040004 | ||||||||
CAREY, Roger William | Amministratore | Instow Burtons Way HP8 4BP Chalfont St Giles Buckinghamshire | United Kingdom | British | Company Director | 6069370001 | ||||||||
DE SOUZA, Adrian Michael | Amministratore | Strand WC2N 5AF London 5 United Kingdom | United Kingdom | British | Solicitor | 158381390001 | ||||||||
DUDGEON, Peter Maxwell | Amministratore | 41 Links Road KT17 3PP Epsom Surrey | United Kingdom | British | Company Secretary | 14674480002 | ||||||||
HEAWOOD, John Anthony Nicholas | Amministratore | South View Road HA5 3YB Pinner Gateway Middlesex | United Kingdom | British | Chartered Surveyor | 133123780001 | ||||||||
KINGSTON, Richard David | Amministratore | 60 Clifton Road HP6 5PN Amersham Buckinghamshire | British | Accountant | 10789160002 | |||||||||
MILLER, Louise | Amministratore | Victoria Street SW1E 5JL London 100 United Kingdom | United Kingdom | British | Chartered Secretary | 199935770001 | ||||||||
OSBORN, Gareth John | Amministratore | 2 Orchard Coombe RG8 7QL Whitchurch Hill Oxfordshire | British | Chartered Surveyor | 91257750001 | |||||||||
SIMONS, David Edmund Frederick | Amministratore | Blue Cedars Wayside Gardens SL9 7NG Gerrards Cross Buckinghamshire | England | British | Comapny Director | 3078420001 | ||||||||
TAYLOR, Martin Laurence | Amministratore | 20 Bushwood Road Kew TW9 3BQ Richmond Surrey | England | British | Chartered Surveyor | 6069400002 | ||||||||
THOMSON, Hugh Linklater | Amministratore | 38 Charlbury Road OX2 6UX Oxford Oxfordshire | British | Chartered Surveyor | 12493210001 | |||||||||
WILSON, Derek Robert | Amministratore | The Spinney Misbourne Avenue Chalfont St Peter SL9 0PF Gerrards Cross Buckinghamshire | British | Company Director | 34786640001 | |||||||||
LAND SECURITIES MANAGEMENT SERVICES LIMITED | Amministratore | Victoria Street SW1E 5JL London 100 United Kingdom |
| 74974580001 | ||||||||||
LAND SECURITIES PORTFOLIO MANAGEMENT LIMITED | Amministratore | 5 Strand WC2N 5AF London | 100069790001 | |||||||||||
LS DIRECTOR LIMITED | Amministratore | Victoria Street SW1E 5JL London 100 United Kingdom |
| 133814600001 |
Chi sono le persone con controllo significativo di LS HOWARD CENTRE WELWYN LIMITED?
Nome | Notificato il | Indirizzo | Cessato | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Land Securities Portfolio Management Limited | 06 apr 2016 | Victoria Street SW1E 5JL London 100 United Kingdom | No | ||||||||||
| |||||||||||||
Natura del controllo
|
LS HOWARD CENTRE WELWYN LIMITED ha ipoteche?
Classificazione | Date | Stato | Dettagli | |
---|---|---|---|---|
Mortgage | Creato il 23 apr 2008 Consegnato il 25 apr 2008 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due or to become due from the company to any obligor secured creditor on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Brevi particolari F/H 35/47 howardsgate and osborn house welwyn garden city t/n HD213352 see image for full details. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
Mortgage | Creato il 04 gen 2008 Consegnato il 16 gen 2008 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due or to become due from the company to any obligor secured creditor on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Brevi particolari F/H land being co-operative house stonehills welwyn garden city hatfield t/no HD468412 and l/h land being co-operative house stonehills welwyn garden city hatfield t/no HD442056. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
Obligor accession deed | Creato il 31 mar 2005 Consegnato il 12 apr 2005 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due or to become due from the company to any obligor secured creditor under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Brevi particolari First ranking mortgage over land in england and wales, and real property and all all rights title and interest into any of the following assets: any real property, all plant machinery and other chattels, all shares, dividends, interest and other monies and all its right under any agreement. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
Mortgage | Creato il 31 mar 2005 Consegnato il 12 apr 2005 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due or to become due from the company to any obligor secured creditor under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Brevi particolari The f/h & l/h property k/a the howard centre, welwyn garden city, t/no's HD280591 (l/h) & HD272564 (f/h). See the mortgage charge document for full details. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
|
Fonte dati
- Companies House del Regno Unito
Il registro ufficiale delle imprese nel Regno Unito, che fornisce l'accesso pubblico alle informazioni sulle imprese, come nomi, indirizzi, amministratori e depositi finanziari. - Licenza: CC0