LIFECYCLE 2018 LIMITED

LIFECYCLE 2018 LIMITED

  • Panoramica
  • Riepilogo
  • Scopo
  • Indirizzo
  • Denominazioni precedenti
  • Bilanci
  • Dichiarazione di conferma
  • Deposizioni
  • Amministratori
  • Persone con controllo significativo
  • Ipoteche
  • Fonte dati
  • Panoramica

    Nome della societàLIFECYCLE 2018 LIMITED
    Stato della societàAttiva
    Forma giuridicaSocietà a responsabilità limitata
    Numero di società 01816173
    GiurisdizioneInghilterra/Galles
    Data di costituzione
    Data di cessazione

    Qual è lo scopo di LIFECYCLE 2018 LIMITED?

    • Società non commerciali (74990) / Attività professionali, scientifiche e tecniche

    Dove si trova LIFECYCLE 2018 LIMITED?

    Indirizzo della sede legale
    Samuel Ryder House Barling Way
    Eliot Park
    CV10 7RH Nuneaton
    Warwickshire
    Indirizzo della sede legale non recapitabileNo

    Quali erano i nomi precedenti di LIFECYCLE 2018 LIMITED?

    Denominazioni sociali precedenti
    Nome della societàDaA
    ENVOYOUT LIMITED15 mag 198415 mag 1984

    Quali sono gli ultimi bilanci di LIFECYCLE 2018 LIMITED?

    Scaduto
    Prossimi bilanci
    Fine del prossimo esercizio al30 set 2019
    Scadenza dei prossimi bilanci il30 set 2020
    Ultimi bilanci
    Ultimi bilanci redatti al30 set 2018

    Qual è lo stato dell'ultima dichiarazione di conferma per LIFECYCLE 2018 LIMITED?

    Scaduto
    Ultima dichiarazione di conferma redatta al09 mar 2020
    Scadenza della prossima dichiarazione di conferma23 mar 2020
    Ultima dichiarazione di conferma
    Prossima dichiarazione di conferma redatta al09 mar 2019
    Scaduto

    Quali sono le ultime deposizioni per LIFECYCLE 2018 LIMITED?

    Deposizioni
    DataDescrizioneDocumentoTipo

    Dettagli del direttore cambiati per Mr Matthew Giles Thomas Smith il 28 nov 2024

    2 pagineCH01

    Cessazione della carica di Robbie Ian Bell come amministratore in data 30 apr 2023

    1 pagineTM01

    Nomina di Mr Nicholas Dermott Vance Allen come amministratore in data 30 apr 2023

    2 pagineAP01

    Nomina di Mr Matthew Giles Thomas Smith come segretario in data 01 gen 2021

    2 pagineAP03

    Cessazione della carica di Lisa Mary Garley-Evans come amministratore in data 31 dic 2020

    1 pagineTM01

    Cessazione della carica di Lisa Mary Garley-Evans come segretario in data 31 dic 2020

    1 pagineTM02

    Nomina di Mr Matthew Giles Thomas Smith come amministratore in data 01 gen 2021

    2 pagineAP01

    Cessazione della carica di Anthony David Buffin come amministratore in data 02 ott 2020

    1 pagineTM01

    Cessazione della carica di Gregory Alexander Watts come amministratore in data 01 lug 2020

    1 pagineTM01

    Nomina di Mr Robbie Ian Bell come amministratore in data 01 lug 2020

    2 pagineAP01

    Conto per una società dormiente redatto al 30 set 2018

    10 pagineAA

    Nomina di Mr Gregory Alexander Watts come amministratore in data 23 ott 2019

    2 pagineAP01

    Cessazione della carica di Christian Keen come amministratore in data 23 ott 2019

    1 pagineTM01

    Nomina di Mr Anthony David Buffin come amministratore in data 23 ott 2019

    2 pagineAP01

    Dichiarazione di conformità presentata il 09 mar 2019 senza aggiornamenti

    3 pagineCS01

    Dichiarazione di conformità presentata il 09 mar 2018 senza aggiornamenti

    3 pagineCS01

    Dichiarazione di conformità presentata il 09 mar 2017 con aggiornamenti

    5 pagineCS01

    Notifica di Holland & Barrett Retail Limited come persona con controllo significativo il 06 apr 2016

    2 paginePSC02

    Notifica di Holland & Barrett Retail Limited come persona con controllo significativo il 06 apr 2016

    1 paginePSC02

    Cessazione della carica di Kyle John Rowe come amministratore in data 01 ott 2017

    1 pagineTM01

    Cessazione della carica di Martin Philip Moran come amministratore in data 01 ott 2017

    1 pagineTM01

    Cessazione della carica di Peter Howard Aldis come amministratore in data 01 ott 2017

    1 pagineTM01

    Risoluzioni

    Resolutions
    1 pagineRESOLUTIONS
    Risoluzioni
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    change-of-name

    Risoluzione di cambio di nome della società il 28 feb 2018

    RES15

    Avviso di cambio di nome"

    2 pagineCONNOT

    Ripristino per ordine del tribunale

    3 pagineAC92

    Chi sono gli amministratori di LIFECYCLE 2018 LIMITED?

    Amministratori
    NomeNominato ilDimissioni ilRuoloIndirizzoIdentificazione della societàPaese di residenzaNazionalitàData di nascitaProfessioneNumero
    SMITH, Matthew Giles Thomas
    Barling Way
    Eliot Park
    CV10 7RH Nuneaton
    Samuel Ryder House
    Warwickshire
    Segretario
    Barling Way
    Eliot Park
    CV10 7RH Nuneaton
    Samuel Ryder House
    Warwickshire
    278476660001
    ALLEN, Nicholas Dermott Vance
    Barling Way
    Eliot Park
    CV10 7RH Nuneaton
    Samuel Ryder House
    Warwickshire
    Amministratore
    Barling Way
    Eliot Park
    CV10 7RH Nuneaton
    Samuel Ryder House
    Warwickshire
    United KingdomBritishCfo245111960001
    SMITH, Matthew Giles Thomas
    Barling Way
    Eliot Park
    CV10 7RH Nuneaton
    Samuel Ryder House
    Warwickshire
    Amministratore
    Barling Way
    Eliot Park
    CV10 7RH Nuneaton
    Samuel Ryder House
    Warwickshire
    United KingdomBritishLawyer154170600003
    CRADDOCK, Roger
    Barling Way
    Eliot Park
    CV10 7RH Nuneaton
    Samuel Ryder House
    Warwickshire
    United Kingdom
    Segretario
    Barling Way
    Eliot Park
    CV10 7RH Nuneaton
    Samuel Ryder House
    Warwickshire
    United Kingdom
    British20091330002
    DAVIES, John Richard Bridge
    Amberley
    5 Primrose Hill Waste Lane
    CW6 0PE Kelsall
    Cheshire
    Segretario
    Amberley
    5 Primrose Hill Waste Lane
    CW6 0PE Kelsall
    Cheshire
    British51554100001
    EBRAHIMJEE, Mahmood
    112 Wantage Road
    OX10 0LX Wallingford
    Oxfordshire
    Segretario
    112 Wantage Road
    OX10 0LX Wallingford
    Oxfordshire
    British2582770001
    GARLEY-EVANS, Lisa Mary
    Barling Way
    Eliot Park
    CV10 7RH Nuneaton
    Samuel Ryder House
    Warwickshire
    Segretario
    Barling Way
    Eliot Park
    CV10 7RH Nuneaton
    Samuel Ryder House
    Warwickshire
    216302200001
    RILEY, Rodney Hardwicke
    34 Sumatra Road
    West Hampstead
    NW6 1PU London
    Segretario
    34 Sumatra Road
    West Hampstead
    NW6 1PU London
    British9862630001
    ALDIS, Peter Howard
    Barling Way
    Eliot Park
    CV10 7RH Nuneaton
    Samuel Ryder House
    Warwickshire
    United Kingdom
    Amministratore
    Barling Way
    Eliot Park
    CV10 7RH Nuneaton
    Samuel Ryder House
    Warwickshire
    United Kingdom
    Chief Executive OfficerIrishChief Executive Officer55735210005
    BELL, Robbie Ian
    Barling Way
    Eliot Park
    CV10 7RH Nuneaton
    Samuel Ryder House
    Warwickshire
    Amministratore
    Barling Way
    Eliot Park
    CV10 7RH Nuneaton
    Samuel Ryder House
    Warwickshire
    EnglandBritishCfo97384120002
    BUCKELL, Stephen William
    Wykin House
    Wykin
    LE10 3PN Hinckley
    Leicestershire
    Amministratore
    Wykin House
    Wykin
    LE10 3PN Hinckley
    Leicestershire
    BritishDirector & Company Secretary20341960001
    BUFFIN, Anthony David
    Barling Way
    Eliot Park
    CV10 7RH Nuneaton
    Samuel Ryder House
    Warwickshire
    Amministratore
    Barling Way
    Eliot Park
    CV10 7RH Nuneaton
    Samuel Ryder House
    Warwickshire
    EnglandBritishCeo178011680002
    CRADDOCK, Roger
    Barling Way
    Eliot Park
    CV10 7RH Nuneaton
    Samuel Ryder House
    Warwickshire
    United Kingdom
    Amministratore
    Barling Way
    Eliot Park
    CV10 7RH Nuneaton
    Samuel Ryder House
    Warwickshire
    United Kingdom
    EnglandBritishSolicitor20091330013
    DAY, Gillian Margaret
    Our House
    1 Meadow Brook Court
    DE12 7AX Appleby Magna
    Derbyshire
    Amministratore
    Our House
    1 Meadow Brook Court
    DE12 7AX Appleby Magna
    Derbyshire
    BritishDirector55013960005
    FELLOWS, Jonathan
    26 Ladywood Road
    Four Oaks
    B74 2QN Sutton Coldfield
    West Midlands
    Amministratore
    26 Ladywood Road
    Four Oaks
    B74 2QN Sutton Coldfield
    West Midlands
    EnglandBritishFin Dir118296490001
    GARLEY-EVANS, Lisa Mary
    Barling Way
    Eliot Park
    CV10 7RH Nuneaton
    Samuel Ryder House
    Warwickshire
    Amministratore
    Barling Way
    Eliot Park
    CV10 7RH Nuneaton
    Samuel Ryder House
    Warwickshire
    United KingdomBritishSolicitor210802400001
    GOLECHHA, Dipak
    Barling Way
    Eliot Park
    CV10 7RH Nuneaton
    Samuel Ryder House
    Warwickshire
    Amministratore
    Barling Way
    Eliot Park
    CV10 7RH Nuneaton
    Samuel Ryder House
    Warwickshire
    UsaBritishBusiness Executive195451690001
    HARDY, Lysa Maria
    Barling Way
    Eliot Park
    CV10 7RH Nuneaton
    Samuel Ryder House
    Warwickshire
    United Kingdom
    Amministratore
    Barling Way
    Eliot Park
    CV10 7RH Nuneaton
    Samuel Ryder House
    Warwickshire
    United Kingdom
    United KingdomBritishChief Marketing Officer165408450002
    KAMIL, Harvey
    Barling Way
    Eliot Park
    CV10 7RH Nuneaton
    Samuel Ryder House
    Warwickshire
    United Kingdom
    Amministratore
    Barling Way
    Eliot Park
    CV10 7RH Nuneaton
    Samuel Ryder House
    Warwickshire
    United Kingdom
    United StatesAmericanPresident54421630001
    KEEN, Christian
    Barling Way
    Eliot Park
    CV10 7RH Nuneaton
    Samuel Ryder House
    Warwickshire
    Amministratore
    Barling Way
    Eliot Park
    CV10 7RH Nuneaton
    Samuel Ryder House
    Warwickshire
    EnglandBritishChief Financial Officer54544790004
    KENDRICK, Mark
    Barling Way
    Eliot Park
    CV10 7RH Nuneaton
    Samuel Ryder House
    Warwickshire
    United Kingdom
    Amministratore
    Barling Way
    Eliot Park
    CV10 7RH Nuneaton
    Samuel Ryder House
    Warwickshire
    United Kingdom
    United KingdomBritishDirector133928070002
    KERSHAW, Graham Anthony
    24 Oakfield Road
    HD2 2XF Huddersfield
    Yorkshire
    Amministratore
    24 Oakfield Road
    HD2 2XF Huddersfield
    Yorkshire
    BritishGroup Human Resources Director8991780009
    LLOYD, Allen John
    Yew House
    Freasley
    B78 2EY Tamworth
    Staffordshire
    Amministratore
    Yew House
    Freasley
    B78 2EY Tamworth
    Staffordshire
    BritishChairman & Chief Executive2270630001
    LLOYD, Peter Edward
    Southfield Coventry Road
    CV8 2FT Kenilworth
    Warwickshire
    Amministratore
    Southfield Coventry Road
    CV8 2FT Kenilworth
    Warwickshire
    BritishDirector Of Retail Operations35546210001
    MCMENEMIE, Carolyn
    Barling Way
    Eliot Park
    CV10 7RH Nuneaton
    Samuel Ryder House
    Warwickshire
    Amministratore
    Barling Way
    Eliot Park
    CV10 7RH Nuneaton
    Samuel Ryder House
    Warwickshire
    EnglandBritishH.R Director196411980001
    MEISTER, Stefan Mario
    Rosengartenstrasse 19
    70184 Stuttgart
    Germany
    Amministratore
    Rosengartenstrasse 19
    70184 Stuttgart
    Germany
    SwissDirector43550520003
    MORAN, Martin Philip
    Barling Way
    Eliot Park
    CV10 7RH Nuneaton
    Samuel Ryder House
    Warwickshire
    Amministratore
    Barling Way
    Eliot Park
    CV10 7RH Nuneaton
    Samuel Ryder House
    Warwickshire
    Northern IrelandIrishChief Operating Officer196412390001
    MORAN, Martin Philip
    Barling Way
    Eliot Park
    CV10 7RH Nuneaton
    Samuel Ryder House
    Warwickshire
    United Kingdom
    Amministratore
    Barling Way
    Eliot Park
    CV10 7RH Nuneaton
    Samuel Ryder House
    Warwickshire
    United Kingdom
    United KingdomIrishDirector88328810002
    MURGATROYD, Andrew John
    The Martens Hamshill
    Coaley
    GL11 5EH Dursley
    Gloucestershire
    Amministratore
    The Martens Hamshill
    Coaley
    GL11 5EH Dursley
    Gloucestershire
    BritishDirector14531520001
    OAKLEY, Stephen Edward
    31 Barlings Road
    AL5 2AW Harpenden
    Hertfordshire
    Amministratore
    31 Barlings Road
    AL5 2AW Harpenden
    Hertfordshire
    EnglandBritishAccountant438640001
    PARSONS, Ian Dominic
    72 Spindlewood
    Elloughton
    HU15 1LL Brough
    North Humberside
    Amministratore
    72 Spindlewood
    Elloughton
    HU15 1LL Brough
    North Humberside
    EnglandBritishChief Executive63325310001
    ROWE, Kyle John
    Barling Way
    Eliot Park
    CV10 7RH Nuneaton
    Samuel Ryder House
    Warwickshire
    Amministratore
    Barling Way
    Eliot Park
    CV10 7RH Nuneaton
    Samuel Ryder House
    Warwickshire
    EnglandBritishInternational Development Director196412690001
    RUDOLPH, Scott Allen
    25 Piping Rock Road
    Upper Brookville
    New York
    11545
    U S A
    Amministratore
    25 Piping Rock Road
    Upper Brookville
    New York
    11545
    U S A
    UsaAmericanChairman54420230004
    SHAW, Robert Petrie
    9 Linnet Road
    NN12 6RH Towcester
    Northamptonshire
    Amministratore
    9 Linnet Road
    NN12 6RH Towcester
    Northamptonshire
    BritishAccountant728590001
    STEELE, Richard John
    10 Newton Park
    Newton Solney
    DE15 0SX Burton On Trent
    Derbyshire
    Amministratore
    10 Newton Park
    Newton Solney
    DE15 0SX Burton On Trent
    Derbyshire
    EnglandBritishGroup Financial Director1415570001

    Chi sono le persone con controllo significativo di LIFECYCLE 2018 LIMITED?

    Persone con controllo significativo
    NomeNotificato ilIndirizzoCessato
    Holland & Barrett Retail Limited
    Barling Way
    CV10 7RH Nuneaton
    Samuel Ryder House
    England
    06 apr 2016
    Barling Way
    CV10 7RH Nuneaton
    Samuel Ryder House
    England
    No
    Forma giuridicaLimited Company
    Paese di registrazioneEngland
    Autorità legaleCompanies Act 2006
    Luogo di registrazioneEngland & Wales
    Numero di registrazione2758955
    Natura del controllo
    • La persona possiede, direttamente o indirettamente, più del 75% delle azioni della società.
    Holland & Barrett Retail Limited
    Barling Way
    CV10 7RH Nuneaton
    Samuel Ryder House
    England
    06 apr 2016
    Barling Way
    CV10 7RH Nuneaton
    Samuel Ryder House
    England
    No
    Forma giuridicaPrivate Limited Company
    Autorità legaleEngland & Wales
    Natura del controllo
    • La persona possiede, direttamente o indirettamente, più del 75% delle azioni della società.
    • La persona detiene, direttamente o indirettamente, più del 75% dei diritti di voto nella società.

    LIFECYCLE 2018 LIMITED ha ipoteche?

    Ipoteche
    ClassificazioneDateStatoDettagli
    Legal charge
    Creato il 28 ott 1986
    Consegnato il 30 nov 1986
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Unit 5, cutbush industrial estate, lower earley title no. Bk 228413.
    Persone aventi diritto
    • Trustee Savings Bank England and Wales
    Transazioni
    • 30 nov 1986Registrazione di un'ipoteca
    • 13 set 1991Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Mortgage
    Creato il 01 lug 1986
    Consegnato il 03 lug 1986
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of a lease dated 6.2.85 and under the terms of the charge
    Brevi particolari
    The sum of sterling pounds 21,72900 together with accrued interest and other monies as provided in the mortgage.
    Persone aventi diritto
    • Hill Samuel Life Assurance Limited
    Transazioni
    • 03 lug 1986Registrazione di un'ipoteca
    And guarantee mortgage debenture
    Creato il 24 apr 1986
    Consegnato il 02 mag 1986
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company and/or southern heath foods limited to the chargee on any account whatsoever.
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital 219 high street o'pington kent t/n sgl 237543.
    Persone aventi diritto
    • Trustee Damings Bank England and Wales
    Transazioni
    • 02 mag 1986Registrazione di un'ipoteca

    Fonte dati

    • Companies House del Regno Unito
      Il registro ufficiale delle imprese nel Regno Unito, che fornisce l'accesso pubblico alle informazioni sulle imprese, come nomi, indirizzi, amministratori e depositi finanziari.
    • Licenza: CC0