LIFECYCLE 2018 LIMITED
Panoramica
Nome della società | LIFECYCLE 2018 LIMITED |
---|---|
Stato della società | Attiva |
Forma giuridica | Società a responsabilità limitata |
Numero di società | 01816173 |
Giurisdizione | Inghilterra/Galles |
Data di costituzione | |
Data di cessazione |
Riepilogo
Ha PSCs super sicuri | No |
---|---|
Ha ipoteche | Sì |
Ha una storia di insolvenza | No |
La sede legale è in contestazione | No |
Qual è lo scopo di LIFECYCLE 2018 LIMITED?
- Società non commerciali (74990) / Attività professionali, scientifiche e tecniche
Dove si trova LIFECYCLE 2018 LIMITED?
Indirizzo della sede legale | Samuel Ryder House Barling Way Eliot Park CV10 7RH Nuneaton Warwickshire |
---|---|
Indirizzo della sede legale non recapitabile | No |
Quali erano i nomi precedenti di LIFECYCLE 2018 LIMITED?
Nome della società | Da | A |
---|---|---|
ENVOYOUT LIMITED | 15 mag 1984 | 15 mag 1984 |
Quali sono gli ultimi bilanci di LIFECYCLE 2018 LIMITED?
Scaduto | Sì |
---|---|
Prossimi bilanci | |
Fine del prossimo esercizio al | 30 set 2019 |
Scadenza dei prossimi bilanci il | 30 set 2020 |
Ultimi bilanci | |
Ultimi bilanci redatti al | 30 set 2018 |
Qual è lo stato dell'ultima dichiarazione di conferma per LIFECYCLE 2018 LIMITED?
Scaduto | Sì |
---|---|
Ultima dichiarazione di conferma redatta al | 09 mar 2020 |
Scadenza della prossima dichiarazione di conferma | 23 mar 2020 |
Ultima dichiarazione di conferma | |
Prossima dichiarazione di conferma redatta al | 09 mar 2019 |
Scaduto | Sì |
Quali sono le ultime deposizioni per LIFECYCLE 2018 LIMITED?
Data | Descrizione | Documento | Tipo | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dettagli del direttore cambiati per Mr Matthew Giles Thomas Smith il 28 nov 2024 | 2 pagine | CH01 | ||||||||||
Cessazione della carica di Robbie Ian Bell come amministratore in data 30 apr 2023 | 1 pagine | TM01 | ||||||||||
Nomina di Mr Nicholas Dermott Vance Allen come amministratore in data 30 apr 2023 | 2 pagine | AP01 | ||||||||||
Nomina di Mr Matthew Giles Thomas Smith come segretario in data 01 gen 2021 | 2 pagine | AP03 | ||||||||||
Cessazione della carica di Lisa Mary Garley-Evans come amministratore in data 31 dic 2020 | 1 pagine | TM01 | ||||||||||
Cessazione della carica di Lisa Mary Garley-Evans come segretario in data 31 dic 2020 | 1 pagine | TM02 | ||||||||||
Nomina di Mr Matthew Giles Thomas Smith come amministratore in data 01 gen 2021 | 2 pagine | AP01 | ||||||||||
Cessazione della carica di Anthony David Buffin come amministratore in data 02 ott 2020 | 1 pagine | TM01 | ||||||||||
Cessazione della carica di Gregory Alexander Watts come amministratore in data 01 lug 2020 | 1 pagine | TM01 | ||||||||||
Nomina di Mr Robbie Ian Bell come amministratore in data 01 lug 2020 | 2 pagine | AP01 | ||||||||||
Conto per una società dormiente redatto al 30 set 2018 | 10 pagine | AA | ||||||||||
Nomina di Mr Gregory Alexander Watts come amministratore in data 23 ott 2019 | 2 pagine | AP01 | ||||||||||
Cessazione della carica di Christian Keen come amministratore in data 23 ott 2019 | 1 pagine | TM01 | ||||||||||
Nomina di Mr Anthony David Buffin come amministratore in data 23 ott 2019 | 2 pagine | AP01 | ||||||||||
Dichiarazione di conformità presentata il 09 mar 2019 senza aggiornamenti | 3 pagine | CS01 | ||||||||||
Dichiarazione di conformità presentata il 09 mar 2018 senza aggiornamenti | 3 pagine | CS01 | ||||||||||
Dichiarazione di conformità presentata il 09 mar 2017 con aggiornamenti | 5 pagine | CS01 | ||||||||||
Notifica di Holland & Barrett Retail Limited come persona con controllo significativo il 06 apr 2016 | 2 pagine | PSC02 | ||||||||||
Notifica di Holland & Barrett Retail Limited come persona con controllo significativo il 06 apr 2016 | 1 pagine | PSC02 | ||||||||||
Cessazione della carica di Kyle John Rowe come amministratore in data 01 ott 2017 | 1 pagine | TM01 | ||||||||||
Cessazione della carica di Martin Philip Moran come amministratore in data 01 ott 2017 | 1 pagine | TM01 | ||||||||||
Cessazione della carica di Peter Howard Aldis come amministratore in data 01 ott 2017 | 1 pagine | TM01 | ||||||||||
Risoluzioni Resolutions | 1 pagine | RESOLUTIONS | ||||||||||
| ||||||||||||
Avviso di cambio di nome" | 2 pagine | CONNOT | ||||||||||
Ripristino per ordine del tribunale | 3 pagine | AC92 | ||||||||||
Chi sono gli amministratori di LIFECYCLE 2018 LIMITED?
Nome | Nominato il | Dimissioni il | Ruolo | Indirizzo | Identificazione della società | Paese di residenza | Nazionalità | Data di nascita | Professione | Numero |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SMITH, Matthew Giles Thomas | Segretario | Barling Way Eliot Park CV10 7RH Nuneaton Samuel Ryder House Warwickshire | 278476660001 | |||||||
ALLEN, Nicholas Dermott Vance | Amministratore | Barling Way Eliot Park CV10 7RH Nuneaton Samuel Ryder House Warwickshire | United Kingdom | British | Cfo | 245111960001 | ||||
SMITH, Matthew Giles Thomas | Amministratore | Barling Way Eliot Park CV10 7RH Nuneaton Samuel Ryder House Warwickshire | United Kingdom | British | Lawyer | 154170600003 | ||||
CRADDOCK, Roger | Segretario | Barling Way Eliot Park CV10 7RH Nuneaton Samuel Ryder House Warwickshire United Kingdom | British | 20091330002 | ||||||
DAVIES, John Richard Bridge | Segretario | Amberley 5 Primrose Hill Waste Lane CW6 0PE Kelsall Cheshire | British | 51554100001 | ||||||
EBRAHIMJEE, Mahmood | Segretario | 112 Wantage Road OX10 0LX Wallingford Oxfordshire | British | 2582770001 | ||||||
GARLEY-EVANS, Lisa Mary | Segretario | Barling Way Eliot Park CV10 7RH Nuneaton Samuel Ryder House Warwickshire | 216302200001 | |||||||
RILEY, Rodney Hardwicke | Segretario | 34 Sumatra Road West Hampstead NW6 1PU London | British | 9862630001 | ||||||
ALDIS, Peter Howard | Amministratore | Barling Way Eliot Park CV10 7RH Nuneaton Samuel Ryder House Warwickshire United Kingdom | Chief Executive Officer | Irish | Chief Executive Officer | 55735210005 | ||||
BELL, Robbie Ian | Amministratore | Barling Way Eliot Park CV10 7RH Nuneaton Samuel Ryder House Warwickshire | England | British | Cfo | 97384120002 | ||||
BUCKELL, Stephen William | Amministratore | Wykin House Wykin LE10 3PN Hinckley Leicestershire | British | Director & Company Secretary | 20341960001 | |||||
BUFFIN, Anthony David | Amministratore | Barling Way Eliot Park CV10 7RH Nuneaton Samuel Ryder House Warwickshire | England | British | Ceo | 178011680002 | ||||
CRADDOCK, Roger | Amministratore | Barling Way Eliot Park CV10 7RH Nuneaton Samuel Ryder House Warwickshire United Kingdom | England | British | Solicitor | 20091330013 | ||||
DAY, Gillian Margaret | Amministratore | Our House 1 Meadow Brook Court DE12 7AX Appleby Magna Derbyshire | British | Director | 55013960005 | |||||
FELLOWS, Jonathan | Amministratore | 26 Ladywood Road Four Oaks B74 2QN Sutton Coldfield West Midlands | England | British | Fin Dir | 118296490001 | ||||
GARLEY-EVANS, Lisa Mary | Amministratore | Barling Way Eliot Park CV10 7RH Nuneaton Samuel Ryder House Warwickshire | United Kingdom | British | Solicitor | 210802400001 | ||||
GOLECHHA, Dipak | Amministratore | Barling Way Eliot Park CV10 7RH Nuneaton Samuel Ryder House Warwickshire | Usa | British | Business Executive | 195451690001 | ||||
HARDY, Lysa Maria | Amministratore | Barling Way Eliot Park CV10 7RH Nuneaton Samuel Ryder House Warwickshire United Kingdom | United Kingdom | British | Chief Marketing Officer | 165408450002 | ||||
KAMIL, Harvey | Amministratore | Barling Way Eliot Park CV10 7RH Nuneaton Samuel Ryder House Warwickshire United Kingdom | United States | American | President | 54421630001 | ||||
KEEN, Christian | Amministratore | Barling Way Eliot Park CV10 7RH Nuneaton Samuel Ryder House Warwickshire | England | British | Chief Financial Officer | 54544790004 | ||||
KENDRICK, Mark | Amministratore | Barling Way Eliot Park CV10 7RH Nuneaton Samuel Ryder House Warwickshire United Kingdom | United Kingdom | British | Director | 133928070002 | ||||
KERSHAW, Graham Anthony | Amministratore | 24 Oakfield Road HD2 2XF Huddersfield Yorkshire | British | Group Human Resources Director | 8991780009 | |||||
LLOYD, Allen John | Amministratore | Yew House Freasley B78 2EY Tamworth Staffordshire | British | Chairman & Chief Executive | 2270630001 | |||||
LLOYD, Peter Edward | Amministratore | Southfield Coventry Road CV8 2FT Kenilworth Warwickshire | British | Director Of Retail Operations | 35546210001 | |||||
MCMENEMIE, Carolyn | Amministratore | Barling Way Eliot Park CV10 7RH Nuneaton Samuel Ryder House Warwickshire | England | British | H.R Director | 196411980001 | ||||
MEISTER, Stefan Mario | Amministratore | Rosengartenstrasse 19 70184 Stuttgart Germany | Swiss | Director | 43550520003 | |||||
MORAN, Martin Philip | Amministratore | Barling Way Eliot Park CV10 7RH Nuneaton Samuel Ryder House Warwickshire | Northern Ireland | Irish | Chief Operating Officer | 196412390001 | ||||
MORAN, Martin Philip | Amministratore | Barling Way Eliot Park CV10 7RH Nuneaton Samuel Ryder House Warwickshire United Kingdom | United Kingdom | Irish | Director | 88328810002 | ||||
MURGATROYD, Andrew John | Amministratore | The Martens Hamshill Coaley GL11 5EH Dursley Gloucestershire | British | Director | 14531520001 | |||||
OAKLEY, Stephen Edward | Amministratore | 31 Barlings Road AL5 2AW Harpenden Hertfordshire | England | British | Accountant | 438640001 | ||||
PARSONS, Ian Dominic | Amministratore | 72 Spindlewood Elloughton HU15 1LL Brough North Humberside | England | British | Chief Executive | 63325310001 | ||||
ROWE, Kyle John | Amministratore | Barling Way Eliot Park CV10 7RH Nuneaton Samuel Ryder House Warwickshire | England | British | International Development Director | 196412690001 | ||||
RUDOLPH, Scott Allen | Amministratore | 25 Piping Rock Road Upper Brookville New York 11545 U S A | Usa | American | Chairman | 54420230004 | ||||
SHAW, Robert Petrie | Amministratore | 9 Linnet Road NN12 6RH Towcester Northamptonshire | British | Accountant | 728590001 | |||||
STEELE, Richard John | Amministratore | 10 Newton Park Newton Solney DE15 0SX Burton On Trent Derbyshire | England | British | Group Financial Director | 1415570001 |
Chi sono le persone con controllo significativo di LIFECYCLE 2018 LIMITED?
Nome | Notificato il | Indirizzo | Cessato | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Holland & Barrett Retail Limited | 06 apr 2016 | Barling Way CV10 7RH Nuneaton Samuel Ryder House England | No | ||||||||||
| |||||||||||||
Natura del controllo
| |||||||||||||
Holland & Barrett Retail Limited | 06 apr 2016 | Barling Way CV10 7RH Nuneaton Samuel Ryder House England | No | ||||||||||
| |||||||||||||
Natura del controllo
|
LIFECYCLE 2018 LIMITED ha ipoteche?
Classificazione | Date | Stato | Dettagli | |
---|---|---|---|---|
Legal charge | Creato il 28 ott 1986 Consegnato il 30 nov 1986 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Brevi particolari Unit 5, cutbush industrial estate, lower earley title no. Bk 228413. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
Mortgage | Creato il 01 lug 1986 Consegnato il 03 lug 1986 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of a lease dated 6.2.85 and under the terms of the charge | |
Brevi particolari The sum of sterling pounds 21,72900 together with accrued interest and other monies as provided in the mortgage. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
And guarantee mortgage debenture | Creato il 24 apr 1986 Consegnato il 02 mag 1986 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due or to become due from the company and/or southern heath foods limited to the chargee on any account whatsoever. | |
Brevi particolari Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital 219 high street o'pington kent t/n sgl 237543. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
|
Fonte dati
- Companies House del Regno Unito
Il registro ufficiale delle imprese nel Regno Unito, che fornisce l'accesso pubblico alle informazioni sulle imprese, come nomi, indirizzi, amministratori e depositi finanziari. - Licenza: CC0