GNE GROUP LIMITED

  • Panoramica
  • Riepilogo
  • Scopo
  • Indirizzo
  • Denominazioni precedenti
  • Bilanci
  • Deposizioni
  • Amministratori
  • Ipoteche
  • Insolvenza
  • Fonte dati
  • Panoramica

    Nome della societàGNE GROUP LIMITED
    Stato della societàSciolta
    Forma giuridicaSocietà a responsabilità limitata
    Numero di società 01816510
    GiurisdizioneInghilterra/Galles
    Data di costituzione
    Data di cessazione

    Qual è lo scopo di GNE GROUP LIMITED?

    • (7415) /

    Dove si trova GNE GROUP LIMITED?

    Indirizzo della sede legale
    1st Floor 26-28 Bedford Row
    WC1R 4HE London
    Indirizzo della sede legale non recapitabileNo

    Quali erano i nomi precedenti di GNE GROUP LIMITED?

    Denominazioni sociali precedenti
    Nome della societàDaA
    GNE GROUP PLC18 giu 200718 giu 2007
    GLOBAL NATURAL ENERGY PLC09 ago 200209 ago 2002
    MIDDLESEX HOLDINGS PLC04 gen 199404 gen 1994
    FERROMET GROUP PLC27 nov 198927 nov 1989
    CLOGAU GOLD MINES P.L.C.15 mag 198415 mag 1984

    Quali sono gli ultimi bilanci di GNE GROUP LIMITED?

    Ultimi bilanci
    Ultimi bilanci redatti al31 dic 2008

    Quali sono le ultime deposizioni per GNE GROUP LIMITED?

    Deposizioni
    DataDescrizioneDocumentoTipo

    Gazzetta ufficiale finale sciolta a seguito di liquidazione

    1 pagineGAZ2

    Ritorno della riunione finale in una liquidazione volontaria dei membri

    3 pagine4.71

    Dichiarazione dei ricevimenti e dei pagamenti dei liquidatori fino a 29 set 2011

    5 pagine4.68

    Dichiarazione dei ricevimenti e dei pagamenti dei liquidatori fino a 29 mar 2011

    5 pagine4.68

    Dichiarazione dei ricevimenti e dei pagamenti dei liquidatori fino a 29 set 2010

    5 pagine4.68

    Risoluzioni

    Resolutions
    1 pagineRESOLUTIONS
    Risoluzioni
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    liquidation

    Risoluzione speciale per la liquidazione al 30 set 2009

    LRESSP

    Risoluzioni

    Resolutions
    1 pagineRESOLUTIONS
    Risoluzioni
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    liquidation

    Risoluzione straordinaria per la liquidazione

    LRESEX

    Indirizzo della sede legale modificato da Ground Floor Ryder Court 14 Ryder Street London Greater London SW1Y 6QB in data 18 ott 2009

    1 pagineAD01

    Nomina di un liquidatore volontario

    1 pagine600

    Dichiarazione di solvibilità

    3 pagine4.70

    legacy

    2 pagine288a

    legacy

    1 pagine288b

    legacy

    1 pagineSH20

    legacy

    1 pagineCAP-SS

    legacy

    1 pagineCAP-MDSC

    Risoluzioni

    Resolutions
    2 pagineRESOLUTIONS
    Risoluzioni
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    capital

    Risoluzioni

    Share premium account cancelled 29/06/2009
    RES13

    legacy

    1 pagine288a

    legacy

    1 pagine288b

    legacy

    1 pagine288b

    legacy

    1 pagine288b

    legacy

    2 pagine288a

    Risoluzioni

    Resolutions
    3 pagineRESOLUTIONS
    Risoluzioni
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    capital

    Risoluzione di assegnazione di titoli

    RES10
    incorporation

    Risoluzione di modifica del Memorandum di Associazione

    RES01
    capital

    Risoluzione di rimozione dei diritti di prelazione

    RES11
    capital

    Risoluzione di assistenza finanziaria per l'acquisizione di azioni

    RES07

    Certificato di ri-registrazione da Società Pubblica a Responsabilità Limitata a Privata

    1 pagineCERT10

    Riregistrazione del Memorandum e dello Statuto

    63 pagineMAR

    legacy

    1 pagine53

    Chi sono gli amministratori di GNE GROUP LIMITED?

    Amministratori
    NomeNominato ilDimissioni ilRuoloIndirizzoIdentificazione della societàPaese di residenzaNazionalitàData di nascitaProfessioneNumero
    J.O.HAMBRO CAPITAL MANAGEMENT LIMITED
    14 Ryder Street
    SW1Y 6QB London
    Ground Floor Ryder Court
    Segretario
    14 Ryder Street
    SW1Y 6QB London
    Ground Floor Ryder Court
    138355930001
    VAUGHAN, Margaret Helen
    Court Lodge
    Vanity Lane, Linton
    ME17 4BP Maidstone
    Kent
    Amministratore
    Court Lodge
    Vanity Lane, Linton
    ME17 4BP Maidstone
    Kent
    United KingdomBritish123167120001
    WARNER, Graham
    2 St Paul's Close
    AL5 5UH Harpenden
    Hertfordshire
    Amministratore
    2 St Paul's Close
    AL5 5UH Harpenden
    Hertfordshire
    UkBritish11302410002
    FALCONER, Ian
    Cottington House
    Cottington Hill
    RG26 5UD Hannington
    Hampshire
    Segretario
    Cottington House
    Cottington Hill
    RG26 5UD Hannington
    Hampshire
    British49402550006
    GORMAN, Jeremy Philip
    19 Connaught Square
    W2 2HJ London
    Segretario
    19 Connaught Square
    W2 2HJ London
    British3290440003
    ALIKHANI, Masoud
    10a Oakhill Avenue
    Hampstead
    NW3 7RE London
    Amministratore
    10a Oakhill Avenue
    Hampstead
    NW3 7RE London
    British5410440001
    CHANDOS, Thomas Orlando, Viscount
    149 Gloucester Avenue
    NW1 8LA London
    Amministratore
    149 Gloucester Avenue
    NW1 8LA London
    EnglandBritish34942190003
    EDMONDS, Philippe Henri
    26 Elgin Crescent
    W11 2JR London
    Amministratore
    26 Elgin Crescent
    W11 2JR London
    United KingdomBritish8594220001
    ENOCH, Philip Maurice
    16 Hampstead Way
    NW11 7LS London
    Amministratore
    16 Hampstead Way
    NW11 7LS London
    United KingdomBritish9554600001
    FALCONER, Ian
    Cottington House
    Cottington Hill
    RG26 5UD Hannington
    Hampshire
    Amministratore
    Cottington House
    Cottington Hill
    RG26 5UD Hannington
    Hampshire
    EnglandBritish49402550006
    GLASS, Colin Howard
    Little Coppice
    Pinewood Road
    SL0 0NJ Iver Heath
    Buckinghamshire
    Amministratore
    Little Coppice
    Pinewood Road
    SL0 0NJ Iver Heath
    Buckinghamshire
    EnglandBritish49754080001
    GRANT-RENNICK, Simon Richard De Clanay
    Elysium
    162 Somerset Road
    FOREIGN Sandys
    Bermuda
    Amministratore
    Elysium
    162 Somerset Road
    FOREIGN Sandys
    Bermuda
    British31567380001
    HILLEL, David
    59 Brampton Grove
    Hendon
    NW4 4AH London
    Amministratore
    59 Brampton Grove
    Hendon
    NW4 4AH London
    British15888600001
    MOSHIRI, Ardavan Farhad
    56h Randolph Avenue
    W9 1BE London
    Amministratore
    56h Randolph Avenue
    W9 1BE London
    EnglandBritish8554620001
    OWEN, David Anthony Llewellyn, Lord
    78 Narrow Street
    E14 8BP London
    Amministratore
    78 Narrow Street
    E14 8BP London
    United KingdomBritish68807910001
    PORT, David Charles
    Hollins Lane
    Marple Bridge
    SK6 5BD Stockport
    Canarino
    Cheshire
    United Kingdom
    Amministratore
    Hollins Lane
    Marple Bridge
    SK6 5BD Stockport
    Canarino
    Cheshire
    United Kingdom
    United KingdomBritish131655680001
    RATCLIFFE, Martyn Roy
    Grayshurst
    Highercombe Road
    GU27 2LH Haslemere
    Surrey
    Amministratore
    Grayshurst
    Highercombe Road
    GU27 2LH Haslemere
    Surrey
    EnglandBritish58344960004
    SPRATLING, Ian Peter
    Llwyn Yr Eos
    Llangennech
    SA14 8YD Llanelli
    Carmarthenshire
    Amministratore
    Llwyn Yr Eos
    Llangennech
    SA14 8YD Llanelli
    Carmarthenshire
    British14180710001
    UGAROV, Alexei
    Mikroraion Zhukovka 16-10
    Stary Oskol Belgorod Region
    Russia 309530
    Amministratore
    Mikroraion Zhukovka 16-10
    Stary Oskol Belgorod Region
    Russia 309530
    Russian52834670001
    USMANOV, Alisher Burkhanovich
    Ap 15 House 31 Per Sivtsev Vrazhek
    Moscow
    Russia
    Amministratore
    Ap 15 House 31 Per Sivtsev Vrazhek
    Moscow
    Russia
    RussiaRussian53576520001
    VLADISLAVLEV, Alander
    1014 Staraya Ploschad
    103070 Moscow
    Russia
    Amministratore
    1014 Staraya Ploschad
    103070 Moscow
    Russia
    Russian40614400001
    WAIN, Roger Henry Ashley
    Sulgrave House Little Street
    Sulgrave
    OX17 2SG Banbury
    Oxfordshire
    Amministratore
    Sulgrave House Little Street
    Sulgrave
    OX17 2SG Banbury
    Oxfordshire
    British20999140003
    WEST, James Glynn
    Orchard House The Street
    Eastling
    ME13 0AZ Faversham
    Kent
    Amministratore
    Orchard House The Street
    Eastling
    ME13 0AZ Faversham
    Kent
    EnglandBritish2136250001
    WINER, Marc Alan
    21 Trevor Place
    SW7 1LB London
    Amministratore
    21 Trevor Place
    SW7 1LB London
    EnglandAmerican83743470001
    WOLFF, John Philip Anthony
    Nashleigh Farm
    Ashleigh Green Road
    HP5 3PF Chesham
    Buckinghamshire
    Amministratore
    Nashleigh Farm
    Ashleigh Green Road
    HP5 3PF Chesham
    Buckinghamshire
    United KingdomBritish10969520001
    WOODS, Dennis Laurence
    Birch Hall
    Church Road
    GU20 6BN Windlesham
    Surrey
    Amministratore
    Birch Hall
    Church Road
    GU20 6BN Windlesham
    Surrey
    EnglandEnglish19765000002

    GNE GROUP LIMITED ha ipoteche?

    Ipoteche
    ClassificazioneDateStatoDettagli
    Deed of charge over credit balances
    Creato il 22 set 2003
    Consegnato il 03 ott 2003
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Barclays bank PLC re global natural energy PLC business premium account account number 80410896.
    Persone aventi diritto
    • Barclays Bank PLC
    Transazioni
    • 03 ott 2003Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 24 gen 2007Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Charge over cash deposits
    Creato il 07 set 1998
    Consegnato il 12 set 1998
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    The principal sums from time to time standing to the credit of the companys deposit account held with the bank to include interest accrued on such principal sums.
    Persone aventi diritto
    • United Mizrahi Bank Limited
    Transazioni
    • 12 set 1998Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 11 set 2000Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Assignment of documents goods and proceeds financed by the bank
    Creato il 07 set 1998
    Consegnato il 12 set 1998
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    All bills of lading airway bills ships delivery orders dock and warehouse warrants and all other documents of title relating to goods and products specified in any letter of credit issued by the bank at the company's request or in any agreement for finance made between the bank and the company hereafter together with all legal title to any goods and products the subject thereof all policies of insurance in connection with the goods and the proceeds of sal thererof. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • United Mizrahi Bank Limited
    Transazioni
    • 12 set 1998Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 11 set 2000Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Charge over loan stock
    Creato il 25 ott 1996
    Consegnato il 13 nov 1996
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    £827,282.26 now due or to become due from the company to the chargees pursuant to the terms of the charge
    Brevi particolari
    The sum of £827,282.26 deposited with an account in the name of middlesex holdings PLC at national westminster bank PLC or such sum as may remain on deposit with such account. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Ian Peter Spratling Robin Alastair Parris Leslie Sidney Christmas and Judith M. Jones
    Transazioni
    • 13 nov 1996Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 03 set 2008Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Equitable charge over shares
    Creato il 28 giu 1996
    Consegnato il 18 lug 1996
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever pursuant to the facility documents (as defined)
    Brevi particolari
    All stock, shares, warrants or other securities, rights dividends interest or other property. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • The Anglo-Eastern Trust Limited
    Transazioni
    • 18 lug 1996Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 11 set 2000Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Debenture
    Creato il 14 mar 1989
    Consegnato il 20 mar 1989
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    (Including trade fixtures). Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Persone aventi diritto
    • Barclays Bank PLC
    Transazioni
    • 20 mar 1989Registrazione di un'ipoteca
    • 09 gen 1996Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)

    GNE GROUP LIMITED ha procedimenti di insolvenza?

    Numero di praticaDateTipoProfessionistiAltro
    1
    DataTipo
    30 set 2009Inizio della liquidazione
    06 giu 2012Data di scioglimento
    Liquidazione volontaria dei soci
    NomeRuoloIndirizzoNominato ilCessato il
    Paul Robert Appleton
    26-28 Bedford Row
    WC1R 4HE London
    Praticante
    26-28 Bedford Row
    WC1R 4HE London

    Fonte dati

    • Companies House del Regno Unito
      Il registro ufficiale delle imprese nel Regno Unito, che fornisce l'accesso pubblico alle informazioni sulle imprese, come nomi, indirizzi, amministratori e depositi finanziari.
    • Licenza: CC0