SUMMIT HOUSE NOMINEES LIMITED

SUMMIT HOUSE NOMINEES LIMITED

  • Panoramica
  • Riepilogo
  • Scopo
  • Indirizzo
  • Bilanci
  • Deposizioni
  • Amministratori
  • Ipoteche
  • Insolvenza
  • Fonte dati
  • Panoramica

    Nome della societàSUMMIT HOUSE NOMINEES LIMITED
    Stato della societàSciolta
    Forma giuridicaSocietà a responsabilità limitata
    Numero di società 01819704
    GiurisdizioneInghilterra/Galles
    Data di costituzione
    Data di cessazione

    Qual è lo scopo di SUMMIT HOUSE NOMINEES LIMITED?

    • (7020) /

    Dove si trova SUMMIT HOUSE NOMINEES LIMITED?

    Indirizzo della sede legale
    Craftwork Studios
    1-3 Dufferin Street
    EC1Y 8NA London
    Indirizzo della sede legale non recapitabileNo

    Quali sono gli ultimi bilanci di SUMMIT HOUSE NOMINEES LIMITED?

    Ultimi bilanci
    Ultimi bilanci redatti al31 dic 2009

    Quali sono le ultime deposizioni per SUMMIT HOUSE NOMINEES LIMITED?

    Deposizioni
    DataDescrizioneDocumentoTipo

    Dichiarazione di beni vacanti

    1 pagineBONA

    Gazzetta ufficiale finale sciolta a seguito di liquidazione

    1 pagineGAZ2

    Ritorno della riunione finale in una liquidazione volontaria dei creditori

    15 pagineLIQ14

    Indirizzo della sede legale modificato da 37 Sun Street London EC2M 2PL a Craftwork Studios 1-3 Dufferin Street London EC1Y 8NA in data 18 mar 2019

    2 pagineAD01

    Dichiarazione dei ricevimenti e dei pagamenti dei liquidatori fino a 30 ott 2018

    16 pagineLIQ03

    Dichiarazione dei ricevimenti e dei pagamenti dei liquidatori fino a 30 ott 2017

    16 pagineLIQ03

    Dichiarazione dei ricevimenti e dei pagamenti dei liquidatori fino a 30 ott 2016

    15 pagine4.68

    Dichiarazione dei ricevimenti e dei pagamenti dei liquidatori fino a 30 ott 2015

    14 pagine4.68

    Indirizzo della sede legale modificato da C/O Valentine & Co 3Rd Floor Shakespeare Road 7 Shakespeare House London N3 1XE a 37 Sun Street London EC2M 2PL in data 26 gen 2015

    2 pagineAD01

    Indirizzo della sede legale modificato da Acre House 11-15 William Road London NW1 3ER a C/O Valentine & Co 3Rd Floor Shakespeare Road 7 Shakespeare House London N3 1XE in data 02 dic 2014

    2 pagineAD01

    Nomina di un liquidatore volontario

    4 pagine600

    Ripristino per ordine del tribunale

    2 pagineAC92

    Gazzetta ufficiale finale sciolta a seguito di liquidazione

    1 pagineGAZ2

    Ritorno della riunione finale in una liquidazione volontaria dei creditori

    15 pagine4.72

    Dichiarazione dei ricevimenti e dei pagamenti dei liquidatori fino a 07 nov 2013

    14 pagine4.68

    Dichiarazione dei ricevimenti e dei pagamenti dei liquidatori fino a 07 nov 2012

    10 pagine4.68

    Indirizzo della sede legale modificato da * 9 Great Chesterford Court London Road Great Chesterford Essex CB10 1PF* in data 18 nov 2011

    2 pagineAD01

    Dichiarazione delle attività con il modulo allegato 4.19

    6 pagine4.20

    Nomina di un liquidatore volontario

    1 pagine600

    Risoluzioni

    Resolutions
    1 pagineRESOLUTIONS
    Risoluzioni
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    liquidation

    Risoluzione straordinaria per la liquidazione

    LRESEX

    legacy

    12 pagineMG02

    Nomina di Mr Daniel Anthony Brown come segretario

    2 pagineAP03

    Cessazione della carica di Stuart Ansher come segretario

    1 pagineTM02

    Bilancio annuale redatto al 05 nov 2010 con elenco completo degli azionisti

    5 pagineAR01
    Deposizioni associate
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    capital09 nov 2010

    Stato del capitale al 09 nov 2010

    • Capitale: GBP 100
    SH01

    Dettagli del direttore cambiati per Jaqueline Linda Selby il 04 ott 2010

    2 pagineCH01

    Chi sono gli amministratori di SUMMIT HOUSE NOMINEES LIMITED?

    Amministratori
    NomeNominato ilDimissioni ilRuoloIndirizzoIdentificazione della societàPaese di residenzaNazionalitàData di nascitaProfessioneNumero
    BROWN, Daniel Anthony
    45-46 Berners Street
    W1T 3NE London
    2nd Floor
    Segretario
    45-46 Berners Street
    W1T 3NE London
    2nd Floor
    158402110001
    SELBY, Jaqueline Linda
    Floor
    45-46 Berners Street
    W1T 3NE London
    2nd
    United Kingdom
    Amministratore
    Floor
    45-46 Berners Street
    W1T 3NE London
    2nd
    United Kingdom
    EnglandBritish37391970001
    SELBY, Richard Grant
    Floor
    45-46 Berners Street
    W1T 3NE London
    2nd
    United Kingdom
    Amministratore
    Floor
    45-46 Berners Street
    W1T 3NE London
    2nd
    United Kingdom
    United KingdomBritish44845820006
    ALWIS, Mewan
    Green Island Lodge Hillside Road
    HA5 3YJ Pinner Hill
    Middlesex
    Segretario
    Green Island Lodge Hillside Road
    HA5 3YJ Pinner Hill
    Middlesex
    British157112310001
    ANSHER, Stuart
    17 Francklyn Gardens
    HA8 8RT Edgware
    Middlesex
    Segretario
    17 Francklyn Gardens
    HA8 8RT Edgware
    Middlesex
    British115250060001
    KAY, Rita
    15 Coningsby Court
    The Dell
    WD7 8JH Radlett
    Hertfordshire
    Segretario
    15 Coningsby Court
    The Dell
    WD7 8JH Radlett
    Hertfordshire
    British97665520001
    SELBY, Harvey
    5 Grantham Close
    Brockley Hill
    HA8 8DL Edgware
    Middlesex
    Segretario
    5 Grantham Close
    Brockley Hill
    HA8 8DL Edgware
    Middlesex
    British37391930001
    SELBY, Jaqueline Linda
    5 Grantham Close
    Brockley Hill
    HA8 8DL Edgware
    Middlesex
    Segretario
    5 Grantham Close
    Brockley Hill
    HA8 8DL Edgware
    Middlesex
    British37391970001
    SELBY, Andrew Dean
    37 Harman Drive
    NW2 2ED London
    Amministratore
    37 Harman Drive
    NW2 2ED London
    United KingdomBritish59770850003
    SELBY, Harvey
    5 Grantham Close
    Brockley Hill
    HA8 8DL Edgware
    Middlesex
    Amministratore
    5 Grantham Close
    Brockley Hill
    HA8 8DL Edgware
    Middlesex
    British37391930001

    SUMMIT HOUSE NOMINEES LIMITED ha ipoteche?

    Ipoteche
    ClassificazioneDateStatoDettagli
    Mortgage
    Creato il 14 lug 2006
    Consegnato il 27 lug 2006
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    4,9,14,17,18,21,22,31-33 all saints drive sutton coldfield west midlands t/no WM715021 4 ashburn walk paignton devon t/no DN426133 8 avon close neston cheshire t/no CH268420 for details of further properties charged please refer to the form 395. together with all buildings and fixtures (including trade fixtures) fixed plant and machinery by way of fixed charge all present and future book and other debts floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment by way of assignment the goodwill of the business (if any) the full benefit of all licences and all guarantees. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Lloyds Tsb Bank PLC
    Transazioni
    • 27 lug 2006Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 06 ott 2011Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (MG02)
    Legal charge
    Creato il 07 apr 2006
    Consegnato il 12 apr 2006
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    All f/h properties under t/nos AV93175 B. together with all buildings fixtures (including trade fixtures) fixed plant and machinery thereon the goodwill of any business carried on at the property the benefit of any licences and registrations required in the running of such business. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Nationwide Building Society
    Transazioni
    • 12 apr 2006Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 13 apr 2007Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Legal charge
    Creato il 24 gen 2000
    Consegnato il 27 gen 2000
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Various properties shown on the schedules attached to the form 395 the first three of which are 2 nash square, 4 beresford drive and 5 highcroft drive see form 395 for further details. Together with all buildings fixtures (including trade fixtures) fixed plant and machinery thereon the goodwill of any business carried on at the property the benefit of any licences and registrations required in the running of such business.
    Persone aventi diritto
    • Nationwide Building Society
    Transazioni
    • 27 gen 2000Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 13 apr 2007Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Legal charge
    Creato il 24 gen 2000
    Consegnato il 27 gen 2000
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    66 jordan avenue stretton burton on trent and 5 and 16 thornhill drive stretton. Together with all buildings fixtures (including trade fixtures) fixed plant and machinery thereon the goodwill of any business carried on at the property the benefit of any licences and registrations required in the running of such business.
    Persone aventi diritto
    • Nationwide Building Society
    Transazioni
    • 27 gen 2000Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 13 apr 2007Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Legal charge
    Creato il 24 gen 2000
    Consegnato il 27 gen 2000
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    2,3, 22-24, 26-29, 31-33, 35,37-39, 63-65 and 67 lyndale road weston-super-mare and 15 and 23 drake road weston-super-mere and 2,3, 5-8, 23, 24, 26, 27, 29, 31-33, and 35-38 crantock road weston. Together with all buildings fixtures (including trade fixtures) fixed plant and machinery thereon the goodwill of any business carried on at the property the benefit of any licences and registrations required in the running of such business.
    Persone aventi diritto
    • Nationwide Building Society
    Transazioni
    • 27 gen 2000Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 13 apr 2007Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Debenture
    Creato il 24 gen 2000
    Consegnato il 27 gen 2000
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    A floating charge over the undertaking and all rights properties and assets present and future.
    Persone aventi diritto
    • Nationwide Building Society
    Transazioni
    • 27 gen 2000Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 13 apr 2007Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Legal charge
    Creato il 24 gen 2000
    Consegnato il 27 gen 2000
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    7 and 51 ferrers avenue tutbury burton on trent. Together with all buildings fixtures (including trade fixtures) fixed plant and machinery thereon the goodwill of any business carried on at the property the benefit of any licences and registrations required in the running of such business.
    Persone aventi diritto
    • Nationwide Building Society
    Transazioni
    • 27 gen 2000Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 13 apr 2007Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Debenture
    Creato il 03 mag 1995
    Consegnato il 12 mag 1995
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Persone aventi diritto
    • The Royal Bank of Scotland PLC
    Transazioni
    • 12 mag 1995Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 04 apr 2002Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Charge
    Creato il 05 lug 1984
    Consegnato il 11 lug 1984
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Charges by way of security all the obligations & liabilities of the company to the bank by way of first floating charge the company's undertaking, and property.
    Persone aventi diritto
    • The Royal Bank of Scotland PLC
    Transazioni
    • 11 lug 1984Registrazione di un'ipoteca
    • 05 feb 1998Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)

    SUMMIT HOUSE NOMINEES LIMITED ha procedimenti di insolvenza?

    Numero di praticaDateTipoProfessionistiAltro
    1
    DataTipo
    08 nov 2011Inizio della liquidazione
    21 feb 2020Data di scioglimento
    Liquidazione volontaria dei creditori
    NomeRuoloIndirizzoNominato ilCessato il
    David Birne
    Fisher Partners
    Acre House
    NW1 3ER 11-15 William Road
    London
    Praticante
    Fisher Partners
    Acre House
    NW1 3ER 11-15 William Road
    London
    Brian N Johnson
    Fisher Partners
    Acre House
    NW1 3ER 11-15 William Road
    London
    Praticante
    Fisher Partners
    Acre House
    NW1 3ER 11-15 William Road
    London
    Lane Gary Bednash
    3rd Floor Shakespeare House 7 Shakespeare Road
    N3 1XE London
    Praticante
    3rd Floor Shakespeare House 7 Shakespeare Road
    N3 1XE London

    Fonte dati

    • Companies House del Regno Unito
      Il registro ufficiale delle imprese nel Regno Unito, che fornisce l'accesso pubblico alle informazioni sulle imprese, come nomi, indirizzi, amministratori e depositi finanziari.
    • Licenza: CC0