CAPITAL BANK LEASING 2 LIMITED
Panoramica
Nome della società | CAPITAL BANK LEASING 2 LIMITED |
---|---|
Stato della società | Sciolta |
Forma giuridica | Società a responsabilità limitata |
Numero di società | 01826100 |
Giurisdizione | Inghilterra/Galles |
Data di costituzione | |
Data di cessazione |
Riepilogo
Ha PSCs super sicuri | No |
---|---|
Ha ipoteche | Sì |
Ha una storia di insolvenza | Sì |
La sede legale è in contestazione | No |
Qual è lo scopo di CAPITAL BANK LEASING 2 LIMITED?
- Società inattiva (99999) / Attività di organizzazioni ed organismi extraterritoriali
Dove si trova CAPITAL BANK LEASING 2 LIMITED?
Indirizzo della sede legale | 1 More London Place SE1 2AF London |
---|---|
Indirizzo della sede legale non recapitabile | No |
Quali erano i nomi precedenti di CAPITAL BANK LEASING 2 LIMITED?
Nome della società | Da | A |
---|---|---|
NWS 2 LIMITED | 28 nov 1985 | 28 nov 1985 |
NEATLANCE LIMITED | 20 giu 1984 | 20 giu 1984 |
Quali sono gli ultimi bilanci di CAPITAL BANK LEASING 2 LIMITED?
Ultimi bilanci | |
---|---|
Ultimi bilanci redatti al | 29 feb 2016 |
Quali sono le ultime deposizioni per CAPITAL BANK LEASING 2 LIMITED?
Data | Descrizione | Documento | Tipo | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gazzetta ufficiale finale sciolta a seguito di liquidazione | 1 pagine | GAZ2 | ||||||||||
Dettagli del direttore cambiati per Mr Richard Andrew Jones il 25 gen 2019 | 2 pagine | CH01 | ||||||||||
Ritorno della riunione finale in una liquidazione volontaria dei membri | 10 pagine | LIQ13 | ||||||||||
I registri sono stati trasferiti al luogo di ispezione registrato Tower House Charterhall Drive Chester CH88 3AN | 2 pagine | AD03 | ||||||||||
Indirizzo della sede legale modificato da Charterhall House Charterhall Drive Chester Cheshire CH88 3AN a 1 More London Place London SE1 2AF in data 19 apr 2018 | 2 pagine | AD01 | ||||||||||
L'indirizzo di ispezione del registro è stato modificato a Tower House Charterhall Drive Chester CH88 3AN | 2 pagine | AD02 | ||||||||||
Dichiarazione di solvibilità | 6 pagine | LIQ01 | ||||||||||
Nomina di un liquidatore volontario | 4 pagine | 600 | ||||||||||
Risoluzioni Resolutions | 1 pagine | RESOLUTIONS | ||||||||||
| ||||||||||||
Dichiarazione di conformità presentata il 01 feb 2018 con aggiornamenti | 4 pagine | CS01 | ||||||||||
Nomina di Mr Christopher Michael Adams come amministratore in data 25 gen 2018 | 2 pagine | AP01 | ||||||||||
Cessazione della carica di John Paul Moore come amministratore in data 31 dic 2017 | 1 pagine | TM01 | ||||||||||
Esercizio contabile precedente prorogato dal 28 feb 2017 al 28 ago 2017 | 1 pagine | AA01 | ||||||||||
Dichiarazione di conformità presentata il 01 feb 2017 con aggiornamenti | 5 pagine | CS01 | ||||||||||
Nomina di Mr David Dermot Hennessey come segretario in data 25 gen 2017 | 2 pagine | AP03 | ||||||||||
Cessazione della carica di Paul Gittins come segretario in data 25 gen 2017 | 1 pagine | TM02 | ||||||||||
Bilancio redatto al 29 feb 2016 | 23 pagine | AA | ||||||||||
Cessazione della carica di Paul Gerard Christopher Mcgill come amministratore in data 27 mag 2016 | 1 pagine | TM01 | ||||||||||
Nomina di Mr Richard Andrew Jones come amministratore in data 27 mag 2016 | 2 pagine | AP01 | ||||||||||
Cessazione della carica di Jonathan Stewart Roberts come amministratore in data 27 mag 2016 | 1 pagine | TM01 | ||||||||||
Bilancio annuale redatto al 01 feb 2016 con elenco completo degli azionisti | 6 pagine | AR01 | ||||||||||
| ||||||||||||
Bilancio redatto al 28 feb 2015 | 24 pagine | AA | ||||||||||
Bilancio annuale redatto al 01 feb 2015 con elenco completo degli azionisti | 6 pagine | AR01 | ||||||||||
| ||||||||||||
Nomina di Mr Jonathan Stewart Roberts come amministratore in data 23 dic 2014 | 2 pagine | AP01 | ||||||||||
Nomina di Mr Paul Gerard Christopher Mcgill come amministratore in data 23 dic 2014 | 2 pagine | AP01 | ||||||||||
Chi sono gli amministratori di CAPITAL BANK LEASING 2 LIMITED?
Nome | Nominato il | Dimissioni il | Ruolo | Indirizzo | Identificazione della società | Paese di residenza | Nazionalità | Data di nascita | Professione | Numero |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HENNESSEY, David Dermot | Segretario | Charterhall Drive CH88 3AN Chester Tower House United Kingdom | 223286790001 | |||||||
ADAMS, Christopher Michael | Amministratore | Tresillian Terrace CF10 5BH Cardiff St William House United Kingdom | United Kingdom | British | Director | 195547990001 | ||||
JONES, Richard Andrew | Amministratore | 37 South Gyle Crescent EH12 9DS Edinburgh Ettrick House United Kingdom | United Kingdom | British | Director | 130118640005 | ||||
GITTINS, Paul | Segretario | House Charterhall Drive CH88 3AN Chester Tower United Kingdom | British | 45660860003 | ||||||
NIXON, Raymond | Segretario | Holly House The Steadings Wicker Lane, Guilden Sutton CH3 7EL Chester Cheshire | British | 36433110016 | ||||||
BALLINGALL, Stuart James | Amministratore | 39 Craigleith Drive EH4 3JU Edinburgh Midlothian | British | Chartered Accountant | 118506820001 | |||||
BARCLAY, William Gordon | Amministratore | The Coulin 122 Stanstead Road CR3 6AE Caterham Surrey | British | Director | 33196560002 | |||||
BLACKWELL, Timothy Mark | Amministratore | Tresillian Terrace CF10 5BH Cardiff St William House United Kingdom | England | British | Director | 124967310001 | ||||
BOCHENSKI, Anthony Joseph John | Amministratore | Greenacres Bryn Offa Lane CH7 6RQ Mold Flintshire | United Kingdom | British | Company Solicitor | 145644720001 | ||||
BROWN, John Sydney | Amministratore | 15 Newick Avenue Little Aston B74 3DA Sutton Coldfield West Midlands | United Kingdom | British | Company Director | 58961420001 | ||||
BUSH, Claude Harry | Amministratore | 51 Church Croft Dodleston CH4 9NT Chester Cheshire | British | Company Director | 427540002 | |||||
CHESSMAN, Steven David Russell | Amministratore | Charterhall Drive CH88 3AN Chester Tower House United Kingdom | England | British | Sales Director | 135147710001 | ||||
EDWARDS, Jayson | Amministratore | Tresillian Terrace CF10 5BH Cardiff St William House United Kingdom | Wales | British | Accountant | 165227870001 | ||||
FERGUSON, Gordon | Amministratore | St Vincent Street G2 5ER Glasgow 110 United Kingdom | Scotland | British | Head Of Operations | 87681450001 | ||||
GRACE, Adrian Thomas | Amministratore | Charterhall Drive CH88 3AN Chester Charterhall House Cheshire | British | Managing Director | 128752720001 | |||||
GRIFFITHS, Michael John David, Mr. | Amministratore | House Charterhall Drive CH88 3AN Chester Tower United Kingdom | United Kingdom | British | Director | 95344900001 | ||||
HAMMOND, John Sidney | Amministratore | 65 Poulton Road Spital L63 9LD Bebington Merseyside | British | Assistant General Manager | 102290001 | |||||
HARE, Robert Brown | Amministratore | 13 Balgreen Avenue EH12 5SX Edinburgh Lothian | British | Director | 64474720003 | |||||
LITTLER, Roy | Amministratore | 3 The Paddock Curzon Park CH4 8AE Chester Cheshire | British | Deputy Managing Director | 2211250001 | |||||
MCGILL, Paul Gerard Christopher | Amministratore | Tresillian Terrace CF10 5BH Cardiff St William House United Kingdom | United Kingdom | British | Director | 98969570001 | ||||
MERCER, John Alexander | Amministratore | Llwyn-Y-Cyll Lixwm CH8 8LY Holywell Clwyd | British | Managing Director | 4672880001 | |||||
MOORE, John Paul | Amministratore | Old Broad Street EC2N 1HZ London 33 United Kingdom | England | British | Director | 193660300001 | ||||
MORRISSEY, John Michael | Amministratore | House Charterhall Drive CH88 3AN Chester Tower United Kingdom | England | British | Chartered Accountant | 94094650001 | ||||
PERRY, Michael Richard | Amministratore | 10 The Paddock Willaston CW5 7HJ Nantwich Cheshire | British | Company Director | 102300002 | |||||
REID, George Gibson | Amministratore | 46/1 Morningside Park EH10 5HA Edinburgh Lothian | British | Accountant | 95498730001 | |||||
RITCHIE, Carol Ann | Amministratore | 34 Hob Hey Lane Culcheth WA3 4NW Warrington Cheshire | England | British | Finance Director | 46402710001 | ||||
ROBERTS, Jonathan Stewart | Amministratore | Old Broad Street EC2N 1HZ London 33 United Kingdom | United Kingdom | British | Director | 127524890001 | ||||
SKINNER, Trevor John | Amministratore | 2 Tudor Court B95 4AP Henly In Arden Warwickshire | British | Assistant General Manager | 427570015 | |||||
STAPLES, Martin Kenneth | Amministratore | 1 Douglas Drive Crossford KY12 8PB Dunfermline Fife | Scotland | British | Accountant | 110383950001 | ||||
SUTTON, Christopher | Amministratore | Orchard Brae EH4 1PF Edinburgh Finance House United Kingdom | Scotland | British | Managing Director | 130660440002 | ||||
TOWN, Lindsay John | Amministratore | 10 Ferndale TN2 3PB Tunbridge Wells Kent | England | British | Managing Director | 64287260001 | ||||
TRACE, James Owen | Amministratore | House Charterhall Drive CH88 3AN Chester Tower United Kingdom | England | British | Senior Manager | 159477760001 | ||||
WEBSTER, Alistair Linn | Amministratore | 7 Ettrick Road EH10 5BJ Edinburgh | Scotland | British | Accountant | 60101190002 |
Chi sono le persone con controllo significativo di CAPITAL BANK LEASING 2 LIMITED?
Nome | Notificato il | Indirizzo | Cessato | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bank Of Scotland Plc | 06 apr 2016 | EH1 1YZ Edinburgh The Mound United Kingdom | No | ||||||||||
| |||||||||||||
Natura del controllo
|
CAPITAL BANK LEASING 2 LIMITED ha ipoteche?
Classificazione | Date | Stato | Dettagli | |
---|---|---|---|---|
Letter of charge | Creato il 19 giu 1996 Consegnato il 10 lug 1996 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due or to become due from the company and/or all or any of the other companies named therein to the chargee on any account whatsoever | |
Brevi particolari All monies standing to the credit of any account or accounts in the banks books. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
Letter of charge | Creato il 20 feb 1995 Consegnato il 22 feb 1995 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due or to become due from the principal debtors (as defined) to the chargee on any account whatsoever | |
Brevi particolari All monies standing to the credit of any account (s) of the company in the banks books. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
Letter of charge | Creato il 13 dic 1994 Consegnato il 23 dic 1994 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due or to become due from capital incentives PLC and/or all or any of the other companies named therein to the chargee on any account whatsoever | |
Brevi particolari All monies now or at any time hereafter standing to the credit of any account or accounts of the company in the bank's books. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
Letter of charge | Creato il 12 ago 1993 Consegnato il 20 ago 1993 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due or to become due from the company and/or any of the other companys named therein to the chargee on any account whatsoever | |
Brevi particolari All monies now or at any time herafter standing to the credit of any accounts of the company in the banks books. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
|
CAPITAL BANK LEASING 2 LIMITED ha procedimenti di insolvenza?
Numero di pratica | Date | Tipo | Professionisti | Altro | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
| Liquidazione volontaria dei soci |
|
Fonte dati
- Companies House del Regno Unito
Il registro ufficiale delle imprese nel Regno Unito, che fornisce l'accesso pubblico alle informazioni sulle imprese, come nomi, indirizzi, amministratori e depositi finanziari. - Licenza: CC0