MATHER & STUART GENERATORS LIMITED
Panoramica
Nome della società | MATHER & STUART GENERATORS LIMITED |
---|---|
Stato della società | Sciolta |
Forma giuridica | Società a responsabilità limitata |
Numero di società | 01828108 |
Giurisdizione | Inghilterra/Galles |
Data di costituzione | |
Data di cessazione |
Riepilogo
Ha PSCs super sicuri | No |
---|---|
Ha ipoteche | Sì |
Ha una storia di insolvenza | No |
La sede legale è in contestazione | No |
Qual è lo scopo di MATHER & STUART GENERATORS LIMITED?
- Noleggio di macchine e attrezzature per l'edilizia e l'ingegneria civile (77320) / Attività amministrative e di supporto
Dove si trova MATHER & STUART GENERATORS LIMITED?
Indirizzo della sede legale | 100 Cheapside EC2V 6DT London England |
---|---|
Indirizzo della sede legale non recapitabile | No |
Quali erano i nomi precedenti di MATHER & STUART GENERATORS LIMITED?
Nome della società | Da | A |
---|---|---|
MATHER & STUART LIMITED | 20 mar 2000 | 20 mar 2000 |
MATHER & STUART (PLANT HIRE & SERVICES) LIMITED | 26 set 1984 | 26 set 1984 |
MATHER & STEWART (PLANT HIRE & SERVICES) LIMITED | 27 giu 1984 | 27 giu 1984 |
Quali sono gli ultimi bilanci di MATHER & STUART GENERATORS LIMITED?
Ultimi bilanci | |
---|---|
Ultimi bilanci redatti al | 31 dic 2015 |
Quali sono le ultime deposizioni per MATHER & STUART GENERATORS LIMITED?
Data | Descrizione | Documento | Tipo | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gazzetta Ufficiale finale sciolta per scioglimento volontario | 1 pagine | GAZ2(A) | ||||||||||||||
Prima Gazzetta Ufficiale per lo scioglimento volontario | 1 pagine | GAZ1(A) | ||||||||||||||
Richiesta di cancellazione della società dal registro | 3 pagine | DS01 | ||||||||||||||
Dichiarazione di conformità presentata il 31 dic 2016 con aggiornamenti | 6 pagine | CS01 | ||||||||||||||
Soddisfazione dell'onere 018281080006 in pieno | 1 pagine | MR04 | ||||||||||||||
Soddisfazione dell'onere 4 in pieno | 1 pagine | MR04 | ||||||||||||||
Soddisfazione dell'onere 018281080007 in pieno | 1 pagine | MR04 | ||||||||||||||
Soddisfazione dell'onere 018281080008 in pieno | 1 pagine | MR04 | ||||||||||||||
Modifica del nome o della denominazione della classe di azioni | 2 pagine | SH08 | ||||||||||||||
Dettagli della variazione dei diritti legati alle azioni | 2 pagine | SH10 | ||||||||||||||
Nomina di Mr Richard David Thomas come amministratore in data 20 mag 2016 | 2 pagine | AP01 | ||||||||||||||
Risoluzioni Resolutions | 13 pagine | RESOLUTIONS | ||||||||||||||
| ||||||||||||||||
Bilancio redatto al 31 dic 2015 | 26 pagine | AA | ||||||||||||||
Esercizio contabile in corso prorogato dal 31 dic 2016 al 30 apr 2017 | 1 pagine | AA01 | ||||||||||||||
Indirizzo della sede legale modificato da Suite 1.3 20 Market Street Altrincham Cheshire WA14 1PF a 100 Cheapside London EC2V 6DT in data 23 mag 2016 | 1 pagine | AD01 | ||||||||||||||
Nomina di Mr Eric Watkins come segretario in data 20 mag 2016 | 2 pagine | AP03 | ||||||||||||||
Cessazione della carica di Mark Stuart come amministratore in data 20 mag 2016 | 1 pagine | TM01 | ||||||||||||||
Cessazione della carica di Lee Stuart come amministratore in data 20 mag 2016 | 1 pagine | TM01 | ||||||||||||||
Cessazione della carica di Patricia Abbott come amministratore in data 20 mag 2016 | 1 pagine | TM01 | ||||||||||||||
Cessazione della carica di Geoffrey Robinson come amministratore in data 20 mag 2016 | 1 pagine | TM01 | ||||||||||||||
Nomina di Mr Philip John Parker come amministratore in data 20 mag 2016 | 2 pagine | AP01 | ||||||||||||||
Nomina di Mr Satpal Singh Dhaiwal come amministratore in data 20 mag 2016 | 2 pagine | AP01 | ||||||||||||||
Nomina di Mr Michael Richard Pratt come amministratore in data 20 mag 2016 | 2 pagine | AP01 | ||||||||||||||
Cessazione della carica di Keith George Sadler come amministratore in data 09 mar 2016 | 1 pagine | TM01 | ||||||||||||||
Bilancio annuale redatto al 31 dic 2015 con elenco completo degli azionisti | 7 pagine | AR01 | ||||||||||||||
| ||||||||||||||||
Chi sono gli amministratori di MATHER & STUART GENERATORS LIMITED?
Nome | Nominato il | Dimissioni il | Ruolo | Indirizzo | Identificazione della società | Paese di residenza | Nazionalità | Data di nascita | Professione | Numero |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WATKINS, Eric | Segretario | Cheapside EC2V 6DT London 100 England | 208412350001 | |||||||
DHAIWAL, Satpal Singh | Amministratore | Cheapside EC2V 6DT London 100 England | United Kingdom | British | Director | 58977720002 | ||||
PARKER, Philip John | Amministratore | Cheapside EC2V 6DT London 100 England | England | British | Director | 205532770001 | ||||
PRATT, Michael Richard | Amministratore | Cheapside EC2V 6DT London 100 England | England | British | Director | 37254010002 | ||||
THOMAS, Richard David | Amministratore | Cheapside EC2V 6DT London 100 England | England | British | Director | 171245630001 | ||||
BLACK, Gary | Segretario | Ringley Road Whitefield M45 7ZZ Manchester Stand Old Hall | British | 129405360001 | ||||||
MATHER, Anthony | Segretario | 15 Oakleigh Crawford Village WN8 9QU Upholland Lancashire | British | 122804070001 | ||||||
STUART, Frederick John | Segretario | 7 Mendip Avenue Winstanley WN3 6EB Wigan Lancashire | British | 8023770001 | ||||||
ABBOTT, Patricia Edna | Amministratore | 20 Market Street WA14 1PF Altrincham Suite 1.3 Cheshire United Kingdom | England | British | Finance Director | 149432430001 | ||||
BULLOCK, Michael Noel | Amministratore | 20 Market Street WA14 1PF Altrincham Suite 1.3 Cheshire United Kingdom | England | British | Director | 152584260001 | ||||
MATHER, William John | Amministratore | 3 Oleander Drive Eccleston WA10 4EX St Helens Merseyside | British | Company Director | 14330620002 | |||||
ROBINSON, Geoffrey | Amministratore | 20 Market Street WA14 1PF Altrincham Suite 1.3 Cheshire United Kingdom | England | British | Director | 149576770001 | ||||
SADLER, Keith George | Amministratore | 20 Market Street WA14 1PF Altrincham Suite 1.3 Cheshire | United Kingdom | British | Director | 142771320002 | ||||
STUART, Frederick John | Amministratore | 7 Mendip Avenue Winstanley WN3 6EB Wigan Lancashire | United Kingdom | British | Company Director | 8023770001 | ||||
STUART, Lee | Amministratore | Park Avenue Winstanley WN3 6FA Wigan 15 Lancashire | United Kingdom | British | Director | 149439840001 | ||||
STUART, Mark | Amministratore | 20 Market Street WA14 1PF Altrincham Suite 1.3 Cheshire United Kingdom | United Kingdom | British | Director | 149253270001 |
Chi sono le persone con controllo significativo di MATHER & STUART GENERATORS LIMITED?
Nome | Notificato il | Indirizzo | Cessato | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Mather & Stuart Holdings Limited | 06 apr 2016 | Cheapside EC2V 6DT London 100 England | No | ||||
| |||||||
Natura del controllo
|
MATHER & STUART GENERATORS LIMITED ha ipoteche?
Classificazione | Date | Stato | Dettagli | |
---|---|---|---|---|
A registered charge | Creato il 03 ott 2013 Consegnato il 16 ott 2013 | Soddisfatta integralmente | ||
Breve descrizione Unit 74 bradley hall trading estate bradley lane standish wigan. Unit 74L bradley hall trading estate bradley lane standish wigan. Notification of addition to or amendment of charge. L'ipoteca flottante copre tutto: Sì Contiene un'ipoteca flottante: Sì Contiene un'ipoteca fissa: Sì | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
A registered charge | Creato il 03 ott 2013 Consegnato il 09 ott 2013 | Soddisfatta integralmente | ||
Breve descrizione All freehold and leashold properties (whether registered or unregistered) and all commonhold properties, now or in the future (and from time to time) owned by the charging companies or any of them, or which the charging companies or any of them holds an interest.. Notification of addition to or amendment of charge. L'ipoteca flottante copre tutto: Sì Contiene un'ipoteca flottante: Sì Contiene un'ipoteca fissa: Sì | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
A registered charge | Creato il 06 ago 2013 Consegnato il 07 ago 2013 | Soddisfatta integralmente | ||
Breve descrizione Notification of addition to or amendment of charge. Contiene un'ipoteca fissa: Sì | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
Debenture | Creato il 28 dic 2008 Consegnato il 30 dic 2008 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Brevi particolari Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
Debenture | Creato il 19 dic 2008 Consegnato il 23 dic 2008 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Brevi particolari Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
Master agreement | Creato il 21 apr 1997 Consegnato il 24 apr 1997 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Brevi particolari All the company's rights title and interest in the sub-hire agreements described in the supplementary schedules from time to time entered into pursuant to the master agreements and in all ancillary contracts relating thereto and all (if any) the rights of the company to acquire title in the goods forming the subject matter thereof. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
Mortgage debenture | Creato il 13 ott 1987 Consegnato il 21 ott 1987 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Brevi particolari A specific equitable charge over all freehold and leasehold properties and/or the proceeds of sale thereof fixed and floating charges over undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts and the benefits of any licences. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
Debenture | Creato il 07 giu 1985 Consegnato il 14 giu 1985 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Brevi particolari Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital fixtures & fitting fixed plant and machinery. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
|
Fonte dati
- Companies House del Regno Unito
Il registro ufficiale delle imprese nel Regno Unito, che fornisce l'accesso pubblico alle informazioni sulle imprese, come nomi, indirizzi, amministratori e depositi finanziari. - Licenza: CC0