R-ISC INVESTIGATION & SURVEILLANCE COMPANY LIMITED

R-ISC INVESTIGATION & SURVEILLANCE COMPANY LIMITED

  • Panoramica
  • Riepilogo
  • Scopo
  • Indirizzo
  • Denominazioni precedenti
  • Bilanci
  • Deposizioni
  • Amministratori
  • Persone con controllo significativo
  • Ipoteche
  • Insolvenza
  • Fonte dati
  • Panoramica

    Nome della societàR-ISC INVESTIGATION & SURVEILLANCE COMPANY LIMITED
    Stato della societàSciolta
    Forma giuridicaSocietà a responsabilità limitata
    Numero di società 01830660
    GiurisdizioneInghilterra/Galles
    Data di costituzione
    Data di cessazione

    Qual è lo scopo di R-ISC INVESTIGATION & SURVEILLANCE COMPANY LIMITED?

    • Attività di investigazione (80300) / Attività amministrative e di supporto

    Dove si trova R-ISC INVESTIGATION & SURVEILLANCE COMPANY LIMITED?

    Indirizzo della sede legale
    RSM
    Central Square 5th Floor 29 Wellington Street
    LS1 4DL Leeds
    Indirizzo della sede legale non recapitabileNo

    Quali erano i nomi precedenti di R-ISC INVESTIGATION & SURVEILLANCE COMPANY LIMITED?

    Denominazioni sociali precedenti
    Nome della societàDaA
    RENAISSANCE INVESTIGATION & SURVEILLANCE COMPANY LIMITED02 lug 200802 lug 2008
    SPECIALISED INVESTIGATION SERVICES LIMITED06 lug 198406 lug 1984

    Quali sono gli ultimi bilanci di R-ISC INVESTIGATION & SURVEILLANCE COMPANY LIMITED?

    Ultimi bilanci
    Ultimi bilanci redatti al31 mar 2016

    Quali sono le ultime deposizioni per R-ISC INVESTIGATION & SURVEILLANCE COMPANY LIMITED?

    Deposizioni
    DataDescrizioneDocumentoTipo

    Gazzetta ufficiale finale sciolta a seguito di liquidazione

    1 pagineGAZ2

    Ritorno della riunione finale in una liquidazione volontaria dei membri

    15 pagineLIQ13

    Dichiarazione dei ricevimenti e dei pagamenti dei liquidatori fino a 26 set 2018

    15 pagineLIQ03

    Notifica al Registro delle imprese della dichiarazione di disdetta

    4 pagineNDISC

    Indirizzo della sede legale modificato da Liberty House Greenham Business Park Greenham Thatcham RG19 6HW England a Central Square 5th Floor 29 Wellington Street Leeds LS1 4DL in data 19 ott 2017

    2 pagineAD01

    Nomina di un liquidatore volontario

    2 pagine600

    Risoluzioni

    Resolutions
    1 pagineRESOLUTIONS
    Risoluzioni
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    liquidation

    Risoluzione speciale per la liquidazione al 27 set 2017

    LRESSP

    Dichiarazione di solvibilità

    4 pagineLIQ01

    Soddisfazione dell'onere 11 in pieno

    1 pagineMR04

    Dichiarazione di conformità presentata il 15 ago 2017 senza aggiornamenti

    3 pagineCS01

    Notifica di R-Isc Investigation & Surveillance Company (Holdings) Limited come persona con controllo significativo il 06 apr 2016

    2 paginePSC02

    Dichiarazione di conformità presentata il 29 giu 2017 senza aggiornamenti

    3 pagineCS01

    Bilancio per una piccola impresa redatto al 31 mar 2016

    7 pagineAA

    Esercizio contabile in corso abbreviato dal 31 mar 2017 al 31 dic 2016

    1 pagineAA01

    Indirizzo della sede legale modificato da 2nd Floor Landmark House Station Road Cheadle Hulme Cheshire SK8 7BS a Liberty House Greenham Business Park Greenham Thatcham RG19 6HW in data 16 ago 2016

    1 pagineAD01

    Nomina di Mr Stephen Cook come amministratore in data 03 ago 2016

    2 pagineAP01

    Bilancio annuale redatto al 29 giu 2016 con elenco completo degli azionisti

    6 pagineAR01
    Deposizioni associate
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    capital22 lug 2016

    Stato del capitale al 22 lug 2016

    • Capitale: GBP 100
    SH01

    Cessazione della carica di Grainne Greer come segretario in data 31 mag 2016

    2 pagineTM02

    Bilancio per una piccola impresa redatto al 31 mar 2015

    7 pagineAA

    Bilancio annuale redatto al 29 giu 2015 con elenco completo degli azionisti

    3 pagineAR01
    Deposizioni associate
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    capital15 lug 2015

    Stato del capitale al 15 lug 2015

    • Capitale: GBP 100
    SH01

    Bilancio per una piccola impresa redatto al 31 mar 2014

    7 pagineAA

    Bilancio annuale redatto al 29 giu 2014 con elenco completo degli azionisti

    3 pagineAR01
    Deposizioni associate
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    capital15 lug 2014

    Stato del capitale al 15 lug 2014

    • Capitale: GBP 100
    SH01

    Bilancio per una piccola impresa redatto al 31 mar 2013

    7 pagineAA

    Bilancio annuale redatto al 29 giu 2013 con elenco completo degli azionisti

    3 pagineAR01
    Deposizioni associate
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    capital11 lug 2013

    Stato del capitale a seguito di un'emissione di azioni al 11 lug 2013

    SH01

    Bilancio per una piccola impresa redatto al 31 mar 2012

    7 pagineAA

    Chi sono gli amministratori di R-ISC INVESTIGATION & SURVEILLANCE COMPANY LIMITED?

    Amministratori
    NomeNominato ilDimissioni ilRuoloIndirizzoIdentificazione della societàPaese di residenzaNazionalitàData di nascitaProfessioneNumero
    COOK, Stephen
    29 Wellington Street
    LS1 4DL Leeds
    Central Square 5th Floor
    Amministratore
    29 Wellington Street
    LS1 4DL Leeds
    Central Square 5th Floor
    EnglandBritish212303580001
    GREER, Samuel James
    Station Road
    Cheadle Hulme
    SK8 7BS Cheadle
    Landmark House
    Cheshire
    United Kingdom
    Amministratore
    Station Road
    Cheadle Hulme
    SK8 7BS Cheadle
    Landmark House
    Cheshire
    United Kingdom
    United KingdomBritish112097440001
    CAVENDER, Clifford John
    3 Harvey Road
    GU1 3SG Guildford
    Surrey
    Segretario
    3 Harvey Road
    GU1 3SG Guildford
    Surrey
    British11522710002
    GREER, Grainne
    Floor Landmark House Station Road
    SK8 7BS Cheadle Hulme
    2nd
    Cheshire
    England
    Segretario
    Floor Landmark House Station Road
    SK8 7BS Cheadle Hulme
    2nd
    Cheshire
    England
    British129167590001
    GRINDROD, Nicola Jane
    Wood End House Station Road
    SK9 4HF Styal
    Cheshire
    Segretario
    Wood End House Station Road
    SK9 4HF Styal
    Cheshire
    British42992180001
    HAYES, Christine
    60 Claughton Street
    WA10 1SN St Helens
    Merseyside
    Segretario
    60 Claughton Street
    WA10 1SN St Helens
    Merseyside
    British24758880001
    OSBORNE, Philip Thomas
    1715 Bella Vista
    PO BOX 1764
    FOREIGN Belize City
    Belize
    Segretario
    1715 Bella Vista
    PO BOX 1764
    FOREIGN Belize City
    Belize
    British76955710002
    PENNINGTON, David Ian
    Ferndene Applelands Close
    Boundstone
    GU10 4TL Farnham
    Surrey
    Segretario
    Ferndene Applelands Close
    Boundstone
    GU10 4TL Farnham
    Surrey
    British38346120001
    PENNINGTON, David Ian
    Ferndene Applelands Close
    Boundstone
    GU10 4TL Farnham
    Surrey
    Segretario
    Ferndene Applelands Close
    Boundstone
    GU10 4TL Farnham
    Surrey
    British38346120001
    PIMM, John James
    13 North Park Road
    Bramhall
    SK7 3JR Stockport
    Cheshire
    Segretario
    13 North Park Road
    Bramhall
    SK7 3JR Stockport
    Cheshire
    British39920220001
    ROBINSON, Ian George
    74 Brookmans Avenue
    Brookmans Park
    AL9 7QQ Hatfield
    Hertfordshire
    Segretario
    74 Brookmans Avenue
    Brookmans Park
    AL9 7QQ Hatfield
    Hertfordshire
    British57975730001
    SMYTHE, William
    2 Pendlebury Road
    Gatley
    SK8 4BH Cheadle
    Cheshire
    Segretario
    2 Pendlebury Road
    Gatley
    SK8 4BH Cheadle
    Cheshire
    British24540970001
    BRADFORD, Richard James
    Holcombe House
    Olney Road
    MK46 5BX Emberton
    Buckinghamshire
    Bucks
    Amministratore
    Holcombe House
    Olney Road
    MK46 5BX Emberton
    Buckinghamshire
    Bucks
    United KingdomBritish72452740004
    CAVENDER, Clifford John
    3 Harvey Road
    GU1 3SG Guildford
    Surrey
    Amministratore
    3 Harvey Road
    GU1 3SG Guildford
    Surrey
    EnglandBritish11522710002
    COATES, Jeremy William
    62 The Grove
    MK40 3JN Bedford
    Bedfordshire
    Amministratore
    62 The Grove
    MK40 3JN Bedford
    Bedfordshire
    EnglandBritish58806030001
    COLEMAN, Paul James
    Broadlands
    Churchill Drive Knotty Green
    HP9 2TJ Beaconsfield
    Buckinghamshire
    Amministratore
    Broadlands
    Churchill Drive Knotty Green
    HP9 2TJ Beaconsfield
    Buckinghamshire
    British13535920002
    DULIEU, Kenneth Paul
    5 Gledhow Wood
    KT20 6JQ Kingswood
    Surrey
    Amministratore
    5 Gledhow Wood
    KT20 6JQ Kingswood
    Surrey
    British114322880001
    FOX, Peter John
    41 Whistlers Avenue
    SW11 3TS London
    Amministratore
    41 Whistlers Avenue
    SW11 3TS London
    British68548490001
    HAMILTON OF EPSOM, Archibald Gavin, Lord
    14 Tufton Court
    Tufton Street Tufton
    SW1P 3QH London
    Amministratore
    14 Tufton Court
    Tufton Street Tufton
    SW1P 3QH London
    EnglandBritish112172480001
    HARVEY, Charles Peter
    Greensleeves Back Lane
    Wickham Bishops
    CM8 3LU Witham
    Essex
    Amministratore
    Greensleeves Back Lane
    Wickham Bishops
    CM8 3LU Witham
    Essex
    British39114360002
    HAYES, Christine
    60 Claughton Street
    WA10 1SN St Helens
    Merseyside
    Amministratore
    60 Claughton Street
    WA10 1SN St Helens
    Merseyside
    British24758880001
    HAYES, Stephen Paul
    Hagg Farm Shrigley Road South
    Pott Shrigley
    SK12 1TF Poynton
    Cheshire
    Amministratore
    Hagg Farm Shrigley Road South
    Pott Shrigley
    SK12 1TF Poynton
    Cheshire
    United KingdomBritish83224840001
    JONES, Stephen
    59 Granton Avenue
    RM14 2RT Upminster
    Essex
    Amministratore
    59 Granton Avenue
    RM14 2RT Upminster
    Essex
    EnglandBritish52323340002
    LOMAS, John Sidney
    34 Ack Lane West
    Bramhall
    SK8 7EL Stockport
    Cheshire
    Amministratore
    34 Ack Lane West
    Bramhall
    SK8 7EL Stockport
    Cheshire
    United KingdomBritish114065400001
    PENNINGTON, David Ian
    Ferndene Applelands Close
    Boundstone
    GU10 4TL Farnham
    Surrey
    Amministratore
    Ferndene Applelands Close
    Boundstone
    GU10 4TL Farnham
    Surrey
    EnglandBritish38346120001
    ROBINSON, Ian George
    74 Brookmans Avenue
    Brookmans Park
    AL9 7QQ Hatfield
    Hertfordshire
    Amministratore
    74 Brookmans Avenue
    Brookmans Park
    AL9 7QQ Hatfield
    Hertfordshire
    EnglandBritish57975730001
    SMYTHE, William
    2 Pendlebury Road
    Gatley
    SK8 4BH Cheadle
    Cheshire
    Amministratore
    2 Pendlebury Road
    Gatley
    SK8 4BH Cheadle
    Cheshire
    British24540970001
    SOUTHTOWN LIMITED
    Craigmuir Chambers
    PO BOX 71
    Roadtown
    Tortola
    Br Virgin Islands
    Amministratore
    Craigmuir Chambers
    PO BOX 71
    Roadtown
    Tortola
    Br Virgin Islands
    70598540001

    Chi sono le persone con controllo significativo di R-ISC INVESTIGATION & SURVEILLANCE COMPANY LIMITED?

    Persone con controllo significativo
    NomeNotificato ilIndirizzoCessato
    R-Isc Investigation & Surveillance Company (Holdings) Limited
    Greenham Business Park
    Greenham
    RG19 6HW Thatcham
    Liberty House
    United Kingdom
    06 apr 2016
    Greenham Business Park
    Greenham
    RG19 6HW Thatcham
    Liberty House
    United Kingdom
    No
    Forma giuridicaPrivate Limited Company
    Paese di registrazioneEngland
    Autorità legaleCompanies Act 2006
    Luogo di registrazioneCompanies House England
    Numero di registrazione06079303
    Natura del controllo
    • La persona possiede, direttamente o indirettamente, più del 75% delle azioni della società.
    • La persona detiene, direttamente o indirettamente, più del 75% dei diritti di voto nella società.

    R-ISC INVESTIGATION & SURVEILLANCE COMPANY LIMITED ha ipoteche?

    Ipoteche
    ClassificazioneDateStatoDettagli
    Debenture
    Creato il 23 feb 2007
    Consegnato il 16 mar 2007
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Persone aventi diritto
    • Barclays Bank PLC
    Transazioni
    • 16 mar 2007Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 18 set 2017Soddisfazione di un'ipoteca (MR04)
    Deed of floating charge between the chargors (as defined) and the bank of nova scotia as agent and security trustee (the security trustee) for the secured parties (as defined), tracedance limited and capital group limited as security trustee for the secured parties
    Creato il 30 mar 2000
    Consegnato il 13 apr 2000
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All liabilities due or to become due from the chargors to the security trustee under or in respect of the credit agreement, guarantees and all other loan documents to which they are a party and all liabilities of each chargor under the deed
    Brevi particolari
    By way of floating charge all undertaking and all assets rights income and goodwill of the company both present and future.
    Persone aventi diritto
    • The Bank of Nova Scotia
    Transazioni
    • 13 apr 2000Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 01 apr 2006Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Debenture
    Creato il 05 ago 1999
    Consegnato il 18 ago 1999
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Persone aventi diritto
    • Barclays Bank PLC
    Transazioni
    • 18 ago 1999Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 03 mag 2000Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Debenture deed
    Creato il 19 nov 1997
    Consegnato il 03 dic 1997
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Persone aventi diritto
    • Lloyds Bank PLC
    Transazioni
    • 03 dic 1997Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 03 mag 2000Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Debenture
    Creato il 23 set 1994
    Consegnato il 04 ott 1994
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Persone aventi diritto
    • Ucb Invoice Discounting Limited
    Transazioni
    • 04 ott 1994Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 16 set 1997Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Legal charge
    Creato il 12 lug 1994
    Consegnato il 16 lug 1994
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Willow bank house,old road,handforth t/n CH227130 together with all unfixed plant and machinery and other chattels and equipment now or in the future in or about the property and includes any part or parts thereof.
    Persone aventi diritto
    • The Co-Operative Bank PLC
    Transazioni
    • 16 lug 1994Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 11 gen 2000Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Legal charge
    Creato il 18 apr 1994
    Consegnato il 21 apr 1994
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Property k/a 4 pendlebury road, gatley, stockport. Floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment.
    Persone aventi diritto
    • The Co-Operative Bank PLC
    Transazioni
    • 21 apr 1994Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 16 set 1997Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Mortgage debenture
    Creato il 30 mar 1994
    Consegnato il 02 apr 1994
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    (Including trade fixtures). Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Persone aventi diritto
    • The Co-Operative Bank PLC
    Transazioni
    • 02 apr 1994Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 09 set 1997Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Legal charge
    Creato il 24 set 1993
    Consegnato il 25 set 1993
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    F/H property k/a 4 pendlebury road, gatley, stockport. Fixed charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment.
    Persone aventi diritto
    • The Royal Bank of Scotland PLC
    Transazioni
    • 25 set 1993Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 20 ott 1995Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Legal charge
    Creato il 25 ago 1993
    Consegnato il 15 set 1993
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    L/H land and buildings k/a 2 pendlebury road, gatley, stockport, greater manchester. Fixed charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment.
    Persone aventi diritto
    • The Royal Bank of Scotland PLC
    Transazioni
    • 15 set 1993Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 20 ott 1995Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Debenture
    Creato il 03 lug 1987
    Consegnato il 08 lug 1987
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Persone aventi diritto
    • The Royal Bank of Scotland PLC
    Transazioni
    • 08 lug 1987Registrazione di un'ipoteca
    • 20 ott 1995Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)

    R-ISC INVESTIGATION & SURVEILLANCE COMPANY LIMITED ha procedimenti di insolvenza?

    Numero di praticaDateTipoProfessionistiAltro
    1
    DataTipo
    27 set 2017Inizio della liquidazione
    15 gen 2020Data di scioglimento
    Liquidazione volontaria dei soci
    NomeRuoloIndirizzoNominato ilCessato il
    Keith Allan Marshall
    Central Square 5th Floor 29 Wellington Street
    LS1 4DL Leeds
    West Yorkshire
    Praticante
    Central Square 5th Floor 29 Wellington Street
    LS1 4DL Leeds
    West Yorkshire
    Gareth Harris
    Central Square 5th Floor 29 Wellington Street
    LS1 4DL Leeds
    West Yorkshire
    Praticante
    Central Square 5th Floor 29 Wellington Street
    LS1 4DL Leeds
    West Yorkshire

    Fonte dati

    • Companies House del Regno Unito
      Il registro ufficiale delle imprese nel Regno Unito, che fornisce l'accesso pubblico alle informazioni sulle imprese, come nomi, indirizzi, amministratori e depositi finanziari.
    • Licenza: CC0