RESOLV COMPUTERS LIMITED

RESOLV COMPUTERS LIMITED

  • Panoramica
  • Riepilogo
  • Scopo
  • Indirizzo
  • Bilanci
  • Bilancio annuale
  • Deposizioni
  • Amministratori
  • Ipoteche
  • Fonte dati
  • Panoramica

    Nome della societàRESOLV COMPUTERS LIMITED
    Stato della societàSciolta
    Forma giuridicaSocietà a responsabilità limitata
    Numero di società 01831276
    GiurisdizioneInghilterra/Galles
    Data di costituzione
    Data di cessazione

    Qual è lo scopo di RESOLV COMPUTERS LIMITED?

    • Altre attività di servizi nel campo delle tecnologie dell'informazione (62090) / Informazione e comunicazione

    Dove si trova RESOLV COMPUTERS LIMITED?

    Indirizzo della sede legale
    4 Penta Court
    Station Road
    WD6 1SL Borehamwood
    Hertfordshire
    Indirizzo della sede legale non recapitabileNo

    Quali sono gli ultimi bilanci di RESOLV COMPUTERS LIMITED?

    Ultimi bilanci
    Ultimi bilanci redatti al28 feb 2014

    Qual è lo stato dell'ultimo bilancio annuale per RESOLV COMPUTERS LIMITED?

    Bilancio annuale
    Ultimo bilancio annuale

    Quali sono le ultime deposizioni per RESOLV COMPUTERS LIMITED?

    Deposizioni
    DataDescrizioneDocumentoTipo

    Gazzetta Ufficiale finale sciolta per scioglimento volontario

    1 pagineGAZ2(A)

    Prima Gazzetta Ufficiale per lo scioglimento volontario

    1 pagineGAZ1(A)

    Richiesta di cancellazione della società dal registro

    3 pagineDS01

    legacy

    1 pagineSH20

    Stato del capitale al 09 ott 2015

    • Capitale: GBP 1
    4 pagineSH19

    legacy

    1 pagineCAP-SS

    Risoluzioni

    Resolutions
    2 pagineRESOLUTIONS
    Risoluzioni
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    capital

    Risoluzione di riduzione del capitale sociale emesso

    RES06

    Soddisfazione dell'onere 7 in pieno

    4 pagineMR04

    Cessazione della carica di John Michael Wolfenden come amministratore in data 16 apr 2015

    1 pagineTM01

    Cessazione della carica di John Michael Wolfenden come amministratore in data 16 apr 2015

    1 pagineTM01

    Secondo deposito di TM01 precedentemente inviato alla Camera di Commercio

    4 pagineRP04

    Secondo deposito di TM01 precedentemente inviato alla Camera di Commercio

    4 pagineRP04
    Note
    DataNota
    24 mar 2015Clarification SECOND FILED TM01 FOR PAUL MOSER

    Bilancio annuale redatto al 31 dic 2014 con elenco completo degli azionisti

    5 pagineAR01
    Deposizioni associate
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    capital12 gen 2015

    Stato del capitale al 12 gen 2015

    • Capitale: GBP 1,000
    SH01

    Bilancio redatto al 28 feb 2014

    11 pagineAA

    Bilancio annuale redatto al 31 dic 2013 con elenco completo degli azionisti

    5 pagineAR01
    Deposizioni associate
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    capital10 gen 2014

    Stato del capitale al 10 gen 2014

    • Capitale: GBP 1,000
    SH01

    Bilancio redatto al 28 feb 2013

    12 pagineAA

    Cessazione della carica di Paul Moser come amministratore in data 23 mag 2012

    2 pagineTM01
    Note
    DataNota
    24 mar 2015Clarification A SECOND FILED TM01 WAS REGISTERED ON 24/03/2015

    Cessazione della carica di Susan Moser come amministratore in data 20 mar 2012

    2 pagineTM01
    Note
    DataNota
    24 mar 2015Clarification A SECOND FILED TM01 WAS REGISTERED ON 24/03/2015

    Nomina di Mr John Michael Wolfenden come amministratore

    2 pagineAP01

    Nomina di Mr William Odhiambo Oduol come amministratore

    2 pagineAP01

    Bilancio annuale redatto al 31 dic 2012 con elenco completo degli azionisti

    5 pagineAR01

    Bilancio redatto al 29 feb 2012

    12 pagineAA

    Bilancio annuale redatto al 31 dic 2011 con elenco completo degli azionisti

    5 pagineAR01

    Bilancio redatto al 28 feb 2011

    12 pagineAA

    Bilancio annuale redatto al 31 dic 2010 con elenco completo degli azionisti

    6 pagineAR01

    Chi sono gli amministratori di RESOLV COMPUTERS LIMITED?

    Amministratori
    NomeNominato ilDimissioni ilRuoloIndirizzoIdentificazione della societàPaese di residenzaNazionalitàData di nascitaProfessioneNumero
    RAMOUTAR, Subhash
    Long Elmes
    HA3 5LB Harrow
    123
    Middx
    Segretario
    Long Elmes
    HA3 5LB Harrow
    123
    Middx
    BritishAccountant128712400001
    ODUOL, William Odhiambo
    Penta Court
    Station Road
    WD6 1SL Borehamwood
    4
    Hertfordshire
    England
    Amministratore
    Penta Court
    Station Road
    WD6 1SL Borehamwood
    4
    Hertfordshire
    England
    KenyaKenyanManaging Director154933810001
    ALGRA, Martin Victor
    11 Stonegate
    Copped Hall Estate
    GU15 1PD Camberley
    Surrey
    Segretario
    11 Stonegate
    Copped Hall Estate
    GU15 1PD Camberley
    Surrey
    British9322120001
    COWEN, Peter Alan
    3 George Street
    Bryanston
    FOREIGN Johannesburg
    Gauteng Province 2191
    South Africa
    Segretario
    3 George Street
    Bryanston
    FOREIGN Johannesburg
    Gauteng Province 2191
    South Africa
    South AfricanDirector121935970001
    PSARIAS, John
    2 Ardoch Road
    SE6 1SJ London
    Segretario
    2 Ardoch Road
    SE6 1SJ London
    British6153540001
    J P SECRETARIAL SERVICES LTD
    East House
    109 South Worple Way
    SW14 8TN London
    Segretario
    East House
    109 South Worple Way
    SW14 8TN London
    101162510001
    ALGRA, Martin Victor
    11 Stonegate
    Copped Hall Estate
    GU15 1PD Camberley
    Surrey
    Amministratore
    11 Stonegate
    Copped Hall Estate
    GU15 1PD Camberley
    Surrey
    BritishFinancial Advisor9322120001
    MALHERBE, Jacques Francois
    13 Wesley Road
    Lonehill
    FOREIGN Johannesburg
    Gauteng Province 2062
    South Africa
    Amministratore
    13 Wesley Road
    Lonehill
    FOREIGN Johannesburg
    Gauteng Province 2062
    South Africa
    South AfricanDirector121936010001
    MOSER, Paul Raymond
    27 Hartfield Avenue
    Elstree
    WD6 3JB Borehamwood
    Hertfordshire
    Amministratore
    27 Hartfield Avenue
    Elstree
    WD6 3JB Borehamwood
    Hertfordshire
    EnglandBritishCompany Director11338700001
    MOSER, Susan Wendy
    27 Hartfield Avenue
    Elstree
    WD6 3JB Borehamwood
    Hertfordshire
    Amministratore
    27 Hartfield Avenue
    Elstree
    WD6 3JB Borehamwood
    Hertfordshire
    EnglandBritishNone11338690001
    TIERNEY, John Edmund
    Conway House The Fairway
    Worplesdon
    GU3 3QE Guildford
    Surrey
    Amministratore
    Conway House The Fairway
    Worplesdon
    GU3 3QE Guildford
    Surrey
    United KingdomBritishDirector168816310001
    TIERNEY, Susan Carol
    Conway House The Fairway
    Worplesdon
    GU3 3QE Guildford
    Surrey
    Amministratore
    Conway House The Fairway
    Worplesdon
    GU3 3QE Guildford
    Surrey
    BritishDirector21740390001
    WOLFENDEN, John Michael
    Penta Court
    Station Road
    WD6 1SL Borehamwood
    4
    Hertfordshire
    England
    Amministratore
    Penta Court
    Station Road
    WD6 1SL Borehamwood
    4
    Hertfordshire
    England
    EnglandBritishCompany Director91482950001

    RESOLV COMPUTERS LIMITED ha ipoteche?

    Ipoteche
    ClassificazioneDateStatoDettagli
    Debenture
    Creato il 03 ago 2006
    Consegnato il 08 ago 2006
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Svenska Handelsbanken Ab(Publ)
    Transazioni
    • 08 ago 2006Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 06 ott 2015Soddisfazione di un'ipoteca (MR04)
    Rent deposit deed
    Creato il 08 mag 2006
    Consegnato il 10 mag 2006
    In corso
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    £4,758.00 and all monies from time to time standing to the credit of the designated deposit account. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • St Modwen Ventures Limited
    Transazioni
    • 10 mag 2006Registrazione di un'ipoteca (395)
    Legal charge
    Creato il 01 apr 2003
    Consegnato il 04 apr 2003
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Unit 4, fleet business park sandy lane fleet and parking spaces hart hampshire t/n HP545675. By way of fixed charge the benefit of all covenants and rights concerning the property and plant machinery fixtures fittings furniture equipment implements and utensils the goodwill of any business carried on at the property and the proceeds of any insurance affecting the property or assets.
    Persone aventi diritto
    • National Westminster Bank PLC
    Transazioni
    • 04 apr 2003Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 31 gen 2007Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Debenture
    Creato il 01 apr 2003
    Consegnato il 03 apr 2003
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Persone aventi diritto
    • National Westminster Bank PLC
    Transazioni
    • 03 apr 2003Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 31 gen 2007Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Mortgage
    Creato il 09 mag 2000
    Consegnato il 10 mag 2000
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    The f/h property k/a 4 fleet business park sandy lane church crookham fleet hamphshire t/n HP545675. Together with all buildings and fixtures (including trade fixtures) fixed plant and machinery by way of fixed charge all present and future book and other debts floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment by way of assignment the goodwill of the business (if any) the full benefit of all licences and all guarantees.
    Persone aventi diritto
    • Lloyds Tsb Bank PLC
    Transazioni
    • 10 mag 2000Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 04 ott 2005Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Mortgage
    Creato il 11 lug 1989
    Consegnato il 25 lug 1989
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    37 crosby hill drive conberley surrey & all buildings & fixtures assigns goodwill (if any). Floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment.
    Persone aventi diritto
    • Lloyds Bank PLC
    Transazioni
    • 25 lug 1989Registrazione di un'ipoteca
    • 04 ott 2005Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Single debenture
    Creato il 02 feb 1987
    Consegnato il 09 feb 1987
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Persone aventi diritto
    • Lloyds Bank PLC
    Transazioni
    • 09 feb 1987Registrazione di un'ipoteca
    • 04 ott 2005Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)

    Fonte dati

    • Companies House del Regno Unito
      Il registro ufficiale delle imprese nel Regno Unito, che fornisce l'accesso pubblico alle informazioni sulle imprese, come nomi, indirizzi, amministratori e depositi finanziari.
    • Licenza: CC0