EDMOND DE ROTHSCHILD SECURITIES (UK) LIMITED

EDMOND DE ROTHSCHILD SECURITIES (UK) LIMITED

  • Panoramica
  • Riepilogo
  • Scopo
  • Indirizzo
  • Denominazioni precedenti
  • Bilanci
  • Deposizioni
  • Amministratori
  • Persone con controllo significativo
  • Ipoteche
  • Insolvenza
  • Fonte dati
  • Panoramica

    Nome della societàEDMOND DE ROTHSCHILD SECURITIES (UK) LIMITED
    Stato della societàSciolta
    Forma giuridicaSocietà a responsabilità limitata
    Numero di società 01831705
    GiurisdizioneInghilterra/Galles
    Data di costituzione
    Data di cessazione

    Qual è lo scopo di EDMOND DE ROTHSCHILD SECURITIES (UK) LIMITED?

    • Negoziazione per conto proprio di valori mobiliari (64991) / Attività finanziarie e assicurative

    Dove si trova EDMOND DE ROTHSCHILD SECURITIES (UK) LIMITED?

    Indirizzo della sede legale
    C/O Mazars Llp Tower Bridge House
    St Katharines Way
    E1W 1DD London
    Indirizzo della sede legale non recapitabileNo

    Quali erano i nomi precedenti di EDMOND DE ROTHSCHILD SECURITIES (UK) LIMITED?

    Denominazioni sociali precedenti
    Nome della societàDaA
    LCF EDMOND DE ROTHSCHILD SECURITIES LIMITED31 mar 200431 mar 2004
    LCF ROTHSCHILD SECURITIES LIMITED19 lug 200019 lug 2000
    L.C.F. EDMOND DE ROTHSCHILD SECURITIES LIMITED10 set 198410 set 1984
    PATHALTON LIMITED11 lug 198411 lug 1984

    Quali sono gli ultimi bilanci di EDMOND DE ROTHSCHILD SECURITIES (UK) LIMITED?

    Ultimi bilanci
    Ultimi bilanci redatti al31 dic 2016

    Quali sono le ultime deposizioni per EDMOND DE ROTHSCHILD SECURITIES (UK) LIMITED?

    Deposizioni
    DataDescrizioneDocumentoTipo

    Gazzetta ufficiale finale sciolta a seguito di liquidazione

    1 pagineGAZ2

    Ritorno della riunione finale in una liquidazione volontaria dei membri

    15 pagineLIQ13

    Indirizzo della sede legale modificato da 4 Carlton Gardens London SW1Y 5AA a C/O Mazars Llp Tower Bridge House St Katharines Way London E1W 1DD in data 24 set 2018

    2 pagineAD01

    L'indirizzo di ispezione del registro è stato modificato a 4 Carlton Gardens London SW1Y 5AA

    2 pagineAD02

    Dichiarazione di solvibilità

    5 pagineLIQ01

    Nomina di un liquidatore volontario

    3 pagine600

    Risoluzioni

    Resolutions
    1 pagineRESOLUTIONS
    Risoluzioni
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    liquidation

    Risoluzione speciale per la liquidazione al 06 set 2018

    LRESSP

    Soddisfazione dell'onere 4 in pieno

    2 pagineMR04

    Soddisfazione dell'onere 1 in pieno

    2 pagineMR04

    Soddisfazione dell'onere 5 in pieno

    1 pagineMR04

    Soddisfazione dell'onere 8 in pieno

    1 pagineMR04

    Dichiarazione di conformità presentata il 06 lug 2018 senza aggiornamenti

    3 pagineCS01

    Cessazione della carica di Sabine Rabald come amministratore in data 31 gen 2018

    1 pagineTM01

    Bilancio redatto al 31 dic 2016

    25 pagineAA

    Dichiarazione di conformità presentata il 06 lug 2017 con aggiornamenti

    4 pagineCS01

    Cessazione della carica di Gareth Austin Rippon Long come amministratore in data 30 giu 2017

    1 pagineTM01

    Cessazione della carica di Andrew Nicholas John Hay come amministratore in data 31 mar 2017

    1 pagineTM01

    Stato del capitale a seguito di un'emissione di azioni al 31 dic 2016

    • Capitale: GBP 2,000,000
    3 pagineSH01

    Risoluzioni

    Resolutions
    22 pagineRESOLUTIONS
    Risoluzioni
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    incorporation

    Risoluzione di adozione degli Articoli di Associazione

    RES01

    Dichiarazione di conformità presentata il 06 lug 2016 con aggiornamenti

    5 pagineCS01

    Cessazione della carica di Denis Joseph Claude Gilles De Montigny come amministratore in data 30 giu 2016

    1 pagineTM01

    Bilancio redatto al 31 dic 2015

    24 pagineAA

    Cessazione della carica di John William Hewitson come amministratore in data 31 mar 2016

    1 pagineTM01

    Nomina di Mr Denis Joseph Claude Gilles De Montigny come amministratore in data 07 ott 2015

    2 pagineAP01

    Bilancio annuale redatto al 12 set 2015 con elenco completo degli azionisti

    6 pagineAR01
    Deposizioni associate
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    capital14 set 2015

    Stato del capitale al 14 set 2015

    • Capitale: GBP 1,000,000
    SH01

    Chi sono gli amministratori di EDMOND DE ROTHSCHILD SECURITIES (UK) LIMITED?

    Amministratori
    NomeNominato ilDimissioni ilRuoloIndirizzoIdentificazione della societàPaese di residenzaNazionalitàData di nascitaProfessioneNumero
    COUTTS, Eric Joseph
    Tower Bridge House
    St Katharines Way
    E1W 1DD London
    C/O Mazars Llp
    Amministratore
    Tower Bridge House
    St Katharines Way
    E1W 1DD London
    C/O Mazars Llp
    FranceEnglish195873440001
    HORNER, Elizabeth Anne
    Tower Bridge House
    St Katharines Way
    E1W 1DD London
    C/O Mazars Llp
    Amministratore
    Tower Bridge House
    St Katharines Way
    E1W 1DD London
    C/O Mazars Llp
    EnglandBritish147119570001
    COOPER, Anne Sieona Petie
    Greygates
    Warren Road
    TN6 1QN Crowborough
    East Sussex
    Segretario
    Greygates
    Warren Road
    TN6 1QN Crowborough
    East Sussex
    British52030630001
    MADDISON, Patrick James Robson
    Oak Tree Cottage Maddox Lane
    Little Bookham
    KT23 3BT Leatherhead
    Surrey
    Segretario
    Oak Tree Cottage Maddox Lane
    Little Bookham
    KT23 3BT Leatherhead
    Surrey
    British16217330001
    MADDISON, Patrick James Robson
    Oak Tree Cottage Maddox Lane
    Little Bookham
    KT23 3BT Leatherhead
    Surrey
    Segretario
    Oak Tree Cottage Maddox Lane
    Little Bookham
    KT23 3BT Leatherhead
    Surrey
    British16217330001
    ALEXANDER, John Bernard
    Old Rectory
    OX44 7JG Great Haseley
    Oxfordshire
    Amministratore
    Old Rectory
    OX44 7JG Great Haseley
    Oxfordshire
    EnglandUnited Kingdom23013570001
    ALTMANN, David Peter
    Priory Cottage South Mill Street
    Steventon
    OX13 6SP Abingdon
    Oxfordshire
    Amministratore
    Priory Cottage South Mill Street
    Steventon
    OX13 6SP Abingdon
    Oxfordshire
    British30828020003
    BONFIELD, John Anthony
    30 Burghley Road
    SW19 5HN London
    Amministratore
    30 Burghley Road
    SW19 5HN London
    British56236200001
    BRIANCE, Richard Henry
    13 Holland Street
    W8 4NA London
    The Old House
    England
    Amministratore
    13 Holland Street
    W8 4NA London
    The Old House
    England
    EnglandBritish16636440001
    DE MONTIGNY, Denis Joseph Claude Gilles
    Carlton Gardens
    SW1Y 5AA London
    4
    Amministratore
    Carlton Gardens
    SW1Y 5AA London
    4
    LuxembourgLuxembourger200877180001
    DRUMMOND, John Leitch
    Latimers
    Wendens Ambo
    CB11 4LQ Saffron Walden
    Essex
    Amministratore
    Latimers
    Wendens Ambo
    CB11 4LQ Saffron Walden
    Essex
    British30828010001
    ELMAN, Andrew Mark
    Carlton Gardens
    SW1Y 5AA London
    4
    England
    Amministratore
    Carlton Gardens
    SW1Y 5AA London
    4
    England
    United KingdomBritish59954220004
    FORDHAM, Kevin Lindsay
    159 Forest Road
    TN2 5JP Tunbridge Wells
    Kent
    Amministratore
    159 Forest Road
    TN2 5JP Tunbridge Wells
    Kent
    United KingdomBritish29835100001
    FUNAKI, Hiroshi
    Orion House
    5 Upper St Martins Lane
    WC2H 9EA London
    Amministratore
    Orion House
    5 Upper St Martins Lane
    WC2H 9EA London
    EnglandBritish156927690001
    HAY, Andrew Nicholas John
    10 Favart Road
    SW6 4AZ London
    Amministratore
    10 Favart Road
    SW6 4AZ London
    United KingdomBritish64172700001
    HEATHFIELD, Claire Louise
    53 Warwick Gardens
    W14 8PL London
    Amministratore
    53 Warwick Gardens
    W14 8PL London
    EnglandBritish75061300002
    HEWITSON, John William
    Carlton Gardens
    SW1Y 5AA London
    4
    England
    Amministratore
    Carlton Gardens
    SW1Y 5AA London
    4
    England
    EnglandEnglish170530830001
    JONES BATEMAN, Richard Stephen
    Bretton House
    Fosseway
    GL54 1JU Stow On The Wold
    Gloucestershire
    Amministratore
    Bretton House
    Fosseway
    GL54 1JU Stow On The Wold
    Gloucestershire
    British30828030002
    JOUINOT, Patrick-Joel
    6 Darlan Road
    SW6 5BT London
    Amministratore
    6 Darlan Road
    SW6 5BT London
    EnglandFrench104267410001
    LAMBOURNE, Douglas Ivan
    55 Waldemar Avenue
    W13 9PZ London
    Amministratore
    55 Waldemar Avenue
    W13 9PZ London
    British87042370001
    LONG, Gareth Austin Rippon
    Carlton Gardens
    SW1Y 5AA London
    4
    England
    Amministratore
    Carlton Gardens
    SW1Y 5AA London
    4
    England
    EnglandEnglish171854950001
    MADDISON, Patrick James Robson
    Oak Tree Cottage Maddox Lane
    Little Bookham
    KT23 3BT Leatherhead
    Surrey
    Amministratore
    Oak Tree Cottage Maddox Lane
    Little Bookham
    KT23 3BT Leatherhead
    Surrey
    EnglandBritish16217330001
    PRITCHARD, Huw Brentnall
    6 Davema Close
    BR7 5QZ Chislehurst
    Kent
    Amministratore
    6 Davema Close
    BR7 5QZ Chislehurst
    Kent
    Great BritainBritish53794300001
    RABALD, Sabine
    Carlton Gardens
    SW1Y 5AA London
    4
    Amministratore
    Carlton Gardens
    SW1Y 5AA London
    4
    FranceSwiss196552860001
    REGAN, Peter William
    3 Pimms Close Weylea Farm
    GU4 7YG Guildford
    Surrey
    Amministratore
    3 Pimms Close Weylea Farm
    GU4 7YG Guildford
    Surrey
    British53794420001
    SCHLIEMANN, Henrik Oliver
    Carlton Gardens
    SW1Y 5AA London
    4
    England
    Amministratore
    Carlton Gardens
    SW1Y 5AA London
    4
    England
    EnglandGerman68742850002
    SOPHER, Richard Moshe
    3 Upper Belgrave Street
    SW1X 8BD London
    Amministratore
    3 Upper Belgrave Street
    SW1X 8BD London
    United KingdomBritish35899030001
    STEER, Ian Peter
    Denstone Berry Lane
    WD3 5EY Chorley Wood
    Hertfordshire
    Amministratore
    Denstone Berry Lane
    WD3 5EY Chorley Wood
    Hertfordshire
    British37588490001
    THISTLETHWAYTE, Mark Edward
    Fairfield House
    East Street, Hambledon
    PO7 4RY Waterlooville
    Hampshire
    Amministratore
    Fairfield House
    East Street, Hambledon
    PO7 4RY Waterlooville
    Hampshire
    United KingdomBritish107579860001
    TUTT, Stephen Brian Reginald
    Carlton Gardens
    SW1Y 5AA London
    4
    England
    Amministratore
    Carlton Gardens
    SW1Y 5AA London
    4
    England
    EnglandBritish174717210001
    VELTMAN, Willem Laurens
    55b Harrington Gardens
    SW7 4JZ London
    Amministratore
    55b Harrington Gardens
    SW7 4JZ London
    Dutch62997050001

    Chi sono le persone con controllo significativo di EDMOND DE ROTHSCHILD SECURITIES (UK) LIMITED?

    Persone con controllo significativo
    NomeNotificato ilIndirizzoCessato
    Carlton Gardens
    SW1Y 5AA London
    4
    England
    06 apr 2016
    Carlton Gardens
    SW1Y 5AA London
    4
    England
    No
    Forma giuridicaPrivate Company Limited By Shares
    Paese di registrazioneEngland
    Autorità legaleCompanies Act 2006
    Luogo di registrazioneCompanies House
    Numero di registrazione01750485
    Natura del controllo
    • La persona possiede, direttamente o indirettamente, più del 75% delle azioni della società.
    • La persona detiene, direttamente o indirettamente, più del 75% dei diritti di voto nella società.
    • La persona ha il diritto, direttamente o indirettamente, di nominare o rimuovere la maggioranza del consiglio di amministrazione della società.

    EDMOND DE ROTHSCHILD SECURITIES (UK) LIMITED ha ipoteche?

    Ipoteche
    ClassificazioneDateStatoDettagli
    Crest security deed
    Creato il 22 giu 2010
    Consegnato il 08 lug 2010
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    All sums and payments receivable by or for the account of the company by reason or in respect of any transfer or debit of or any agreement to transfer or debit stock from any stock account see image for full details.
    Persone aventi diritto
    • Barclays Bank PLC
    Transazioni
    • 08 lug 2010Registrazione di un'ipoteca (MG01)
    • 03 set 2018Soddisfazione di un'ipoteca (MR04)
    Security deed
    Creato il 22 giu 2000
    Consegnato il 05 lug 2000
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All debts, obligations and liabilities whatsoever on the date of the security deed and from time to time thereafter (whether before or after the service of a default notice) due, owing or incurred by the company to the chargee (whether solely or jointly or jointly or severally with another or others and whether as principal or surely and whether actual or contingent present and future) including (whether before or after any judgement) all interest, costs and other charges whatsover and including without limitation, any such debts, obligations and liabilities which arise out of or in connection with the provision of crest settlement bank facilities (as defined in the security deed)
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges all sums and payments on the date of the security deed and from time to time thereafter receivable by or for the account of the company referable to the crest member in crest or any transfer by the company or the crest member of any of its right title or interest to and in stock represented by any credit balance on any such eligible account see ch microfiche for full details.
    Persone aventi diritto
    • Barclays Bank PLC
    Transazioni
    • 05 lug 2000Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 03 ago 2010Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (MG02)
    Supplemental security deed which is supplemental to a security deed dated 12TH july 1996
    Creato il 02 nov 1999
    Consegnato il 18 nov 1999
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All debts, obligations and liabilities due or to become due from the company to the chargee which arise out of or in connection with the facility agreement (as defined in the principal deed)
    Brevi particolari
    The principal deed was amended to include a first fixed charge on all sums and payanebts form time to time after the date of the supplemental security deed receivable by or for the account of the company by reason of or in respect of the closing out or liquidation of any unsettled contract relating to any stocks in crest.. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Barclays Bank PLC
    Transazioni
    • 18 nov 1999Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 03 ago 2010Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (MG02)
    Custody agreement
    Creato il 04 mag 1998
    Consegnato il 15 mag 1998
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee pursuant to the custody agreement
    Brevi particolari
    All cash and securities held in any account opened by the chargee in the name of the chargor pursuant to the custody agreement.
    Persone aventi diritto
    • Caroline Desbriere
    Transazioni
    • 15 mag 1998Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 03 set 2018Soddisfazione di un'ipoteca (MR04)
    Declaration of pledge of securities and claims
    Creato il 17 ott 1997
    Consegnato il 04 nov 1997
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All present and future obligations of the pledgor to the guarantor (a syndicate of banks whose lead bank is citibank N.A. and whose members as at the date of this certificate include banque bruxelles lambert S.A. banque generale du luxembourg S.A. banque internationale a luxembourg S.A. credit commercial de france kredietbank N.V. kredietbank S.A. luxemburgeoise union bank of switzerland and whose composition may periodically change) arising from its guarantee of the pledgor's borrowings of securities arranged under the cedel securities lending and borrowing rules and regulations of march 1997 as amended from time to time (the rules)
    Brevi particolari
    All present and future securities bonds notes certificates of deposit instruments or rights representing property rights or claims and the balance from time to time of the cash account(s) and all currencies of the pledgor with cedel bank.
    Persone aventi diritto
    • The Guarantor (See Form 395)
    Transazioni
    • 04 nov 1997Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 03 set 2018Soddisfazione di un'ipoteca (MR04)
    Security deed
    Creato il 12 lug 1996
    Consegnato il 24 lug 1996
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever including without limitation any such debts obligations and liabilities which arise out of or in connection with the provision of crest settlement bank facilities (as defined)
    Brevi particolari
    All sums and payments receivable by or for the account of the company by reason or in respect of any transfer or debit of or any agreement to transfer or debit stock from the eligible stock account. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Barclays Bank PLC
    Transazioni
    • 24 lug 1996Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 03 ago 2010Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (MG02)
    A charge in favour of the international stock exchange of the united kingdom and the republic of ireland limited
    Creato il 10 giu 1993
    Consegnato il 15 giu 1993
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    For securing all monies due or to become due under the terms of the charge
    Brevi particolari
    All shares,stock and other securities of any description which are for the time being designated by the stock exchange as talisman securities which are from time to time registered in the name of any stock exchange nominee company.. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • The International Stock Exchange of the United Kingdom and the Republic of Ireland Limited
    Transazioni
    • 15 giu 1993Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 03 mar 2010Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (MG02)
    Collateral agreement governing secured borrowings by participants in the euroclear system
    Creato il 27 dic 1991
    Consegnato il 06 gen 1992
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee relating to or resulting from the borrowers use of the euroclear system on any account whatsoever
    Brevi particolari
    All "collateral" (as defined on form 395) including in particular cash and securities clearance accounts opened in connection with the euroclear system by the brussels office of morgan guaranty on its books in the name of the company (see 395 for full details).
    Persone aventi diritto
    • Morgan Guaranty Trust Company of New York
    Transazioni
    • 06 gen 1992Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 03 set 2018Soddisfazione di un'ipoteca (MR04)

    EDMOND DE ROTHSCHILD SECURITIES (UK) LIMITED ha procedimenti di insolvenza?

    Numero di praticaDateTipoProfessionistiAltro
    1
    DataTipo
    06 set 2018Inizio della liquidazione
    26 dic 2019Data di scioglimento
    Liquidazione volontaria dei soci
    NomeRuoloIndirizzoNominato ilCessato il
    Guy Robert Thomas Hollander
    Tower Bridge House St Katharine S Way
    E1W 1DD London
    Praticante
    Tower Bridge House St Katharine S Way
    E1W 1DD London
    Simon David Chandler
    Tower Bridge House St Katharines Way
    E1W 1DD London
    Praticante
    Tower Bridge House St Katharines Way
    E1W 1DD London

    Fonte dati

    • Companies House del Regno Unito
      Il registro ufficiale delle imprese nel Regno Unito, che fornisce l'accesso pubblico alle informazioni sulle imprese, come nomi, indirizzi, amministratori e depositi finanziari.
    • Licenza: CC0