SHL TECHNOLOGY SOLUTIONS LIMITED

SHL TECHNOLOGY SOLUTIONS LIMITED

  • Panoramica
  • Riepilogo
  • Scopo
  • Indirizzo
  • Denominazioni precedenti
  • Bilanci
  • Bilancio annuale
  • Deposizioni
  • Amministratori
  • Ipoteche
  • Insolvenza
  • Fonte dati
  • Panoramica

    Nome della societàSHL TECHNOLOGY SOLUTIONS LIMITED
    Stato della societàSciolta
    Forma giuridicaSocietà a responsabilità limitata
    Numero di società 01832838
    GiurisdizioneInghilterra/Galles
    Data di costituzione
    Data di cessazione

    Qual è lo scopo di SHL TECHNOLOGY SOLUTIONS LIMITED?

    • Società non commerciali (74990) / Attività professionali, scientifiche e tecniche

    Dove si trova SHL TECHNOLOGY SOLUTIONS LIMITED?

    Indirizzo della sede legale
    Amen Corner
    Cain Road
    RG12 1HN Bracknell
    Berkshire
    Indirizzo della sede legale non recapitabileNo

    Quali erano i nomi precedenti di SHL TECHNOLOGY SOLUTIONS LIMITED?

    Denominazioni sociali precedenti
    Nome della societàDaA
    COMPUTERGROUP LIMITED17 ott 198417 ott 1984
    CABLEGRACE LIMITED16 lug 198416 lug 1984

    Quali sono gli ultimi bilanci di SHL TECHNOLOGY SOLUTIONS LIMITED?

    Ultimi bilanci
    Ultimi bilanci redatti al31 ott 2014

    Qual è lo stato dell'ultimo bilancio annuale per SHL TECHNOLOGY SOLUTIONS LIMITED?

    Bilancio annuale
    Ultimo bilancio annuale

    Quali sono le ultime deposizioni per SHL TECHNOLOGY SOLUTIONS LIMITED?

    Deposizioni
    DataDescrizioneDocumentoTipo

    Gazzetta ufficiale finale sciolta a seguito di liquidazione

    1 pagineGAZ2

    Ritorno della riunione finale in una liquidazione volontaria dei membri

    6 pagine4.71

    Dichiarazione di solvibilità

    3 pagine4.70

    Nomina di un liquidatore volontario

    2 pagine600

    Risoluzioni

    Resolutions
    1 pagineRESOLUTIONS
    Risoluzioni
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    liquidation

    Risoluzione speciale per la liquidazione al 14 lug 2015

    LRESSP

    Cessazione della carica di Steven David Burr come amministratore in data 30 giu 2015

    1 pagineTM01

    legacy

    4 pagineSH20

    Stato del capitale al 27 mag 2015

    • Capitale: GBP 1,000
    4 pagineSH19

    legacy

    1 pagineCAP-SS

    Risoluzioni

    Resolutions
    1 pagineRESOLUTIONS
    Risoluzioni
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    capital

    Risoluzione di riduzione del capitale sociale emesso

    RES06
    capital

    Risoluzioni

    Share premium account cancelled 20/05/2015
    RES13

    Bilancio redatto al 31 ott 2014

    12 pagineAA

    Bilancio annuale redatto al 06 lug 2014 con elenco completo degli azionisti

    4 pagineAR01
    Deposizioni associate
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    capital09 lug 2014

    Stato del capitale al 09 lug 2014

    • Capitale: GBP 84,620,041
    SH01

    Nomina di Ms Tara Dawn Trower come segretario

    2 pagineAP03

    Nomina di Ms Tara Dawn Trower come amministratore

    2 pagineAP01

    Cessazione della carica di Roberto Putland come amministratore

    1 pagineTM01

    Cessazione della carica di Roberto Putland come segretario

    1 pagineTM02

    Bilancio redatto al 31 ott 2013

    12 pagineAA

    Bilancio annuale redatto al 06 lug 2013 con elenco completo degli azionisti

    4 pagineAR01

    Stato del capitale a seguito di un'emissione di azioni al 17 apr 2013

    • Capitale: GBP 84,620,040
    3 pagineSH01

    Bilancio redatto al 31 ott 2012

    14 pagineAA

    Bilancio annuale redatto al 06 lug 2012 con elenco completo degli azionisti

    4 pagineAR01

    Nomina di Mr Roberto Adriano Putland come amministratore

    2 pagineAP01

    Cessazione della carica di Jonathan Savage come amministratore

    1 pagineTM01

    Bilancio redatto al 31 ott 2011

    15 pagineAA

    Cessazione della carica di Thomas Perkins come segretario

    1 pagineTM02

    Chi sono gli amministratori di SHL TECHNOLOGY SOLUTIONS LIMITED?

    Amministratori
    NomeNominato ilDimissioni ilRuoloIndirizzoIdentificazione della societàPaese di residenzaNazionalitàData di nascitaProfessioneNumero
    TROWER, Tara Dawn
    Cain Road
    RG12 1HN Bracknell
    Amen Corner
    Berkshire
    United Kingdom
    Segretario
    Cain Road
    RG12 1HN Bracknell
    Amen Corner
    Berkshire
    United Kingdom
    187391680001
    TROWER, Tara Dawn
    Cain Road
    RG12 1HN Bracknell
    Amen Corner
    Berkshire
    United Kingdom
    Amministratore
    Cain Road
    RG12 1HN Bracknell
    Amen Corner
    Berkshire
    United Kingdom
    EnglandBritish134963980001
    HILL, Derek
    Woodside Cottage 192 Church Lane
    Marple
    SK6 7LA Stockport
    Cheshire
    Segretario
    Woodside Cottage 192 Church Lane
    Marple
    SK6 7LA Stockport
    Cheshire
    British43301210001
    LA CALAMITA, John Michael
    113 Lord Seaton Road
    M2P 1K8 North York
    Ontario
    Canada
    Segretario
    113 Lord Seaton Road
    M2P 1K8 North York
    Ontario
    Canada
    British51659910001
    ORMROD, James
    10 Midgham Green
    Midgham
    RG7 5TT Reading
    Webcroft
    Berks
    Segretario
    10 Midgham Green
    Midgham
    RG7 5TT Reading
    Webcroft
    Berks
    Other130250210001
    PERKINS, Thomas Clark
    Cain Road
    RG12 1HN Bracknell
    Amen Corner
    Berkshire
    United Kingdom
    Segretario
    Cain Road
    RG12 1HN Bracknell
    Amen Corner
    Berkshire
    United Kingdom
    147686750001
    PHILLIPS, Lawrence Stephen
    42 Cowper Road
    AL5 5NG Harpenden
    Hertfordshire
    Segretario
    42 Cowper Road
    AL5 5NG Harpenden
    Hertfordshire
    British11800250003
    PRICHARD, Teresa Joan
    4 Bracken Gardens
    Barnes
    SW13 9HW London
    Segretario
    4 Bracken Gardens
    Barnes
    SW13 9HW London
    British42862810001
    PUTLAND, Roberto
    Cain Road
    RG12 1HN Bracknell
    Amen Corner
    Berkshire
    United Kingdom
    Segretario
    Cain Road
    RG12 1HN Bracknell
    Amen Corner
    Berkshire
    United Kingdom
    162796870001
    ROY, David Maitland
    14 Lovell Road
    Oakley
    MK43 7RZ Bedford
    Segretario
    14 Lovell Road
    Oakley
    MK43 7RZ Bedford
    British46026850002
    EDS SECRETARIAL SERVICES LIMITED
    4 Roundwood Avenue
    Stockley Park
    UB11 1BQ Uxbridge
    Middlesex
    Segretario
    4 Roundwood Avenue
    Stockley Park
    UB11 1BQ Uxbridge
    Middlesex
    69779900001
    BURR, Steven David
    Cain Road
    RG12 1HN Bracknell
    Amen Corner
    Berkshire
    United Kingdom
    Amministratore
    Cain Road
    RG12 1HN Bracknell
    Amen Corner
    Berkshire
    United Kingdom
    EnglandBritish138588120001
    CRONIN, Thomas Alfred
    20 Ilchester Mansions
    Abingdon Road
    W8 6AE London
    Amministratore
    20 Ilchester Mansions
    Abingdon Road
    W8 6AE London
    Canadian56798460001
    DAMP, Paul David
    9 Bowring Walk
    M3H 525 North York
    Ontario
    Canada
    Amministratore
    9 Bowring Walk
    M3H 525 North York
    Ontario
    Canada
    CanadaCanadian230526150001
    GAFFNEY, Thomas Anthony
    19 Pensford Avenue
    TW9 4HR Richmond
    Surrey
    Amministratore
    19 Pensford Avenue
    TW9 4HR Richmond
    Surrey
    Canadian/Irish54394580001
    GILL, Dara Singh
    Cain Road
    RG12 1HN Bracknell
    Amen Corner
    Berkshire
    United Kingdom
    Amministratore
    Cain Road
    RG12 1HN Bracknell
    Amen Corner
    Berkshire
    United Kingdom
    Great BritainBritish149165080001
    GILL, Stephen
    Woodlee Hall
    Callow Hill
    GU25 4LL Virginia Water
    Surrey
    Amministratore
    Woodlee Hall
    Callow Hill
    GU25 4LL Virginia Water
    Surrey
    British56193720001
    GLAZEBROOK, Colin
    High Ridge Chadwell Rise
    SG12 9LA Ware
    Hertfordshire
    Amministratore
    High Ridge Chadwell Rise
    SG12 9LA Ware
    Hertfordshire
    British16711410001
    GRANT, Andrew Michael
    22 Witches Lane
    TN13 2AX Sevenoaks
    Kent
    Amministratore
    22 Witches Lane
    TN13 2AX Sevenoaks
    Kent
    British59643580001
    HAWES, Kenneth Robert
    Beech House 361 Hale Road
    Halebarns
    WA15 8TB Altrincham
    Cheshire
    Amministratore
    Beech House 361 Hale Road
    Halebarns
    WA15 8TB Altrincham
    Cheshire
    British16711440001
    HILL, Derek
    Woodside Cottage 192 Church Lane
    Marple
    SK6 7LA Stockport
    Cheshire
    Amministratore
    Woodside Cottage 192 Church Lane
    Marple
    SK6 7LA Stockport
    Cheshire
    EnglandBritish43301210001
    LAMBTON, Mark Norman
    Station Road
    GU10 5JZ Bentley
    Lavender Cottage
    Surrey
    Amministratore
    Station Road
    GU10 5JZ Bentley
    Lavender Cottage
    Surrey
    United KingdomBritish162510100001
    LAY, Graham Richard David
    33 Hollybush Lane
    Datchworth
    SG3 6RE Knebworth
    Herts
    Amministratore
    33 Hollybush Lane
    Datchworth
    SG3 6RE Knebworth
    Herts
    EnglandBritish33300160001
    LEWTHWAITE, Mark
    Tokers Green Lane
    RG4 9AY Kidmore End
    Highfields
    South Oxfordshire
    Amministratore
    Tokers Green Lane
    RG4 9AY Kidmore End
    Highfields
    South Oxfordshire
    EnglandBritish134517020001
    LINTON, William Warwick
    18 Edgehill Road
    Etobicoke
    Ontario
    M9a 4n3
    Canada
    Amministratore
    18 Edgehill Road
    Etobicoke
    Ontario
    M9a 4n3
    Canada
    CanadaCanadian115579350001
    LUKES, Edward Frank
    16
    St Mary Abbots Terrace
    W14 8NX London
    Amministratore
    16
    St Mary Abbots Terrace
    W14 8NX London
    American44180480001
    MACDONALD, Iain Archibald
    Blackford House Macclesfield Road
    SK9 7BH Alderley Edge
    Cheshire
    Amministratore
    Blackford House Macclesfield Road
    SK9 7BH Alderley Edge
    Cheshire
    British3614100001
    MADDEN, James
    724 Harbor Island Drive
    Newport Beach 92660
    California
    Usa
    Amministratore
    724 Harbor Island Drive
    Newport Beach 92660
    California
    Usa
    American65642080001
    MCGOUN, Michael Frederick
    The Old Rectory Church Lane
    Mobberley
    WA16 7RD Knutsford
    Cheshire
    Amministratore
    The Old Rectory Church Lane
    Mobberley
    WA16 7RD Knutsford
    Cheshire
    EnglandBritish8300340001
    MCLAREN, Donald Ian
    17
    Catherwood Court
    Kanata
    Ontario K2k 2ki
    Canada
    Amministratore
    17
    Catherwood Court
    Kanata
    Ontario K2k 2ki
    Canada
    Canadian62159130001
    MOSES, Dhyanchand
    3716 Nash Lane
    Plano
    Texas 75025
    Usa
    Amministratore
    3716 Nash Lane
    Plano
    Texas 75025
    Usa
    American64548230001
    PAYNE, Stuart Michael
    2 Highgrove Close
    BR7 5SA Chislehurst
    Kent
    Amministratore
    2 Highgrove Close
    BR7 5SA Chislehurst
    Kent
    United KingdomBritish17465450001
    PUTLAND, Roberto Adriano
    Cain Road
    RG12 1HN Bracknell
    Amen Corner
    Berkshire
    United Kingdom
    Amministratore
    Cain Road
    RG12 1HN Bracknell
    Amen Corner
    Berkshire
    United Kingdom
    EnglandBritish162794370001
    SANDIFORD, Peter
    Lakeview Terrace
    Ottawa
    2
    Ontario, K1s3h4
    Canada
    Amministratore
    Lakeview Terrace
    Ottawa
    2
    Ontario, K1s3h4
    Canada
    CanadaCanadian129544830001
    SAVAGE, Jonathan
    Cain Road
    RG12 1HN Bracknell
    Amen Corner
    Berkshire
    United Kingdom
    Amministratore
    Cain Road
    RG12 1HN Bracknell
    Amen Corner
    Berkshire
    United Kingdom
    United KingdomNew Zealander152970170001

    SHL TECHNOLOGY SOLUTIONS LIMITED ha ipoteche?

    Ipoteche
    ClassificazioneDateStatoDettagli
    Mortgage debenture
    Creato il 30 nov 1993
    Consegnato il 01 dic 1993
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Unit b boulevard ind: park beacon road beeston broxton nottingham. Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Royal Bank of Canada Europe Limited
    Transazioni
    • 01 dic 1993Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 05 ago 1994Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Legal charge
    Creato il 18 giu 1992
    Consegnato il 26 giu 1992
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    F/H land and buildings k/as finney green cottage 134 manchester road wilmslow macclesfield cheshire t/no ch 341638 fixed charge over the benefit of all covenants and rights,plant machinery, fixtures and fittings.
    Persone aventi diritto
    • The Royal Bank of Scotland PLC
    Transazioni
    • 26 giu 1992Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 01 ott 1993Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Legal charge
    Creato il 26 lug 1991
    Consegnato il 15 ago 1991
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    By way of legal mortgage f/h property k/a unit b, bolevard industrial park, beeston, nottingham. Fixed charge over all plant machinery implements utensils furniture and equipment.
    Persone aventi diritto
    • The Royal Bank of Scotland PLC
    Transazioni
    • 15 ago 1991Registrazione di un'ipoteca
    • 27 set 1994Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Group guarantee debenture
    Creato il 29 nov 1984
    Consegnato il 19 dic 1984
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company and/or cablegrace limited to the chargee on any account whatsoever.
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Persone aventi diritto
    • Manufacturers Hanover Trust Company
    Transazioni
    • 19 dic 1984Registrazione di un'ipoteca
    Debenture
    Creato il 31 ott 1984
    Consegnato il 12 nov 1984
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Persone aventi diritto
    • Williams & Glyns Bank PLC
    Transazioni
    • 12 nov 1984Registrazione di un'ipoteca
    • 27 set 1994Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)

    SHL TECHNOLOGY SOLUTIONS LIMITED ha procedimenti di insolvenza?

    Numero di praticaDateTipoProfessionistiAltro
    1
    DataTipo
    14 lug 2015Inizio della liquidazione
    07 set 2016Data di scioglimento
    Liquidazione volontaria dei soci
    NomeRuoloIndirizzoNominato ilCessato il
    Karen Lesley Dukes
    7 More London Riverside
    SE1 2RT London
    Praticante
    7 More London Riverside
    SE1 2RT London
    Timothy Gerard Walsh
    7 More London Riverside
    SE1 2RT London
    Praticante
    7 More London Riverside
    SE1 2RT London

    Fonte dati

    • Companies House del Regno Unito
      Il registro ufficiale delle imprese nel Regno Unito, che fornisce l'accesso pubblico alle informazioni sulle imprese, come nomi, indirizzi, amministratori e depositi finanziari.
    • Licenza: CC0