HARBOUR PROPERTIES LIMITED
Panoramica
| Nome della società | HARBOUR PROPERTIES LIMITED |
|---|---|
| Stato della società | Sciolta |
| Forma giuridica | Società a responsabilità limitata |
| Numero di società | 01833719 |
| Giurisdizione | Inghilterra/Galles |
| Data di costituzione | |
| Data di cessazione |
Riepilogo
| Ha PSCs super sicuri | No |
|---|---|
| Ha ipoteche | Sì |
| Ha una storia di insolvenza | No |
| La sede legale è in contestazione | No |
Qual è lo scopo di HARBOUR PROPERTIES LIMITED?
- Società inattiva (99999) / Attività di organizzazioni ed organismi extraterritoriali
Dove si trova HARBOUR PROPERTIES LIMITED?
| Indirizzo della sede legale | Cornwall House Blythe Gate Blythe Valley Park B90 8AF Solihull West Midlands United Kingdom |
|---|---|
| Indirizzo della sede legale non recapitabile | No |
Quali erano i nomi precedenti di HARBOUR PROPERTIES LIMITED?
| Nome della società | Da | A |
|---|---|---|
| FLAMELINK LIMITED | 18 lug 1984 | 18 lug 1984 |
Quali sono gli ultimi bilanci di HARBOUR PROPERTIES LIMITED?
| Ultimi bilanci | |
|---|---|
| Ultimi bilanci redatti al | 30 giu 2022 |
Quali sono le ultime deposizioni per HARBOUR PROPERTIES LIMITED?
| Data | Descrizione | Documento | Tipo | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gazzetta Ufficiale finale sciolta per scioglimento volontario | 1 pagine | GAZ2(A) | ||||||||||||||||||
Prima Gazzetta Ufficiale per lo scioglimento volontario | 1 pagine | GAZ1(A) | ||||||||||||||||||
Richiesta di cancellazione della società dal registro | 1 pagine | DS01 | ||||||||||||||||||
Notifica di Dollplace Limited come persona con controllo significativo il 13 giu 2023 | 2 pagine | PSC02 | ||||||||||||||||||
Cessazione di Goodman Real Estate Services (Uk) Limited come persona con controllo significativo il 13 giu 2023 | 1 pagine | PSC07 | ||||||||||||||||||
Memorandum e Statuto | 26 pagine | MA | ||||||||||||||||||
Risoluzioni Resolutions | 1 pagine | RESOLUTIONS | ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
Stato del capitale a seguito di un'emissione di azioni al 07 giu 2023
| 3 pagine | SH01 | ||||||||||||||||||
Stato del capitale al 08 giu 2023
| 3 pagine | SH19 | ||||||||||||||||||
legacy | 1 pagine | SH20 | ||||||||||||||||||
legacy | 2 pagine | CAP-SS | ||||||||||||||||||
Risoluzioni Resolutions | 1 pagine | RESOLUTIONS | ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
Dichiarazione di conformità presentata il 23 apr 2023 senza aggiornamenti | 3 pagine | CS01 | ||||||||||||||||||
Dettagli del direttore cambiati per Mr Peter Christopher Ralston il 20 set 2021 | 2 pagine | CH01 | ||||||||||||||||||
Dettagli del direttore cambiati per Mr Robert Paul Reed il 20 set 2021 | 2 pagine | CH01 | ||||||||||||||||||
Dettagli del direttore cambiati per Mr James Martin Cornell il 20 set 2021 | 2 pagine | CH01 | ||||||||||||||||||
Conto per una società dormiente redatto al 30 giu 2022 | 8 pagine | AA | ||||||||||||||||||
Dichiarazione di conformità presentata il 23 apr 2022 senza aggiornamenti | 3 pagine | CS01 | ||||||||||||||||||
Conto per una società dormiente redatto al 30 giu 2021 | 8 pagine | AA | ||||||||||||||||||
Dettagli del segretario cambiati per Ancosec Limited il 20 set 2021 | 1 pagine | CH04 | ||||||||||||||||||
Modifica dei dettagli di Goodman Real Estate Services (Uk) Limited come persona con controllo significativo il 20 set 2021 | 2 pagine | PSC05 | ||||||||||||||||||
Indirizzo della sede legale modificato da Nelson House Central Boulevard, Blythe Valley Park Solihull West Midlands B90 8BG a Cornwall House Blythe Gate Blythe Valley Park Solihull West Midlands B90 8AF in data 20 set 2021 | 1 pagine | AD01 | ||||||||||||||||||
Conto per una società dormiente redatto al 30 giu 2020 | 8 pagine | AA | ||||||||||||||||||
Dichiarazione di conformità presentata il 23 apr 2021 senza aggiornamenti | 3 pagine | CS01 | ||||||||||||||||||
Dichiarazione di conformità presentata il 23 apr 2020 senza aggiornamenti | 3 pagine | CS01 | ||||||||||||||||||
Chi sono gli amministratori di HARBOUR PROPERTIES LIMITED?
| Nome | Nominato il | Dimissioni il | Ruolo | Indirizzo | Identificazione della società | Paese di residenza | Nazionalità | Data di nascita | Professione | Numero | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ANCOSEC LIMITED | Segretario | Blythe Gate Blythe Valley Park B90 8AF Solihull Cornwall House West Midlands United Kingdom |
| 111724450001 | ||||||||||
| CORNELL, James Martin | Amministratore | Blythe Gate Blythe Valley Park B90 8AF Solihull Cornwall House United Kingdom | England | British | 148803950001 | |||||||||
| RALSTON, Peter Christopher | Amministratore | Blythe Gate Blythe Valley Park B90 8AF Solihull Cornwall House United Kingdom | United Kingdom | British | 110237280002 | |||||||||
| REED, Robert Paul | Amministratore | Blythe Gate Blythe Valley Park B90 8AF Solihull Cornwall House United Kingdom | United Kingdom | British | 148032280006 | |||||||||
| DUFFIELD, David Mark Johnston | Segretario | 58 West Chiltern Woodcote RG8 0SG Reading Berkshire | British | 49654480002 | ||||||||||
| EVANS, David Malcolm | Segretario | Springdale Shobley BH24 3HT Ringwood Hampshire | British | 27482710001 | ||||||||||
| FERGUSON, Iain Donald | Segretario | 2 Chalet Close Shootersway Lane HP4 3NR Berkhamsted Hertfordshire | British | 10297860001 | ||||||||||
| LYNE, Sarah Jane | Segretario | 11 Abelia Close West End GU24 9PG Woking Surrey | British | 49635520003 | ||||||||||
| READ, Jonathan David | Segretario | 179 Tanworth Lane Shirley B90 4BZ Solihull West Midlands | British | 77460610002 | ||||||||||
| SWAIN, John Kenneth | Segretario | 77 Grosvenor Street W1A 2BT London | British | 33262350001 | ||||||||||
| AUSTEN, Jonathan Martin | Amministratore | Lygon Croft Sandy Way KT11 2EY Cobham Surrey | United Kingdom | British | 51921200001 | |||||||||
| CHATER, Beth Salena | Amministratore | Langham Lodge Bucklebury Alley RG18 9NH Newbury Berkshire | United Kingdom | British | 60464290003 | |||||||||
| DEIGMAN, Patrick | Amministratore | Frith Hill House Frith Hill HP16 0QR Great Missenden Buckinghamshire | United Kingdom | British | 37099910001 | |||||||||
| DIGBY, Michael Essex | Amministratore | Hillier Parker May & Rowden 77 Grosvenor Street W1A 2BT London | British | 12476600001 | ||||||||||
| DUFFIELD, David Mark Johnston | Amministratore | 58 West Chiltern Woodcote RG8 0SG Reading Berkshire | England | British | 49654480002 | |||||||||
| FERGUSON, Iain Donald | Amministratore | 2 Chalet Close Shootersway Lane HP4 3NR Berkhamsted Hertfordshire | United Kingdom | British | 10297860001 | |||||||||
| FLETCHER, David Jonathan Richard | Amministratore | Stratton House Stratton Street W1X 5FE London | United Kingdom | British | 10597290001 | |||||||||
| JOHNSTON, Andrew James | Amministratore | Central Boulevard, Blythe Valley Park B90 8BG Solihull Nelson House West Midlands England | United Kingdom | British | 131001620001 | |||||||||
| LYALL, Stephen Charles | Amministratore | 77 Grosvenor Street W1A 2BT London | British | 44917590001 | ||||||||||
| MOHANLAL, Satish | Amministratore | 21 Mostyn Gardens NW10 5QU London | British | 51579180001 | ||||||||||
| MURRAY, Nicholas Stuart Granville | Amministratore | Oak House 51 Oxshott Way KT11 2RU Cobham Surrey | United Kingdom | British | 29664370001 | |||||||||
| O'SULLIVAN, Michael James | Amministratore | Greenlawns 21 Broad Highway KT11 2RR Cobham Surrey | Australian | 109785090002 | ||||||||||
| PILGRIM, Simon Richard Ellis | Amministratore | Maytrees 27 Portmore Park Road KT13 8ET Weybridge Surrey | British | 16398280001 | ||||||||||
| POPE, Nigel Howard | Amministratore | Hawthorne Road BR1 2HN Bromley 17 Kent | England | British | 29583660002 | |||||||||
| PULSFORD, Jeffrey Mark | Amministratore | Denesfield 16 Lytton Park KT11 2HB Cobham Surrey | United Kingdom | British | 49776690004 | |||||||||
| ROGERS, Hugh Edward | Amministratore | 24 Sonning Meadows RG4 6XB Sonning Berkshire | British | 13156340003 | ||||||||||
| SADLER, Nicholas James | Amministratore | Clivia Windmill Hill Coleshill HP7 0LZ Amersham Buckinghamshire | British | 38200390001 | ||||||||||
| SMITH, Oliver | Amministratore | 48 Redcliffe Gardens SW10 9HB London | British | 83475590003 |
Chi sono le persone con controllo significativo di HARBOUR PROPERTIES LIMITED?
| Nome | Notificato il | Indirizzo | Cessato | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dollplace Limited | 13 giu 2023 | Blythe Gate Blythe Valley Park B90 8AF Solihull Cornwall House United Kingdom | No | ||||||||||
| |||||||||||||
Natura del controllo
| |||||||||||||
| Goodman Real Estate Services (Uk) Limited | 23 apr 2018 | Blythe Gate Blythe Valley Park B90 8AF Solihull Cornwall House West Midlands United Kingdom | Sì | ||||||||||
| |||||||||||||
Natura del controllo
| |||||||||||||
| Goodman Real Estate Developments (2003) | 06 apr 2016 | Central Boulevard Blythe Valley Park B90 8BG Solihull Nelson House West Midlands United Kingdom | Sì | ||||||||||
| |||||||||||||
Natura del controllo
| |||||||||||||
HARBOUR PROPERTIES LIMITED ha ipoteche?
| Classificazione | Date | Stato | Dettagli | |
|---|---|---|---|---|
| Legal charge | Creato il 16 nov 1999 Consegnato il 19 nov 1999 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the agreement dated 16TH november 1999 and on any account whatsoever and other sums due under the legal charge dated 16TH november 1999 | |
Brevi particolari F/H property at western avenue uxbridge t/no BM110852 & BM85925 with all buildings erections fixtures and fittings fixed plant & machinery. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
| Deposit of title deeds | Creato il 29 mag 1985 Consegnato il 11 giu 1985 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due or to become due from the company to the chargee not exceeding £73,000 under the terms of a sale and purchase agreement d/d 30/4/85. | |
Brevi particolari Part of land k/a oak view 3 gull copse park gate t/n:- hp 202570. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
| Deposit of deeds w/i | Creato il 30 apr 1985 Consegnato il 04 mag 1985 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due or to become due from the company to the chargee not exceeding £66,000 under the terms of an agreement of even date | |
Brevi particolari Land to the north of little park farm, little park farm road, titchfield and the land to the east of hazelgrove foreham T.nos. Hp 95290 & hp 118180. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
| Deposit of deeds w/i | Creato il 30 apr 1985 Consegnato il 04 mag 1985 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due or to become due from the company to the chargee not exceeding £21,000 under the terms of an agreement to even date | |
Brevi particolari Land to the north west at hill coppice road. T.N. hp 1083149. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
| Deposit of deeds w/i | Creato il 30 apr 1985 Consegnato il 03 mag 1985 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due or to become due from the company to the chargee not exceeding £108,000 under the terms of an agreement of even date | |
Brevi particolari Land at ashley little park gull coppice titchfield T.N. hp 210763. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
| Deposit of deeds w/i | Creato il 30 apr 1985 Consegnato il 03 mag 1985 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due or to become due from the company to the chargee not exceeding £50,000 under the terms of an agreement of even date. | |
Brevi particolari Land at ashley little park gull coppice, titchfield T.N. hp 210762. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
| Deposit of deeds w/i | Creato il 30 apr 1985 Consegnato il 03 mag 1985 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due or to become due from the company to the chargee not cxceeding £103,000 under the terms of an agreement of even date. | |
Brevi particolari Land at gull copse park gate. T.N.hp 262278. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
| Legal charge | Creato il 05 feb 1985 Consegnato il 05 feb 1985 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of an agreement d/d 21 december 1984 or this charge. | |
Brevi particolari Land at park gate titchfield hampshire (see doc M18). | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
Fonte dati
- Companies House del Regno Unito
Il registro ufficiale delle imprese nel Regno Unito, che fornisce l'accesso pubblico alle informazioni sulle imprese, come nomi, indirizzi, amministratori e depositi finanziari. - Licenza: CC0