APPOLD PROPERTY MANAGEMENT LIMITED
Panoramica
| Nome della società | APPOLD PROPERTY MANAGEMENT LIMITED |
|---|---|
| Stato della società | Sciolta |
| Forma giuridica | Società a responsabilità limitata |
| Numero di società | 01836659 |
| Giurisdizione | Inghilterra/Galles |
| Data di costituzione | |
| Data di cessazione |
Riepilogo
| Ha PSCs super sicuri | No |
|---|---|
| Ha ipoteche | Sì |
| Ha una storia di insolvenza | Sì |
| La sede legale è in contestazione | No |
Qual è lo scopo di APPOLD PROPERTY MANAGEMENT LIMITED?
- Intermediazione finanziaria non classificata altrove (64999) / Attività finanziarie e assicurative
Dove si trova APPOLD PROPERTY MANAGEMENT LIMITED?
| Indirizzo della sede legale | 30 Finsbury Square EC2P 2YU London |
|---|---|
| Indirizzo della sede legale non recapitabile | No |
Quali erano i nomi precedenti di APPOLD PROPERTY MANAGEMENT LIMITED?
| Nome della società | Da | A |
|---|---|---|
| SHAMROCK LEASING LIMITED | 29 dic 1997 | 29 dic 1997 |
| APPOLD LEASING LIMITED | 09 gen 1995 | 09 gen 1995 |
| APPOLD SECURITIES LIMITED | 06 apr 1992 | 06 apr 1992 |
| HOARE GOVETT SECURITIES LIMITED | 13 ott 1986 | 13 ott 1986 |
| HOARE GOVETT MARKET MAKERS LIMITED | 22 lug 1986 | 22 lug 1986 |
| CHARLES T. PULLEY LIMITED | 27 lug 1984 | 27 lug 1984 |
Quali sono gli ultimi bilanci di APPOLD PROPERTY MANAGEMENT LIMITED?
| Ultimi bilanci | |
|---|---|
| Ultimi bilanci redatti al | 31 dic 2015 |
Quali sono le ultime deposizioni per APPOLD PROPERTY MANAGEMENT LIMITED?
| Data | Descrizione | Documento | Tipo | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gazzetta ufficiale finale sciolta a seguito di liquidazione | 1 pagine | GAZ2 | ||||||||||||||
Ritorno della riunione finale in una liquidazione volontaria dei membri | 8 pagine | LIQ13 | ||||||||||||||
Indirizzo della sede legale modificato da 2 King Edward Street London EC1A 1HQ a 30 Finsbury Square London EC2P 2YU in data 30 mag 2017 | 2 pagine | AD01 | ||||||||||||||
Nomina di un liquidatore volontario | 1 pagine | 600 | ||||||||||||||
Dichiarazione di solvibilità | 5 pagine | LIQ01 | ||||||||||||||
Risoluzioni Resolutions | 1 pagine | RESOLUTIONS | ||||||||||||||
| ||||||||||||||||
Dichiarazione di conformità presentata il 15 mar 2017 con aggiornamenti | 5 pagine | CS01 | ||||||||||||||
Soddisfazione dell'onere 10 in pieno | 4 pagine | MR04 | ||||||||||||||
Soddisfazione dell'onere 11 in pieno | 6 pagine | MR04 | ||||||||||||||
Nomina di Jonathan Howard Redvers Lee come amministratore in data 26 ott 2016 | 2 pagine | AP01 | ||||||||||||||
Cessazione della carica di Richard Ian Jones come amministratore in data 19 ott 2016 | 1 pagine | TM01 | ||||||||||||||
Conto per una società dormiente redatto al 31 dic 2015 | 270 pagine | AA | ||||||||||||||
Bilancio annuale redatto al 02 apr 2016 con elenco completo degli azionisti | 5 pagine | AR01 | ||||||||||||||
| ||||||||||||||||
Bilancio consolidato redatto al 31 dic 2014 | 21 pagine | AA | ||||||||||||||
Nomina di Philip John Wood come amministratore in data 09 giu 2015 | 2 pagine | AP01 | ||||||||||||||
Cessazione della carica di Jacob Dutry Van Haeften come amministratore in data 07 mag 2015 | 1 pagine | TM01 | ||||||||||||||
Bilancio annuale redatto al 02 apr 2015 con elenco completo degli azionisti | 5 pagine | AR01 | ||||||||||||||
| ||||||||||||||||
Dettagli del direttore cambiati per Jacob Dutry Van Haeften il 28 feb 2014 | 2 pagine | CH01 | ||||||||||||||
legacy | 1 pagine | SH20 | ||||||||||||||
Stato del capitale al 16 ott 2014
| 4 pagine | SH19 | ||||||||||||||
legacy | 1 pagine | CAP-SS | ||||||||||||||
Risoluzioni Resolutions | RESOLUTIONS | |||||||||||||||
| ||||||||||||||||
Bilancio consolidato redatto al 31 dic 2013 | 20 pagine | AA | ||||||||||||||
Cessazione della carica di Kerry Eamonn O'connell come amministratore in data 04 ago 2014 | 1 pagine | TM01 | ||||||||||||||
Bilancio annuale redatto al 02 apr 2014 con elenco completo degli azionisti | 6 pagine | AR01 | ||||||||||||||
| ||||||||||||||||
Chi sono gli amministratori di APPOLD PROPERTY MANAGEMENT LIMITED?
| Nome | Nominato il | Dimissioni il | Ruolo | Indirizzo | Identificazione della società | Paese di residenza | Nazionalità | Data di nascita | Professione | Numero | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MERRILL LYNCH CORPORATE SERVICES LIMITED | Segretario | King Edward Street EC1A 1HQ London 2 United Kingdom |
| 93977210001 | ||||||||||
| LEE, Jonathan Howard Redvers | Amministratore | King Edward Street EC1A 1HQ London 2 United Kingdom | England | British | 156416990001 | |||||||||
| WOOD, Philip John | Amministratore | King Edward Street EC1A 1HQ London 2 United Kingdom | United Kingdom | British | 173550830001 | |||||||||
| CHURCH, Fiona | Segretario | King Edward Street EC1A 1HQ London 2 United Kingdom | British | 116911130001 | ||||||||||
| CLOWES, Stephen Bernard | Segretario | Hartsridge Harts Lane, South Godstone RH9 8LZ Godstone Surrey | British | 40195710004 | ||||||||||
| LI, Helene Yuk Hing | Segretario | King Edward Street EC1A 1HQ London 2 | British | 147657130001 | ||||||||||
| STEVENS, Robert Brian | Segretario | 139 Rusthall Avenue Chiswick W4 1BL London | British | 28371200001 | ||||||||||
| STEVINSON, Jenny | Segretario | 95 Stradella Road SE24 9HL London | British | 16404200002 | ||||||||||
| TILGNER, Tracy K | Segretario | Flat 8 55 Queensgate SW7 5JW London | American | 36015120001 | ||||||||||
| ARNUM, Dennis | Amministratore | Fairacres 1 Downs Way KT20 5DH Tadworth Surrey | British | 37241020001 | ||||||||||
| CLEGG, Simon John | Amministratore | Hill Cottage Reading Road Heckfield RG27 0JY Hook Hampshire | British | 61950010001 | ||||||||||
| CLOWES, Stephen Bernard | Amministratore | Hartsridge Harts Lane, South Godstone RH9 8LZ Godstone Surrey | United Kingdom | British | 40195710004 | |||||||||
| DEYONG, Jacqueline Susan | Amministratore | Hayes Cottage 192 Old Woking Road GU22 8HR Woking Surrey | England | British | 25974390001 | |||||||||
| DUTRY VAN HAEFTEN, Jacob | Amministratore | King Edward Street EC1A 1HQ London 2 England | United Kingdom | Dutch | 172432560002 | |||||||||
| DUTTON, Godfrey Thomas | Amministratore | 58 Willingale Way SS1 3SN Thorpe Bay Essex | United Kingdom | British | 42461110001 | |||||||||
| HOFFMAN, Mark Thomas | Amministratore | King Edward Street EC1A 1HQ London 2 United Kingdom | United Kingdom | American | 87065070002 | |||||||||
| HOUSTON, Geoffrey Alan | Amministratore | Ashley House Chiltern Road Chesham Bois HP6 5PG Amersham Buckinghamshire | British | 62886570001 | ||||||||||
| JONES, Richard Ian | Amministratore | King Edward Street EC1A 1HQ London 2 | United Kingdom | British | 159225600001 | |||||||||
| MAZZOLA, Stefano Antonio | Amministratore | 23 Westmoreland Terrace SW1V 4AG London | United Kingdom | British | 8890420001 | |||||||||
| O'CONNELL, Kerry Eamonn | Amministratore | King Edward Street EC1A 1HQ London 2 | United Kingdom | British | 69128130002 | |||||||||
| PITHIA, Kantilal Girdharlal | Amministratore | Canada Square E14 5AQ London 5 | British | 68481610001 | ||||||||||
| SHEALY, Thomas Theodore | Amministratore | 1 Alie Street E1 8DE London | American | 88998990001 | ||||||||||
| SMITH, Mark Simon Martin | Amministratore | 5 Canada Square E14 5AQ London | British | 121952750001 | ||||||||||
| STEVENS, Robert Brian | Amministratore | 139 Rusthall Avenue Chiswick W4 1BL London | British | 28371200001 | ||||||||||
| TETZLAFF, John Stefan Ashby | Amministratore | 5 Canada Square E14 5AQ London | British | 116726040001 | ||||||||||
| THOMSON, David Fraser | Amministratore | King Edward Street EC1A 1HQ London 2 United Kingdom | United Kingdom | British | 74549300002 | |||||||||
| TILGNER, Tracy K | Amministratore | Flat 8 55 Queensgate SW7 5JW London | American | 36015120001 | ||||||||||
| WESTBROOK, Robert William | Amministratore | King Edward Street EC1A 1HQ London 2 | United Kingdom | British | 169811350001 | |||||||||
| WHITAKER, Robert Anthony Mattievich | Amministratore | 38 Florin Court 6/9 Charterhouse Square EC1M 6EY London | British | 66770990001 | ||||||||||
| WITHAM, Geoffrey Alan | Amministratore | 215 Hanging Hill Lane Hutton CM13 2QG Brentwood Essex | British | 7752430001 |
Chi sono le persone con controllo significativo di APPOLD PROPERTY MANAGEMENT LIMITED?
| Nome | Notificato il | Indirizzo | Cessato | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bank Of America Corporation | 06 apr 2016 | 1209 Orange Street Wilmington The Corporation Trust Center De 19801 Usa | No | ||||||||||
| |||||||||||||
Natura del controllo
| |||||||||||||
APPOLD PROPERTY MANAGEMENT LIMITED ha ipoteche?
| Classificazione | Date | Stato | Dettagli | |
|---|---|---|---|---|
| Deed of charge | Creato il 28 feb 1991 Consegnato il 01 mar 1991 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Brevi particolari Fixed charge over all sums floating charge over stock and other securities (see form 395 for full details). | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
| Deed | Creato il 22 giu 1990 Consegnato il 28 giu 1990 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the charge | |
Brevi particolari Fixed charge over all sums from time to time deposited by the company or for the company's accounts with and held by the mortgagees (see form 395 for full details. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
| Collateral agreement | Creato il 24 feb 1989 Consegnato il 01 mar 1989 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Brevi particolari All "collateral" including in particular cash and securities clearance accounts opened in connection with the euro-clear system by the brussels office of morgan guaranty on its books in the name of the company (see form 395 for full details). | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
| Letter agreement | Creato il 28 lug 1987 Consegnato il 12 ago 1987 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the charge | |
Brevi particolari See form 395 for full details. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
| Security agreement | Creato il 21 lug 1987 Consegnato il 28 lug 1987 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due or to become due from the company to the chargee | |
Brevi particolari All adrs which were at the date of the security agreement in possession of the chargee and held for the account of the company (see form 395 for full details). | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
| Deed | Creato il 21 lug 1987 Consegnato il 28 lug 1987 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due or to become due from the company to the chargee | |
Brevi particolari First fixed charge over all sums from time to time deposited by the company or for the company's account with & held by morgan guaranty trust company in the account (s) in the name of the company denominated "adr pre-release collateral account(s) together with the debts arising therefrom or in respect thereof. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
| Charge | Creato il 23 ott 1986 Consegnato il 04 nov 1986 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Brevi particolari All the company's rights interest & property present and future in all securities transferred to national westminster bank PLC or its nominees by the stock exchange pursuant to any short term certificate issued to the bank in accordance with the provisions of any written agreement relating to non-endorseable short term certificates for the time being in face between the stock exchange, the company & the bank (for details see form 395). | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
| Charge in compliance with the rules and regulations (including council notices) of the stock exchange | Creato il 23 ott 1986 Consegnato il 03 nov 1986 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due or to become due from the company to the chargee | |
Brevi particolari All shares stock & other securities of any description which are for the time being designated by the stock exchange as talisman securities (see form 395 dated for 3/11/86 for full details). | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
| Legal charge | Creato il 07 nov 1985 Consegnato il 25 nov 1985 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Brevi particolari All the rights interest and property present or future of the company (whether at law or in equity) in all securities transferred to the company or its nominees of the stock exchange present to any short term certificate issued to national westminster bank PLC. See doc M10 for full details. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
| Charge | Creato il 08 ago 1985 Consegnato il 19 ago 1985 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the charge | |
Brevi particolari All shares stock and other securities of any description which are for the time being designated by the stock exchange as talisman securities (see doc M9 for details). | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
| Charge | Creato il 01 ago 1984 Consegnato il 17 ago 1984 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Brevi particolari The securities therein defined together with all benefits arising therefrom and not transferred by the stock exchange to the company for details see doc M8. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
| Deed of variation | Creato il 01 ago 1984 Consegnato il 17 ago 1984 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito For varying the terms of the principal charge of even date | |
Brevi particolari The deed varis the definition of the securities which are subject to the principal charge and also affects the ranking of the principal charge and certain charges in favour of other parties. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
| Charge | Creato il 01 ago 1984 Consegnato il 16 ago 1984 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Brevi particolari All the rights interest and property present or future of the company (whether at law or in equity) in all shares stock and other securities of any class or description which are from time to time included in and evidenced by any current collateral certificate or supplemental collateral certificate issued pursuant to any operating agreement in writing for further details see doc M6. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
APPOLD PROPERTY MANAGEMENT LIMITED ha procedimenti di insolvenza?
| Numero di pratica | Date | Tipo | Professionisti | Altro | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
| Liquidazione volontaria dei soci |
|
Fonte dati
- Companies House del Regno Unito
Il registro ufficiale delle imprese nel Regno Unito, che fornisce l'accesso pubblico alle informazioni sulle imprese, come nomi, indirizzi, amministratori e depositi finanziari. - Licenza: CC0