APPOLD PROPERTY MANAGEMENT LIMITED

APPOLD PROPERTY MANAGEMENT LIMITED

  • Panoramica
  • Riepilogo
  • Scopo
  • Indirizzo
  • Denominazioni precedenti
  • Bilanci
  • Deposizioni
  • Amministratori
  • Persone con controllo significativo
  • Ipoteche
  • Insolvenza
  • Fonte dati
  • Panoramica

    Nome della societàAPPOLD PROPERTY MANAGEMENT LIMITED
    Stato della societàSciolta
    Forma giuridicaSocietà a responsabilità limitata
    Numero di società 01836659
    GiurisdizioneInghilterra/Galles
    Data di costituzione
    Data di cessazione

    Qual è lo scopo di APPOLD PROPERTY MANAGEMENT LIMITED?

    • Intermediazione finanziaria non classificata altrove (64999) / Attività finanziarie e assicurative

    Dove si trova APPOLD PROPERTY MANAGEMENT LIMITED?

    Indirizzo della sede legale
    30 Finsbury Square
    EC2P 2YU London
    Indirizzo della sede legale non recapitabileNo

    Quali erano i nomi precedenti di APPOLD PROPERTY MANAGEMENT LIMITED?

    Denominazioni sociali precedenti
    Nome della societàDaA
    SHAMROCK LEASING LIMITED29 dic 199729 dic 1997
    APPOLD LEASING LIMITED09 gen 199509 gen 1995
    APPOLD SECURITIES LIMITED06 apr 199206 apr 1992
    HOARE GOVETT SECURITIES LIMITED 13 ott 198613 ott 1986
    HOARE GOVETT MARKET MAKERS LIMITED22 lug 198622 lug 1986
    CHARLES T. PULLEY LIMITED27 lug 198427 lug 1984

    Quali sono gli ultimi bilanci di APPOLD PROPERTY MANAGEMENT LIMITED?

    Ultimi bilanci
    Ultimi bilanci redatti al31 dic 2015

    Quali sono le ultime deposizioni per APPOLD PROPERTY MANAGEMENT LIMITED?

    Deposizioni
    DataDescrizioneDocumentoTipo

    Gazzetta ufficiale finale sciolta a seguito di liquidazione

    1 pagineGAZ2

    Ritorno della riunione finale in una liquidazione volontaria dei membri

    8 pagineLIQ13

    Indirizzo della sede legale modificato da 2 King Edward Street London EC1A 1HQ a 30 Finsbury Square London EC2P 2YU in data 30 mag 2017

    2 pagineAD01

    Nomina di un liquidatore volontario

    1 pagine600

    Dichiarazione di solvibilità

    5 pagineLIQ01

    Risoluzioni

    Resolutions
    1 pagineRESOLUTIONS
    Risoluzioni
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    liquidation

    Risoluzione speciale per la liquidazione al 03 mag 2017

    LRESSP

    Dichiarazione di conformità presentata il 15 mar 2017 con aggiornamenti

    5 pagineCS01

    Soddisfazione dell'onere 10 in pieno

    4 pagineMR04

    Soddisfazione dell'onere 11 in pieno

    6 pagineMR04

    Nomina di Jonathan Howard Redvers Lee come amministratore in data 26 ott 2016

    2 pagineAP01

    Cessazione della carica di Richard Ian Jones come amministratore in data 19 ott 2016

    1 pagineTM01

    Conto per una società dormiente redatto al 31 dic 2015

    270 pagineAA

    Bilancio annuale redatto al 02 apr 2016 con elenco completo degli azionisti

    5 pagineAR01
    Deposizioni associate
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    capital06 apr 2016

    Stato del capitale al 06 apr 2016

    • Capitale: GBP 1
    SH01

    Bilancio consolidato redatto al 31 dic 2014

    21 pagineAA

    Nomina di Philip John Wood come amministratore in data 09 giu 2015

    2 pagineAP01

    Cessazione della carica di Jacob Dutry Van Haeften come amministratore in data 07 mag 2015

    1 pagineTM01

    Bilancio annuale redatto al 02 apr 2015 con elenco completo degli azionisti

    5 pagineAR01
    Deposizioni associate
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    capital29 apr 2015

    Stato del capitale al 29 apr 2015

    • Capitale: GBP 1
    SH01

    Dettagli del direttore cambiati per Jacob Dutry Van Haeften il 28 feb 2014

    2 pagineCH01

    legacy

    1 pagineSH20

    Stato del capitale al 16 ott 2014

    • Capitale: GBP 1
    4 pagineSH19

    legacy

    1 pagineCAP-SS

    Risoluzioni

    Resolutions
    RESOLUTIONS
    Risoluzioni
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    capital

    Risoluzione di riduzione del capitale sociale emesso

    RES06
    capital

    Risoluzioni

    Share premium account reduced to zero 15/10/2014
    RES13

    Bilancio consolidato redatto al 31 dic 2013

    20 pagineAA

    Cessazione della carica di Kerry Eamonn O'connell come amministratore in data 04 ago 2014

    1 pagineTM01

    Bilancio annuale redatto al 02 apr 2014 con elenco completo degli azionisti

    6 pagineAR01
    Deposizioni associate
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    capital15 apr 2014

    Stato del capitale al 15 apr 2014

    • Capitale: GBP 73,575,500
    SH01

    Chi sono gli amministratori di APPOLD PROPERTY MANAGEMENT LIMITED?

    Amministratori
    NomeNominato ilDimissioni ilRuoloIndirizzoIdentificazione della societàPaese di residenzaNazionalitàData di nascitaProfessioneNumero
    MERRILL LYNCH CORPORATE SERVICES LIMITED
    King Edward Street
    EC1A 1HQ London
    2
    United Kingdom
    Segretario
    King Edward Street
    EC1A 1HQ London
    2
    United Kingdom
    Tipo di documento di identificazioneSEE
    Numero di registrazione4929251
    93977210001
    LEE, Jonathan Howard Redvers
    King Edward Street
    EC1A 1HQ London
    2
    United Kingdom
    Amministratore
    King Edward Street
    EC1A 1HQ London
    2
    United Kingdom
    EnglandBritish156416990001
    WOOD, Philip John
    King Edward Street
    EC1A 1HQ London
    2
    United Kingdom
    Amministratore
    King Edward Street
    EC1A 1HQ London
    2
    United Kingdom
    United KingdomBritish173550830001
    CHURCH, Fiona
    King Edward Street
    EC1A 1HQ London
    2
    United Kingdom
    Segretario
    King Edward Street
    EC1A 1HQ London
    2
    United Kingdom
    British116911130001
    CLOWES, Stephen Bernard
    Hartsridge
    Harts Lane, South Godstone
    RH9 8LZ Godstone
    Surrey
    Segretario
    Hartsridge
    Harts Lane, South Godstone
    RH9 8LZ Godstone
    Surrey
    British40195710004
    LI, Helene Yuk Hing
    King Edward Street
    EC1A 1HQ London
    2
    Segretario
    King Edward Street
    EC1A 1HQ London
    2
    British147657130001
    STEVENS, Robert Brian
    139 Rusthall Avenue
    Chiswick
    W4 1BL London
    Segretario
    139 Rusthall Avenue
    Chiswick
    W4 1BL London
    British28371200001
    STEVINSON, Jenny
    95 Stradella Road
    SE24 9HL London
    Segretario
    95 Stradella Road
    SE24 9HL London
    British16404200002
    TILGNER, Tracy K
    Flat 8
    55 Queensgate
    SW7 5JW London
    Segretario
    Flat 8
    55 Queensgate
    SW7 5JW London
    American36015120001
    ARNUM, Dennis
    Fairacres
    1 Downs Way
    KT20 5DH Tadworth
    Surrey
    Amministratore
    Fairacres
    1 Downs Way
    KT20 5DH Tadworth
    Surrey
    British37241020001
    CLEGG, Simon John
    Hill Cottage
    Reading Road Heckfield
    RG27 0JY Hook
    Hampshire
    Amministratore
    Hill Cottage
    Reading Road Heckfield
    RG27 0JY Hook
    Hampshire
    British61950010001
    CLOWES, Stephen Bernard
    Hartsridge
    Harts Lane, South Godstone
    RH9 8LZ Godstone
    Surrey
    Amministratore
    Hartsridge
    Harts Lane, South Godstone
    RH9 8LZ Godstone
    Surrey
    United KingdomBritish40195710004
    DEYONG, Jacqueline Susan
    Hayes Cottage 192 Old Woking Road
    GU22 8HR Woking
    Surrey
    Amministratore
    Hayes Cottage 192 Old Woking Road
    GU22 8HR Woking
    Surrey
    EnglandBritish25974390001
    DUTRY VAN HAEFTEN, Jacob
    King Edward Street
    EC1A 1HQ London
    2
    England
    Amministratore
    King Edward Street
    EC1A 1HQ London
    2
    England
    United KingdomDutch172432560002
    DUTTON, Godfrey Thomas
    58 Willingale Way
    SS1 3SN Thorpe Bay
    Essex
    Amministratore
    58 Willingale Way
    SS1 3SN Thorpe Bay
    Essex
    United KingdomBritish42461110001
    HOFFMAN, Mark Thomas
    King Edward Street
    EC1A 1HQ London
    2
    United Kingdom
    Amministratore
    King Edward Street
    EC1A 1HQ London
    2
    United Kingdom
    United KingdomAmerican87065070002
    HOUSTON, Geoffrey Alan
    Ashley House Chiltern Road
    Chesham Bois
    HP6 5PG Amersham
    Buckinghamshire
    Amministratore
    Ashley House Chiltern Road
    Chesham Bois
    HP6 5PG Amersham
    Buckinghamshire
    British62886570001
    JONES, Richard Ian
    King Edward Street
    EC1A 1HQ London
    2
    Amministratore
    King Edward Street
    EC1A 1HQ London
    2
    United KingdomBritish159225600001
    MAZZOLA, Stefano Antonio
    23 Westmoreland Terrace
    SW1V 4AG London
    Amministratore
    23 Westmoreland Terrace
    SW1V 4AG London
    United KingdomBritish8890420001
    O'CONNELL, Kerry Eamonn
    King Edward Street
    EC1A 1HQ London
    2
    Amministratore
    King Edward Street
    EC1A 1HQ London
    2
    United KingdomBritish69128130002
    PITHIA, Kantilal Girdharlal
    Canada Square
    E14 5AQ London
    5
    Amministratore
    Canada Square
    E14 5AQ London
    5
    British68481610001
    SHEALY, Thomas Theodore
    1 Alie Street
    E1 8DE London
    Amministratore
    1 Alie Street
    E1 8DE London
    American88998990001
    SMITH, Mark Simon Martin
    5 Canada Square
    E14 5AQ London
    Amministratore
    5 Canada Square
    E14 5AQ London
    British121952750001
    STEVENS, Robert Brian
    139 Rusthall Avenue
    Chiswick
    W4 1BL London
    Amministratore
    139 Rusthall Avenue
    Chiswick
    W4 1BL London
    British28371200001
    TETZLAFF, John Stefan Ashby
    5 Canada Square
    E14 5AQ London
    Amministratore
    5 Canada Square
    E14 5AQ London
    British116726040001
    THOMSON, David Fraser
    King Edward Street
    EC1A 1HQ London
    2
    United Kingdom
    Amministratore
    King Edward Street
    EC1A 1HQ London
    2
    United Kingdom
    United KingdomBritish74549300002
    TILGNER, Tracy K
    Flat 8
    55 Queensgate
    SW7 5JW London
    Amministratore
    Flat 8
    55 Queensgate
    SW7 5JW London
    American36015120001
    WESTBROOK, Robert William
    King Edward Street
    EC1A 1HQ London
    2
    Amministratore
    King Edward Street
    EC1A 1HQ London
    2
    United KingdomBritish169811350001
    WHITAKER, Robert Anthony Mattievich
    38 Florin Court
    6/9 Charterhouse Square
    EC1M 6EY London
    Amministratore
    38 Florin Court
    6/9 Charterhouse Square
    EC1M 6EY London
    British66770990001
    WITHAM, Geoffrey Alan
    215 Hanging Hill Lane
    Hutton
    CM13 2QG Brentwood
    Essex
    Amministratore
    215 Hanging Hill Lane
    Hutton
    CM13 2QG Brentwood
    Essex
    British7752430001

    Chi sono le persone con controllo significativo di APPOLD PROPERTY MANAGEMENT LIMITED?

    Persone con controllo significativo
    NomeNotificato ilIndirizzoCessato
    Bank Of America Corporation
    1209 Orange Street
    Wilmington
    The Corporation Trust Center
    De 19801
    Usa
    06 apr 2016
    1209 Orange Street
    Wilmington
    The Corporation Trust Center
    De 19801
    Usa
    No
    Forma giuridicaCorporation
    Paese di registrazioneUnited States Of America / Delaware
    Autorità legaleDelaware General Corporation Law
    Luogo di registrazioneDelaware Secretary Of State
    Numero di registrazioneNot Applicable
    Natura del controllo
    • La persona possiede, direttamente o indirettamente, più del 75% delle azioni della società.
    • La persona detiene, direttamente o indirettamente, più del 75% dei diritti di voto nella società.
    • La persona ha il diritto, direttamente o indirettamente, di nominare o rimuovere la maggioranza del consiglio di amministrazione della società.

    APPOLD PROPERTY MANAGEMENT LIMITED ha ipoteche?

    Ipoteche
    ClassificazioneDateStatoDettagli
    Deed of charge
    Creato il 28 feb 1991
    Consegnato il 01 mar 1991
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Fixed charge over all sums floating charge over stock and other securities (see form 395 for full details).
    Persone aventi diritto
    • Lloyds Bank PLC
    Transazioni
    • 01 mar 1991Registrazione di un'ipoteca
    • 09 mag 1992Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Deed
    Creato il 22 giu 1990
    Consegnato il 28 giu 1990
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the charge
    Brevi particolari
    Fixed charge over all sums from time to time deposited by the company or for the company's accounts with and held by the mortgagees (see form 395 for full details.
    Persone aventi diritto
    • Morgan Guaranty Trust Company of New York
    Transazioni
    • 28 giu 1990Registrazione di un'ipoteca
    • 07 mag 1992Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Collateral agreement
    Creato il 24 feb 1989
    Consegnato il 01 mar 1989
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    All "collateral" including in particular cash and securities clearance accounts opened in connection with the euro-clear system by the brussels office of morgan guaranty on its books in the name of the company (see form 395 for full details).
    Persone aventi diritto
    • Morgan Guaranty Trust Company of New York
    Transazioni
    • 01 mar 1989Registrazione di un'ipoteca
    • 31 gen 2017Soddisfazione di un'ipoteca (MR04)
    Letter agreement
    Creato il 28 lug 1987
    Consegnato il 12 ago 1987
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the charge
    Brevi particolari
    See form 395 for full details.
    Persone aventi diritto
    • Citibank N.A.
    Transazioni
    • 12 ago 1987Registrazione di un'ipoteca
    • 31 gen 2017Soddisfazione di un'ipoteca (MR04)
    Security agreement
    Creato il 21 lug 1987
    Consegnato il 28 lug 1987
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee
    Brevi particolari
    All adrs which were at the date of the security agreement in possession of the chargee and held for the account of the company (see form 395 for full details).
    Persone aventi diritto
    • Morgan Guaranty Trust Company of New York
    Transazioni
    • 28 lug 1987Registrazione di un'ipoteca
    • 07 mag 1992Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Deed
    Creato il 21 lug 1987
    Consegnato il 28 lug 1987
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee
    Brevi particolari
    First fixed charge over all sums from time to time deposited by the company or for the company's account with & held by morgan guaranty trust company in the account (s) in the name of the company denominated "adr pre-release collateral account(s) together with the debts arising therefrom or in respect thereof.
    Persone aventi diritto
    • Morgan Guaranty Trust Company of New York
    Transazioni
    • 28 lug 1987Registrazione di un'ipoteca
    • 07 mag 1992Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Charge
    Creato il 23 ott 1986
    Consegnato il 04 nov 1986
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    All the company's rights interest & property present and future in all securities transferred to national westminster bank PLC or its nominees by the stock exchange pursuant to any short term certificate issued to the bank in accordance with the provisions of any written agreement relating to non-endorseable short term certificates for the time being in face between the stock exchange, the company & the bank (for details see form 395).
    Persone aventi diritto
    • National Westminster Bank PLC
    Transazioni
    • 04 nov 1986Registrazione di un'ipoteca
    • 09 mag 1992Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Charge in compliance with the rules and regulations (including council notices) of the stock exchange
    Creato il 23 ott 1986
    Consegnato il 03 nov 1986
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee
    Brevi particolari
    All shares stock & other securities of any description which are for the time being designated by the stock exchange as talisman securities (see form 395 dated for 3/11/86 for full details).
    Persone aventi diritto
    • The Stock Exchange of the United Kingdom and the Republic of Ireland
    Transazioni
    • 03 nov 1986Registrazione di un'ipoteca
    • 07 mag 1992Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Legal charge
    Creato il 07 nov 1985
    Consegnato il 25 nov 1985
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    All the rights interest and property present or future of the company (whether at law or in equity) in all securities transferred to the company or its nominees of the stock exchange present to any short term certificate issued to national westminster bank PLC. See doc M10 for full details.
    Persone aventi diritto
    • National Westminster Bank PLC
    Transazioni
    • 25 nov 1985Registrazione di un'ipoteca
    • 09 mag 1992Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Charge
    Creato il 08 ago 1985
    Consegnato il 19 ago 1985
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the charge
    Brevi particolari
    All shares stock and other securities of any description which are for the time being designated by the stock exchange as talisman securities (see doc M9 for details).
    Persone aventi diritto
    • The Stock Exchange
    Transazioni
    • 19 ago 1985Registrazione di un'ipoteca
    • 07 mag 1992Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Charge
    Creato il 01 ago 1984
    Consegnato il 17 ago 1984
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    The securities therein defined together with all benefits arising therefrom and not transferred by the stock exchange to the company for details see doc M8.
    Persone aventi diritto
    • The Stock Exchange
    Transazioni
    • 17 ago 1984Registrazione di un'ipoteca
    • 07 mag 1992Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Deed of variation
    Creato il 01 ago 1984
    Consegnato il 17 ago 1984
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    For varying the terms of the principal charge of even date
    Brevi particolari
    The deed varis the definition of the securities which are subject to the principal charge and also affects the ranking of the principal charge and certain charges in favour of other parties.
    Persone aventi diritto
    • The Stock Exchange
    Transazioni
    • 17 ago 1984Registrazione di un'ipoteca
    • 07 mag 1992Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Charge
    Creato il 01 ago 1984
    Consegnato il 16 ago 1984
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    All the rights interest and property present or future of the company (whether at law or in equity) in all shares stock and other securities of any class or description which are from time to time included in and evidenced by any current collateral certificate or supplemental collateral certificate issued pursuant to any operating agreement in writing for further details see doc M6.
    Persone aventi diritto
    • National Westminster Bank PLC
    Transazioni
    • 16 ago 1984Registrazione di un'ipoteca
    • 09 mag 1992Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)

    APPOLD PROPERTY MANAGEMENT LIMITED ha procedimenti di insolvenza?

    Numero di praticaDateTipoProfessionistiAltro
    1
    DataTipo
    03 mag 2017Inizio della liquidazione
    07 feb 2018Data di scioglimento
    Liquidazione volontaria dei soci
    NomeRuoloIndirizzoNominato ilCessato il
    Sean Kenneth Croston
    Grant Thornton Uk Llp
    30 Finsbury Square
    EC2P 2YU London
    Praticante
    Grant Thornton Uk Llp
    30 Finsbury Square
    EC2P 2YU London

    Fonte dati

    • Companies House del Regno Unito
      Il registro ufficiale delle imprese nel Regno Unito, che fornisce l'accesso pubblico alle informazioni sulle imprese, come nomi, indirizzi, amministratori e depositi finanziari.
    • Licenza: CC0