HW1 LIMITED

  • Panoramica
  • Riepilogo
  • Scopo
  • Indirizzo
  • Denominazioni precedenti
  • Bilanci
  • Deposizioni
  • Amministratori
  • Ipoteche
  • Fonte dati
  • Panoramica

    Nome della societàHW1 LIMITED
    Stato della societàSciolta
    Forma giuridicaSocietà a responsabilità limitata
    Numero di società 01837286
    GiurisdizioneInghilterra/Galles
    Data di costituzione
    Data di cessazione

    Qual è lo scopo di HW1 LIMITED?

    • (7499) /

    Dove si trova HW1 LIMITED?

    Indirizzo della sede legale
    Chancery House
    53-64 Chancery Lane
    WC2A 1QS London
    Indirizzo della sede legale non recapitabileNo

    Quali erano i nomi precedenti di HW1 LIMITED?

    Denominazioni sociali precedenti
    Nome della societàDaA
    HW HARRISON WILLIS LIMITED11 mag 199811 mag 1998
    HARRISON WILLIS LIMITED08 gen 199308 gen 1993
    HARRISON & WILLIS (COMMERCIAL & INDUSTRIAL APPOINTMENTS DIVISION) LIMITED11 mar 198511 mar 1985
    TOP 10 APPOINTMENTS SERVICE LIMITED31 lug 198431 lug 1984

    Quali sono gli ultimi bilanci di HW1 LIMITED?

    Ultimi bilanci
    Ultimi bilanci redatti al31 mar 2010

    Quali sono le ultime deposizioni per HW1 LIMITED?

    Deposizioni
    DataDescrizioneDocumentoTipo

    Gazzetta Ufficiale finale sciolta per scioglimento volontario

    1 pagineGAZ2(A)

    Prima Gazzetta Ufficiale per lo scioglimento volontario

    1 pagineGAZ1(A)

    Richiesta di cancellazione della società dal registro

    3 pagineDS01

    Bilancio annuale redatto al 30 giu 2010 con elenco completo degli azionisti

    4 pagineAR01
    Deposizioni associate
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    capital20 ago 2010

    Stato del capitale al 20 ago 2010

    • Capitale: GBP 100
    SH01

    Cessazione della carica di Caroline Marshall come segretario

    2 pagineTM02

    Nomina di Martin James Piers come segretario

    3 pagineAP03

    Conto per una società dormiente redatto al 31 mar 2010

    6 pagineAA

    I registri sono stati trasferiti al luogo di ispezione registrato

    1 pagineAD03

    L'indirizzo di ispezione del registro è stato modificato

    1 pagineAD02

    Dettagli del direttore cambiati per Aileen Brown il 28 ott 2009

    2 pagineCH01

    Dettagli del segretario cambiati per Caroline Louise Marshall il 28 ott 2009

    1 pagineCH03

    legacy

    3 pagine363a

    legacy

    1 pagine288c

    Bilancio redatto al 31 mar 2009

    6 pagineAA

    Bilancio redatto al 31 mar 2008

    5 pagineAA

    legacy

    1 pagine288b

    legacy

    2 pagine288a

    legacy

    3 pagine363a

    Certificato di cambio di nome

    Company name changed hw harrison willis LIMITED\certificate issued on 23/06/08
    2 pagineCERTNM

    legacy

    2 pagine363a

    Bilancio redatto al 31 mar 2007

    5 pagineAA

    Bilancio redatto al 31 mar 2006

    5 pagineAA

    legacy

    2 pagine288a

    legacy

    1 pagine288b

    legacy

    2 pagine363a

    Chi sono gli amministratori di HW1 LIMITED?

    Amministratori
    NomeNominato ilDimissioni ilRuoloIndirizzoIdentificazione della societàPaese di residenzaNazionalitàData di nascitaProfessioneNumero
    PIERS, Martin James
    Chancery House
    53-64 Chancery Lane
    WC2A 1QS London
    Segretario
    Chancery House
    53-64 Chancery Lane
    WC2A 1QS London
    British151889720001
    BROWN, Aileen
    Blythswood Square
    G2 4AD Glasgow
    6-7
    United Kingdom
    Amministratore
    Blythswood Square
    G2 4AD Glasgow
    6-7
    United Kingdom
    ScotlandBritishChief Fin Officer135871560003
    DUGGAN, Bridget Martina
    51 Rossendale Way
    NW1 0XB London
    Segretario
    51 Rossendale Way
    NW1 0XB London
    Irish13373730001
    KIMBER, Robert Charles
    6 Marina View
    Willow Way
    BH23 1JJ Christchurch
    Dorset
    Segretario
    6 Marina View
    Willow Way
    BH23 1JJ Christchurch
    Dorset
    BritishChartered Accountant39744090001
    MARSHALL, Caroline Louise
    Chancery House
    53-64 Chancery Lane
    WC2A 1QS London
    Segretario
    Chancery House
    53-64 Chancery Lane
    WC2A 1QS London
    British102950490001
    SMITH, Glyn Margaret
    104 Otley Drive
    IG2 6QX Ilford
    Essex
    Segretario
    104 Otley Drive
    IG2 6QX Ilford
    Essex
    British1538300001
    SMITH, Laurence Edwin
    Bakers Farm House
    Ladham Lane
    TN17 1LS Goudhurst
    Kent
    Segretario
    Bakers Farm House
    Ladham Lane
    TN17 1LS Goudhurst
    Kent
    British1538310001
    TOOP, John Frank
    Oakhurst 11 Randiddles Close
    Hurstpierpoint
    BN6 9BG Hassocks
    West Sussex
    Segretario
    Oakhurst 11 Randiddles Close
    Hurstpierpoint
    BN6 9BG Hassocks
    West Sussex
    British46999630001
    UPWOOD, John Richard
    98 Biddulph Mansions
    Elgin Avenue
    W9 1HU London
    Segretario
    98 Biddulph Mansions
    Elgin Avenue
    W9 1HU London
    British38319000005
    BIRT-LLEWELLIN, Fiona Murray
    58 Brackenbury Road
    Hammersmith
    W6 0BD London
    Amministratore
    58 Brackenbury Road
    Hammersmith
    W6 0BD London
    BritishCompany Director13373720002
    BLAKE, Stuart John
    2 Cedar Lane
    Burghill
    HR4 7QQ Hereford
    Herefordshire
    Amministratore
    2 Cedar Lane
    Burghill
    HR4 7QQ Hereford
    Herefordshire
    BritainBritishDirector95561040001
    FLOOD, Brendan Christopher
    5a Acacia Road
    TW12 3DP Hampton
    Middlesex
    Amministratore
    5a Acacia Road
    TW12 3DP Hampton
    Middlesex
    EnglandIrishFinance Director65847200001
    GRANT, Andrew Barton
    99 Flood Street
    SW3 5TD London
    Amministratore
    99 Flood Street
    SW3 5TD London
    EnglandBritishCompany Director73457680001
    HARRIS, Sheila Kay
    2 Orchard Mains
    Hook Heath Avenue
    GU22 0ET Woking
    Surrey
    Amministratore
    2 Orchard Mains
    Hook Heath Avenue
    GU22 0ET Woking
    Surrey
    BritishRecruitment Consultant60652460001
    HAYNES, Christopher John Latimer
    Lilac Tree Cottage
    12 The Moors
    RG8 7LP Pangbourne
    Berkshire
    Amministratore
    Lilac Tree Cottage
    12 The Moors
    RG8 7LP Pangbourne
    Berkshire
    BritishFinance Director87271370001
    HERRMANNSEN, Chris
    11 Mallow Street
    EC1A 8RQ London
    Amministratore
    11 Mallow Street
    EC1A 8RQ London
    United KingdomBritishCompany Director81712600001
    LIVETT, Timothy James
    Nelson Cottage
    Oakdale
    RH5 4NR South Holmwood
    Surrey
    Amministratore
    Nelson Cottage
    Oakdale
    RH5 4NR South Holmwood
    Surrey
    EnglandBritishFinance Director277507240001
    MOFFATT, David Stewart
    Laxtons 176 Kimbolton Road
    MK41 8DW Bedford
    Bedfordshire
    Amministratore
    Laxtons 176 Kimbolton Road
    MK41 8DW Bedford
    Bedfordshire
    BritishAccountant78731200001
    PALFREY-SMITH, Graham
    Cookham Dene
    Manor Park
    BR7 5QD Chislehurst
    Kent
    Amministratore
    Cookham Dene
    Manor Park
    BR7 5QD Chislehurst
    Kent
    BritishDirector77194730001
    ROGERSON, Andrew Walter
    192 Ferry Road
    EH6 4NW Edinburgh
    Midlothian
    Amministratore
    192 Ferry Road
    EH6 4NW Edinburgh
    Midlothian
    ScotlandBritishCompany Director119618310001
    ROSE, John Ian
    7 Willow Dene
    WD23 1PS Bushey Heath
    Hertfordshire
    Amministratore
    7 Willow Dene
    WD23 1PS Bushey Heath
    Hertfordshire
    BritishChief Executive Officer96949660001
    ROSE, John
    156a Pinner Road
    WD1 4EW Watford
    Hertfordshire
    Amministratore
    156a Pinner Road
    WD1 4EW Watford
    Hertfordshire
    BritishDirector64485810001
    SMITH, Laurence Edwin
    Bakers Farm House
    Ladham Lane
    TN17 1LS Goudhurst
    Kent
    Amministratore
    Bakers Farm House
    Ladham Lane
    TN17 1LS Goudhurst
    Kent
    BritishManaging Director1538310001
    WALTERS, Leslie Gary
    Flat 9 2 Antrim Grove
    Belize Park
    NW3 4XR London
    Amministratore
    Flat 9 2 Antrim Grove
    Belize Park
    NW3 4XR London
    BritishRecruitment Consultant50218170001

    HW1 LIMITED ha ipoteche?

    Ipoteche
    ClassificazioneDateStatoDettagli
    Mortgage debenture
    Creato il 06 mar 1997
    Consegnato il 19 mar 1997
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    A specific equitable charge over all freehold and leasehold properties and/or the proceeds of sale thereof fixed and floating charges over undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts and the benefits of any licences.
    Persone aventi diritto
    • National Westminster Bank PLC
    Transazioni
    • 19 mar 1997Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 31 mar 2003Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Debenture
    Creato il 06 mar 1997
    Consegnato il 14 mar 1997
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the debenture and a deed of guarantee and indemnity of even date
    Brevi particolari
    .. fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • 3I PLC(Or Such Other Person as May from Time to Time Be the Security Trustee for the Purposes of the Charge) for Itself and as Trustee for the Investors
    Transazioni
    • 14 mar 1997Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 16 ott 1998Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Single debenture
    Creato il 19 lug 1996
    Consegnato il 25 lug 1996
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    .. fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Lloyds Bank PLC
    Transazioni
    • 25 lug 1996Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 17 giu 1997Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)

    Fonte dati

    • Companies House del Regno Unito
      Il registro ufficiale delle imprese nel Regno Unito, che fornisce l'accesso pubblico alle informazioni sulle imprese, come nomi, indirizzi, amministratori e depositi finanziari.
    • Licenza: CC0