WHITEGATE TAVERNS LIMITED

WHITEGATE TAVERNS LIMITED

  • Panoramica
  • Riepilogo
  • Scopo
  • Indirizzo
  • Denominazioni precedenti
  • Bilanci
  • Deposizioni
  • Amministratori
  • Dichiarazioni delle persone con controllo significativo
  • Ipoteche
  • Insolvenza
  • Fonte dati
  • Panoramica

    Nome della societàWHITEGATE TAVERNS LIMITED
    Stato della societàSciolta
    Forma giuridicaSocietà a responsabilità limitata
    Numero di società 01838261
    GiurisdizioneInghilterra/Galles
    Data di costituzione
    Data di cessazione

    Qual è lo scopo di WHITEGATE TAVERNS LIMITED?

    • Società non commerciali (74990) / Attività professionali, scientifiche e tecniche

    Dove si trova WHITEGATE TAVERNS LIMITED?

    Indirizzo della sede legale
    Resolve Advisory Limited
    22 York Buildings
    WC2N 6JU London
    Indirizzo della sede legale non recapitabileNo

    Quali erano i nomi precedenti di WHITEGATE TAVERNS LIMITED?

    Denominazioni sociali precedenti
    Nome della societàDaA
    SHANHEATH LIMITED03 ago 198403 ago 1984

    Quali sono gli ultimi bilanci di WHITEGATE TAVERNS LIMITED?

    Ultimi bilanci
    Ultimi bilanci redatti al29 apr 2018

    Quali sono le ultime deposizioni per WHITEGATE TAVERNS LIMITED?

    Deposizioni
    DataDescrizioneDocumentoTipo

    Gazzetta ufficiale finale sciolta a seguito di liquidazione

    1 pagineGAZ2

    Ritorno della riunione finale in una liquidazione volontaria dei membri

    11 pagineLIQ13

    Dichiarazione dei ricevimenti e dei pagamenti dei liquidatori fino a 15 gen 2021

    10 pagineLIQ03

    Dichiarazione di conformità presentata il 01 mar 2020 con aggiornamenti

    5 pagineCS01

    Dichiarazione di solvibilità

    5 pagineLIQ01

    Indirizzo della sede legale modificato da Westgate Brewery Bury St Edmunds Suffolk IP33 1QT United Kingdom a Resolve Advisory Limited 22 York Buildings London WC2N 6JU in data 30 gen 2020

    2 pagineAD01

    Nomina di un liquidatore volontario

    3 pagine600

    Risoluzioni

    Resolutions
    2 pagineRESOLUTIONS
    Risoluzioni
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    liquidation

    Risoluzione speciale per la liquidazione al 16 gen 2020

    LRESSP

    Stato del capitale al 30 dic 2019

    • Capitale: GBP 1
    3 pagineSH19

    legacy

    1 pagineSH20

    legacy

    1 pagineCAP-SS

    Risoluzioni

    Resolutions
    1 pagineRESOLUTIONS
    Risoluzioni
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    capital

    Risoluzione di riduzione del capitale sociale emesso

    RES06

    Dichiarazione di conformità presentata il 01 mar 2019 con aggiornamenti

    4 pagineCS01

    Conto per una società dormiente redatto al 29 apr 2018

    10 pagineAA

    Dichiarazione di conformità presentata il 01 mar 2018 con aggiornamenti

    4 pagineCS01

    Cessazione della carica di Kirk Dyson Davis come amministratore in data 31 gen 2018

    1 pagineTM01

    Nomina di Mr Richard Smothers come amministratore in data 31 gen 2018

    2 pagineAP01

    Conto per una società dormiente redatto al 30 apr 2017

    10 pagineAA

    Dichiarazione di conformità presentata il 01 mar 2017 con aggiornamenti

    5 pagineCS01

    Conto per una società dormiente redatto al 01 mag 2016

    11 pagineAA

    Nomina di Lindsay Anne Keswick come segretario in data 25 apr 2016

    2 pagineAP03

    Cessazione della carica di Claire Susan Stewart come segretario in data 25 apr 2016

    1 pagineTM02

    Indirizzo della sede legale modificato da Sunrise House Ninth Avenue Burton upon Trent Staffordshire DE14 3JZ a Westgate Brewery Bury St Edmunds Suffolk IP33 1QT in data 07 mar 2016

    1 pagineAD01

    Bilancio annuale redatto al 01 mar 2016 con elenco completo degli azionisti

    3 pagineAR01
    Deposizioni associate
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    capital01 mar 2016

    Stato del capitale al 01 mar 2016

    • Capitale: GBP 3,000
    SH01

    Conto per una società dormiente redatto al 22 ago 2015

    3 pagineAA

    Chi sono gli amministratori di WHITEGATE TAVERNS LIMITED?

    Amministratori
    NomeNominato ilDimissioni ilRuoloIndirizzoIdentificazione della societàPaese di residenzaNazionalitàData di nascitaProfessioneNumero
    KESWICK, Lindsay Anne
    22 York Buildings
    WC2N 6JU London
    Resolve Advisory Limited
    Segretario
    22 York Buildings
    WC2N 6JU London
    Resolve Advisory Limited
    207523810001
    SMOTHERS, Richard
    IP33 1QT Bury St Edmunds
    Westgate Brewery
    Suffolk
    United Kingdom
    Amministratore
    IP33 1QT Bury St Edmunds
    Westgate Brewery
    Suffolk
    United Kingdom
    United KingdomBritish242658700001
    CUTHBERTSON, Colin
    5 Hill Gardens
    LE16 9EB Market Harborough
    Leicestershire
    Segretario
    5 Hill Gardens
    LE16 9EB Market Harborough
    Leicestershire
    British26369940001
    HOMER, Neville Rex
    Caberfeidh 12 Forth Street
    EH39 4HY North Berwick
    East Lothian
    Segretario
    Caberfeidh 12 Forth Street
    EH39 4HY North Berwick
    East Lothian
    British895960001
    JONES, Henry
    Ninth Avenue
    DE14 3JZ Burton Upon Trent
    Sunrise House
    Staffordshire
    United Kingdom
    Segretario
    Ninth Avenue
    DE14 3JZ Burton Upon Trent
    Sunrise House
    Staffordshire
    United Kingdom
    180592810001
    KENDALL, Timothy James
    31 Canterbury Close
    Erdington
    B23 7QL Birmingham
    West Midlands
    Segretario
    31 Canterbury Close
    Erdington
    B23 7QL Birmingham
    West Midlands
    British117397470002
    RUDD, Susan Clare
    Ninth Avenue
    DE14 3JZ Burton Upon Trent
    Sunrise House
    Staffordshire
    United Kingdom
    Segretario
    Ninth Avenue
    DE14 3JZ Burton Upon Trent
    Sunrise House
    Staffordshire
    United Kingdom
    172445020001
    RUDD, Susan Clare
    17 Thacker Drive
    WS13 6NS Lichfield
    Staffordshire
    Segretario
    17 Thacker Drive
    WS13 6NS Lichfield
    Staffordshire
    British81789210004
    STEVENS, Mark
    5 Lyon Drive
    Murieston
    EH54 9HF Livingston
    West Lothian
    Segretario
    5 Lyon Drive
    Murieston
    EH54 9HF Livingston
    West Lothian
    British80951870001
    STEWART, Claire Susan
    Ninth Avenue
    DE14 3JZ Burton Upon Trent
    Sunrise House
    Staffordshire
    United Kingdom
    Segretario
    Ninth Avenue
    DE14 3JZ Burton Upon Trent
    Sunrise House
    Staffordshire
    United Kingdom
    181021410001
    STEWART, Claire Susan
    Ninth Avenue
    DE14 3JZ Burton Upon Trent
    Sunrise House
    Staffordshire
    United Kingdom
    Segretario
    Ninth Avenue
    DE14 3JZ Burton Upon Trent
    Sunrise House
    Staffordshire
    United Kingdom
    Other130369890001
    WALMSLEY, Derek Kerr
    High Street
    Pavenham
    MK43 7NJ Bedford
    Walnut Barn
    Bedfordshire
    Segretario
    High Street
    Pavenham
    MK43 7NJ Bedford
    Walnut Barn
    Bedfordshire
    British135181230001
    BASHFORTH, Edward Michael
    Second Avenue
    DE14 2WF Burton Upon Trent
    Jubilee House
    Staffordshire
    United Kingdom
    Amministratore
    Second Avenue
    DE14 2WF Burton Upon Trent
    Jubilee House
    Staffordshire
    United Kingdom
    United KingdomBritish131551840002
    BELL, Lucy Jane
    Ninth Avenue
    DE14 3JZ Burton Upon Trent
    Sunrise House
    Staffordshire
    United Kingdom
    Amministratore
    Ninth Avenue
    DE14 3JZ Burton Upon Trent
    Sunrise House
    Staffordshire
    United Kingdom
    United KingdomBritish164754670001
    BUBB, Stewart Edmund Conyers
    Clare Cottage
    42 Lammas Lane
    KT10 8PD Esher
    Surrey
    Amministratore
    Clare Cottage
    42 Lammas Lane
    KT10 8PD Esher
    Surrey
    British36779040001
    CUMMING, Johanna Louise
    18 Prospect Quay
    98 Point Pleasant
    SW18 1PR London
    Amministratore
    18 Prospect Quay
    98 Point Pleasant
    SW18 1PR London
    United KingdomBritish111108910001
    CUTHBERTSON, Colin
    5 Hill Gardens
    LE16 9EB Market Harborough
    Leicestershire
    Amministratore
    5 Hill Gardens
    LE16 9EB Market Harborough
    Leicestershire
    EnglandBritish26369940001
    DANDO, Stephen Peter
    Second Avenue
    DE14 2WF Burton Upon Trent
    Jubilee House
    Staffordshire
    United Kingdom
    Amministratore
    Second Avenue
    DE14 2WF Burton Upon Trent
    Jubilee House
    Staffordshire
    United Kingdom
    United KingdomBritish152083750001
    DAVIS, Kirk Dyson
    Ninth Avenue
    DE14 3JZ Burton Upon Trent
    Sunrise House
    Staffordshire
    United Kingdom
    Amministratore
    Ninth Avenue
    DE14 3JZ Burton Upon Trent
    Sunrise House
    Staffordshire
    United Kingdom
    United KingdomBritish158484730001
    DUTTON, Philip
    Second Avenue
    DE14 2WF Burton Upon Trent
    Jubilee House
    Staffordshire
    United Kingdom
    Amministratore
    Second Avenue
    DE14 2WF Burton Upon Trent
    Jubilee House
    Staffordshire
    United Kingdom
    United KingdomBritish141395280001
    GALLAGHER, Patrick James
    Ninth Avenue
    DE14 3JZ Burton Upon Trent
    Sunrise House
    Staffordshire
    United Kingdom
    Amministratore
    Ninth Avenue
    DE14 3JZ Burton Upon Trent
    Sunrise House
    Staffordshire
    United Kingdom
    EnglandBritish205366190001
    GODWIN-BRATT, Robert James
    Ninth Avenue
    DE14 3JZ Burton Upon Trent
    Sunrise House
    Staffordshire
    United Kingdom
    Amministratore
    Ninth Avenue
    DE14 3JZ Burton Upon Trent
    Sunrise House
    Staffordshire
    United Kingdom
    United KingdomBritish170184800001
    HOMER, Neville Rex
    Caberfeidh 12 Forth Street
    EH39 4HY North Berwick
    East Lothian
    Amministratore
    Caberfeidh 12 Forth Street
    EH39 4HY North Berwick
    East Lothian
    British895960001
    HOMER, Neville Rex
    Caberfeidh 12 Forth Street
    EH39 4HY North Berwick
    East Lothian
    Amministratore
    Caberfeidh 12 Forth Street
    EH39 4HY North Berwick
    East Lothian
    British895960001
    JACOBS, David Michael
    Riverside House
    Hall Cottages Lodden Drive
    RG10 8ND Reading
    Berkshire
    Amministratore
    Riverside House
    Hall Cottages Lodden Drive
    RG10 8ND Reading
    Berkshire
    British47141160001
    JONES, Karen Elisabeth Dind
    Paddock House
    9 Spencer Park Wandsworth
    SW18 2SX London
    Amministratore
    Paddock House
    9 Spencer Park Wandsworth
    SW18 2SX London
    United KingdomBritish47793260007
    KELLY, Daryl Antony
    Ninth Avenue
    DE14 3JZ Burton Upon Trent
    Sunrise House
    Staffordshire
    United Kingdom
    Amministratore
    Ninth Avenue
    DE14 3JZ Burton Upon Trent
    Sunrise House
    Staffordshire
    United Kingdom
    United KingdomBritish86246470001
    KELLY, Daryl Antony
    Ninth Avenue
    DE14 3JZ Burton Upon Trent
    Sunrise House
    Staffordshire
    United Kingdom
    Amministratore
    Ninth Avenue
    DE14 3JZ Burton Upon Trent
    Sunrise House
    Staffordshire
    United Kingdom
    United KingdomBritish86246470001
    KNIGHT, Andrew Ronald
    89 Main Street
    DE13 7ED Alrewas
    Staffordshire
    Amministratore
    89 Main Street
    DE13 7ED Alrewas
    Staffordshire
    British81555100002
    LANGFORD, Jonathan Robert
    Ninth Avenue
    DE14 3JZ Burton Upon Trent
    Sunrise House
    Staffordshire
    United Kingdom
    Amministratore
    Ninth Avenue
    DE14 3JZ Burton Upon Trent
    Sunrise House
    Staffordshire
    United Kingdom
    United KingdomBritish135408140001
    MARGERRISON, Russell John
    Ninth Avenue
    DE14 3JZ Burton Upon Trent
    Sunrise House
    Staffordshire
    United Kingdom
    Amministratore
    Ninth Avenue
    DE14 3JZ Burton Upon Trent
    Sunrise House
    Staffordshire
    United Kingdom
    EnglandBritish170590800001
    MCDONALD, Robert James
    46 Wentworth Drive
    WS14 9HN Lichfield
    Staffordshire
    Amministratore
    46 Wentworth Drive
    WS14 9HN Lichfield
    Staffordshire
    British42019620001
    MILLER, Louise
    13 Traquair Park West
    EH12 7AN Edinburgh
    Midlothian
    Amministratore
    13 Traquair Park West
    EH12 7AN Edinburgh
    Midlothian
    British63895470001
    PEAREY, Michael John
    The Lodge
    EH32 0RE Aberlady
    East Lothian
    Amministratore
    The Lodge
    EH32 0RE Aberlady
    East Lothian
    British46305030001
    PEAREY, Michael John
    The Lodge
    EH32 0RE Aberlady
    East Lothian
    Amministratore
    The Lodge
    EH32 0RE Aberlady
    East Lothian
    British46305030001

    Quali sono le ultime dichiarazioni delle persone con controllo significativo per WHITEGATE TAVERNS LIMITED?

    Dichiarazioni delle persone con controllo significativo
    Notificato ilCessato ilDichiarazione
    01 mar 2017La società sa o ha ragione di credere che non vi siano persone registrabili o entità giuridiche rilevanti registrabili in relazione alla società.

    WHITEGATE TAVERNS LIMITED ha ipoteche?

    Ipoteche
    ClassificazioneDateStatoDettagli
    Security agreement
    Creato il 15 dic 2003
    Consegnato il 31 dic 2003
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from each obligor to any finance party under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • The Royal Bank of Scotland PLC (The Facility Agent) as Agent and Trustee for the Financeparties
    Transazioni
    • 31 dic 2003Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 09 dic 2004Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Debenture
    Creato il 15 mar 1985
    Consegnato il 27 mar 1985
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    (Including trade fixtures). Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Persone aventi diritto
    • Lloyds Bank PLC
    Transazioni
    • 27 mar 1985Registrazione di un'ipoteca
    Legal charge
    Creato il 15 mar 1985
    Consegnato il 27 mar 1985
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    19/21 flixton road, urmston, trafford greater manchester together with trade and other fixtures, goodwill, and the benefit of all licences.
    Persone aventi diritto
    • Lloyds Bank PLC
    Transazioni
    • 27 mar 1985Registrazione di un'ipoteca
    Legal charge
    Creato il 15 mar 1985
    Consegnato il 27 mar 1985
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    The stone room 3/a in the sub-basement of the manchester royal exchange together with trade and other fixtures, goodwill and benefits of all licences.
    Persone aventi diritto
    • Lloyds Bank PLC
    Transazioni
    • 27 mar 1985Registrazione di un'ipoteca
    Legal charge
    Creato il 15 mar 1985
    Consegnato il 27 mar 1985
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    The barnaby rudge restaurant. 15 st. Ann's square, 2 old bank street, together with trade and other fixtures, goodwill, benefits of all licences.
    Persone aventi diritto
    • Lloyds Bank PLC
    Transazioni
    • 27 mar 1985Registrazione di un'ipoteca
    Legal charge
    Creato il 15 mar 1985
    Consegnato il 27 mar 1985
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Municipal buildings wellington road ashton under lyne greater manchester not known as fergusons restaurant toget her with trade and other fixtures good will and benefit of all licences.
    Persone aventi diritto
    • Lloyds Bank PLC
    Transazioni
    • 27 mar 1985Registrazione di un'ipoteca
    Legal charge
    Creato il 15 mar 1985
    Consegnato il 27 mar 1985
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    The old dukes restaurant, (formerly wellington inn drane street, and smith street, rochdale, lancashire. Together with trade and other fixtures, goodwill and benefits of all licences.
    Persone aventi diritto
    • Lloyds Bank PLC
    Transazioni
    • 27 mar 1985Registrazione di un'ipoteca
    Legal charge
    Creato il 15 mar 1985
    Consegnato il 27 mar 1985
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Ferguson's restaurant, 2A northenden road, sale. Together with trade and other fixtures, goodwill and benefits of all licences.
    Persone aventi diritto
    • Lloyds Bank PLC
    Transazioni
    • 27 mar 1985Registrazione di un'ipoteca
    Legal charge
    Creato il 15 mar 1985
    Consegnato il 27 mar 1985
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    L/H - manchester road, castleton greater manchester. K/a- the royal toby hotel. Togerher with trade and other fixtures, goodwill, and benefits of all licences.
    Persone aventi diritto
    • Lloyds Bank PLC
    Transazioni
    • 27 mar 1985Registrazione di un'ipoteca
    Legal charge
    Creato il 15 mar 1985
    Consegnato il 27 mar 1985
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Land lying to the w of manchester rd, castleton, rochdale together with trade & other fixtures goodwill and the benefits of all licences.
    Persone aventi diritto
    • Lloyds Bank PLC
    Transazioni
    • 27 mar 1985Registrazione di un'ipoteca
    Legal charge
    Creato il 15 mar 1985
    Consegnato il 27 mar 1985
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Section 24 of the industrial building situate in longwood road trafford park, manchester with trade & other fixtures, goodwill and benefits of all licences.
    Persone aventi diritto
    • Lloyds Bank PLC
    Transazioni
    • 27 mar 1985Registrazione di un'ipoteca
    Debenture
    Creato il 15 mar 1985
    Consegnato il 27 mar 1985
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    Securing £436,333.29 and all other moneys due or to become due from the company to the chargee under the terms of the charge (incl. Moneys in respect of trade payments (as defined in the charge).
    Brevi particolari
    1) charge by way of legal mortgage on - ferguson's restaurant 2A northenden road, sale, cheshire. T/no:- gm 179649 2) fixed charge on machinery plant tool equipment the goodwill of the business, all bookdebts and other debts of the company present and future. Floating charge on all the undertakings and all property and assets of the borrower present and future (not subject to fixed charges under 1 & 2 abover) the debenture prohilats the creation of any further charges or of granting any leases without the written consent of wilsons brewery LTD.
    Persone aventi diritto
    • Wilsons Brewery Limited.
    Transazioni
    • 27 mar 1985Registrazione di un'ipoteca

    WHITEGATE TAVERNS LIMITED ha procedimenti di insolvenza?

    Numero di praticaDateTipoProfessionistiAltro
    1
    DataTipo
    16 gen 2020Inizio della liquidazione
    25 apr 2022Data di scioglimento
    Liquidazione volontaria dei soci
    NomeRuoloIndirizzoNominato ilCessato il
    Simon Jagger
    22 York Buildings
    John Addam Street
    WC2N 6JU London
    Praticante
    22 York Buildings
    John Addam Street
    WC2N 6JU London
    Ben David Woodthorpe
    22 York Buildings
    WC2N 6JU London
    Praticante
    22 York Buildings
    WC2N 6JU London

    Fonte dati

    • Companies House del Regno Unito
      Il registro ufficiale delle imprese nel Regno Unito, che fornisce l'accesso pubblico alle informazioni sulle imprese, come nomi, indirizzi, amministratori e depositi finanziari.
    • Licenza: CC0