ESPRESSO LIMITED

  • Panoramica
  • Riepilogo
  • Scopo
  • Indirizzo
  • Denominazioni precedenti
  • Bilanci
  • Deposizioni
  • Amministratori
  • Persone con controllo significativo
  • Dichiarazioni delle persone con controllo significativo
  • Ipoteche
  • Fonte dati
  • Panoramica

    Nome della societàESPRESSO LIMITED
    Stato della societàSciolta
    Forma giuridicaSocietà a responsabilità limitata
    Numero di società 01845723
    GiurisdizioneInghilterra/Galles
    Data di costituzione
    Data di cessazione

    Qual è lo scopo di ESPRESSO LIMITED?

    • Ristoranti con licenza (56101) / Attività di alloggio e di ristorazione

    Dove si trova ESPRESSO LIMITED?

    Indirizzo della sede legale
    Lower Ground Floor, Elsley House
    24/30 Great Titchfield Street
    W1W 8BF London
    England
    Indirizzo della sede legale non recapitabileNo

    Quali erano i nomi precedenti di ESPRESSO LIMITED?

    Denominazioni sociali precedenti
    Nome della societàDaA
    HEATHGATE RESTAURANTS LIMITED28 ago 200228 ago 2002
    HEATHGATE RESTAURANTS PLC20 nov 198420 nov 1984
    JORDANS 197 PUBLIC LIMITED COMPANY04 set 198404 set 1984

    Quali sono gli ultimi bilanci di ESPRESSO LIMITED?

    Ultimi bilanci
    Ultimi bilanci redatti al26 mag 2019

    Quali sono le ultime deposizioni per ESPRESSO LIMITED?

    Deposizioni
    DataDescrizioneDocumentoTipo

    Gazzetta Ufficiale finale sciolta per scioglimento volontario

    1 pagineGAZ2(A)

    Cessazione della carica di James Forrester Spragg come amministratore in data 31 mar 2021

    1 pagineTM01

    L'azione di cancellazione volontaria è stata sospesa

    1 pagineSOAS(A)

    Prima Gazzetta Ufficiale per lo scioglimento volontario

    1 pagineGAZ1(A)

    Richiesta di cancellazione della società dal registro

    1 pagineDS01

    Indirizzo della sede legale modificato da 1st Floor 163 Eversholt Street London NW1 1BU a Lower Ground Floor, Elsley House 24/30 Great Titchfield Street London W1W 8BF in data 01 dic 2020

    1 pagineAD01

    Dichiarazione di conformità presentata il 31 mag 2020 senza aggiornamenti

    3 pagineCS01

    Conto per una società dormiente redatto al 26 mag 2019

    2 pagineAA

    Nomina di Mr Adrian Walker come amministratore in data 06 dic 2019

    2 pagineAP01

    Cessazione della carica di Giles Matthew Oliver David come segretario in data 06 dic 2019

    1 pagineTM02

    Cessazione della carica di Giles Matthew Oliver David come amministratore in data 06 dic 2019

    1 pagineTM01

    Dichiarazione di conformità presentata il 31 mag 2019 con aggiornamenti

    4 pagineCS01

    Nomina di Mr James Forrester Spragg come amministratore in data 30 apr 2019

    2 pagineAP01

    Cessazione della carica di Stephen Richards come amministratore in data 30 apr 2019

    1 pagineTM01

    Conto per una società dormiente redatto al 31 mag 2018

    2 pagineAA

    Dichiarazione di conformità presentata il 31 mag 2018 con aggiornamenti

    4 pagineCS01

    Notifica di Cafe Rouge Restaurants Limited come persona con controllo significativo il 06 apr 2016

    2 paginePSC02

    Revoca di una dichiarazione relativa a una persona con controllo significativo il 06 giu 2018

    2 paginePSC09

    Bilancio redatto al 28 mag 2017

    16 pagineAA

    Cessazione della carica di Timothy John Doubleday come amministratore in data 21 giu 2017

    1 pagineTM01

    Nomina di Giles Matthew Oliver David come segretario in data 21 giu 2017

    2 pagineAP03

    Nomina di Giles Matthew Oliver David come amministratore in data 21 giu 2017

    2 pagineAP01

    Dichiarazione di conformità presentata il 31 mag 2017 con aggiornamenti

    5 pagineCS01

    Bilancio redatto al 29 mag 2016

    20 pagineAA

    Bilancio annuale redatto al 31 mag 2016 con elenco completo degli azionisti

    7 pagineAR01
    Deposizioni associate
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    capital24 giu 2016

    Stato del capitale al 24 giu 2016

    • Capitale: GBP 1,400,000
    SH01

    Chi sono gli amministratori di ESPRESSO LIMITED?

    Amministratori
    NomeNominato ilDimissioni ilRuoloIndirizzoIdentificazione della societàPaese di residenzaNazionalitàData di nascitaProfessioneNumero
    WALKER, Adrian Rowland
    163 Eversholt Street
    NW1 1BU London
    1st Floor
    United Kingdom
    Amministratore
    163 Eversholt Street
    NW1 1BU London
    1st Floor
    United Kingdom
    EnglandBritish265227060001
    BUXTON SMITH, Maria Rita
    83 Wordsworth Avenue
    MK16 8RH Newport Pagnell
    Bucks
    Segretario
    83 Wordsworth Avenue
    MK16 8RH Newport Pagnell
    Bucks
    British39442340002
    DAVID, Giles Matthew Oliver
    1st Floor 163 Eversholt Street
    London
    NW1 1BU
    Segretario
    1st Floor 163 Eversholt Street
    London
    NW1 1BU
    237559880001
    FENTON, Nicola Jane
    Flat 1
    56 Rosslyn Hill
    NW3 1ND Hampstead
    London
    Segretario
    Flat 1
    56 Rosslyn Hill
    NW3 1ND Hampstead
    London
    British31440290005
    FRANKLIN, Robert Norman Carew
    147 Middleton Road
    E8 4LL London
    Segretario
    147 Middleton Road
    E8 4LL London
    British37258120002
    MANSIGANI, Mohan
    1st Floor 163 Eversholt Street
    London
    NW1 1BU
    Segretario
    1st Floor 163 Eversholt Street
    London
    NW1 1BU
    British64318140001
    MORLEY, Harry Michael Charles
    71 Musard Road
    W6 8NR London
    Segretario
    71 Musard Road
    W6 8NR London
    British49107830002
    BEKAY SECRETARIES LIMITED
    Conduit House 24 Conduit Place
    W2 1EP London
    Segretario
    Conduit House 24 Conduit Place
    W2 1EP London
    56992480001
    BARBOUR, Niel Paterson
    Church View Barn
    Loversall
    DN11 9DF Doncaster
    Amministratore
    Church View Barn
    Loversall
    DN11 9DF Doncaster
    British71423490001
    DAVID, Giles Matthew Oliver
    1st Floor 163 Eversholt Street
    London
    NW1 1BU
    Amministratore
    1st Floor 163 Eversholt Street
    London
    NW1 1BU
    EnglandBritish187907210001
    DERKACH, John
    1st Floor 163 Eversholt Street
    London
    NW1 1BU
    Amministratore
    1st Floor 163 Eversholt Street
    London
    NW1 1BU
    United KingdomBritish113885080002
    DOUBLEDAY, Timothy John
    163 Eversholt Street
    NW1 1BU London
    1st Floor
    United Kingdom
    Amministratore
    163 Eversholt Street
    NW1 1BU London
    1st Floor
    United Kingdom
    United KingdomBritish91011320001
    JOHNSON, Michael Andrew
    North End House
    Oakley Road
    SO51 0LQ Mottisfont
    Hampshire
    Amministratore
    North End House
    Oakley Road
    SO51 0LQ Mottisfont
    Hampshire
    United KingdomBritish98243170001
    JONES, Karen Elisabeth Dind
    31 Rosehill Road
    SW18 2NY London
    Amministratore
    31 Rosehill Road
    SW18 2NY London
    British47793260004
    MANSIGANI, Mohan
    1st Floor 163 Eversholt Street
    London
    NW1 1BU
    Amministratore
    1st Floor 163 Eversholt Street
    London
    NW1 1BU
    EnglandBritish64318140002
    MANSIGANI, Mohan
    36 Copthall Drive
    Mill Hill
    NW7 2NB London
    Amministratore
    36 Copthall Drive
    Mill Hill
    NW7 2NB London
    United KingdomBritish64318140001
    MORLEY, Harry Michael Charles
    71 Musard Road
    W6 8NR London
    Amministratore
    71 Musard Road
    W6 8NR London
    British49107830002
    MYERS, Roger
    Flat 16 9/11 Belsize Grove
    NW3 4UU London
    Amministratore
    Flat 16 9/11 Belsize Grove
    NW3 4UU London
    British56413030001
    PARSONS, James
    East Heath Road
    NW3 1AL London
    17
    United Kingdom
    Amministratore
    East Heath Road
    NW3 1AL London
    17
    United Kingdom
    United KingdomBritish98887110002
    RICHARDS, Stephen
    163 Eversholt Street
    NW1 1BU London
    1st Floor
    United Kingdom
    Amministratore
    163 Eversholt Street
    NW1 1BU London
    1st Floor
    United Kingdom
    EnglandBritish187618040002
    ROSS, Lewis Ian
    64 Elm Park Road
    SW3 6AU London
    Amministratore
    64 Elm Park Road
    SW3 6AU London
    United KingdomBritish8006590004
    SCOTT, Finlay Thomas Kennedy
    The Limes
    OX15 6NH Shenington
    Oxfordshire
    Amministratore
    The Limes
    OX15 6NH Shenington
    Oxfordshire
    United KingdomBritish72912750001
    SPRAGG, James Forrester
    163 Eversholt Street
    NW1 1BU London
    1st Floor
    United Kingdom
    Amministratore
    163 Eversholt Street
    NW1 1BU London
    1st Floor
    United Kingdom
    United KingdomBritish127602840002
    TURNER, Graham
    163 Eversholt Street
    NW1 1BU London
    1st Floor
    United Kingdom
    Amministratore
    163 Eversholt Street
    NW1 1BU London
    1st Floor
    United Kingdom
    United KingdomBritish59209570004
    WARNER, Sophie Jane
    7 Melrose Terrace
    W6 7RL London
    Amministratore
    7 Melrose Terrace
    W6 7RL London
    EnglandBritish49748240001
    WILLIAMS, Gavin Laurence
    2 Greenwood Road
    KT7 0DY Thames Ditton
    Surrey
    Amministratore
    2 Greenwood Road
    KT7 0DY Thames Ditton
    Surrey
    British54736710002
    WRIGHT, Nicholas David
    Kilby House
    Danesbury Park Road
    AL6 9SF Welwyn Garden City
    Herts
    Amministratore
    Kilby House
    Danesbury Park Road
    AL6 9SF Welwyn Garden City
    Herts
    British77805390001

    Chi sono le persone con controllo significativo di ESPRESSO LIMITED?

    Persone con controllo significativo
    NomeNotificato ilIndirizzoCessato
    163 Eversholt Street
    NW1 1BU London
    1st Floor
    United Kingdom
    06 apr 2016
    163 Eversholt Street
    NW1 1BU London
    1st Floor
    United Kingdom
    No
    Forma giuridicaLimited By Shares
    Paese di registrazioneEngland And Wales
    Autorità legaleUnited Kingdom (England And Wales)
    Luogo di registrazioneCompanies House
    Numero di registrazione00425057
    Natura del controllo
    • La persona possiede, direttamente o indirettamente, più del 75% delle azioni della società.
    • La persona detiene, direttamente o indirettamente, più del 75% dei diritti di voto nella società.
    • La persona ha il diritto, direttamente o indirettamente, di nominare o rimuovere la maggioranza del consiglio di amministrazione della società.

    Quali sono le ultime dichiarazioni delle persone con controllo significativo per ESPRESSO LIMITED?

    Dichiarazioni delle persone con controllo significativo
    Notificato ilCessato ilDichiarazione
    31 mag 201731 mag 2017La società non ha ancora completato le misure ragionevoli per determinare se vi sia alcuna persona che sia una persona registrabile o un'entità giuridica rilevante registrabile in relazione alla società.

    ESPRESSO LIMITED ha ipoteche?

    Ipoteche
    ClassificazioneDateStatoDettagli
    A registered charge
    Creato il 30 set 2014
    Consegnato il 03 ott 2014
    Soddisfatta integralmente
    L'ipoteca flottante copre tutto:
    Contiene un'ipotesi negativa:
    Contiene un'ipoteca flottante:
    Contiene un'ipoteca fissa:
    Persone aventi diritto
    • U.S. Bank Trustees Limited
    Transazioni
    • 03 ott 2014Registrazione di un'ipoteca (MR01)
    • 30 mag 2015Soddisfazione di un'ipoteca (MR04)
    Fixed and floating security document
    Creato il 25 lug 2007
    Consegnato il 31 lug 2007
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to any finance party on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    All its right, title and interest in and to the assigned contracts all insurances and a fixed charge on all present and future real property. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Barclays Bank PLC as Security Agent for the Benefit of the Finance Parties
    Transazioni
    • 31 lug 2007Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 30 mag 2015Soddisfazione di un'ipoteca (MR04)
    Fixed and floating security document
    Creato il 19 feb 2007
    Consegnato il 22 feb 2007
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to any finance party on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    The assigned contracts, insurances, present and future real property, book debts, bank accounts, intellectual property, investments, plant and machinery flaoting charge undertaking and all assets other than the loan note account present and future. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Barclays Bank PLC as Security Agent for the Benefit of the Finance Parties
    Transazioni
    • 22 feb 2007Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 30 mag 2015Soddisfazione di un'ipoteca (MR04)
    Debenture
    Creato il 25 mag 2006
    Consegnato il 09 giu 2006
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from any obligor to the security agent and/or the other security beneficiaries (or any of them) on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    All property,first fixed charge all other property,all licences,all computers,vehicles,office equipment and other equipment,the benefit of all contracts,licences and warranties. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Barclays Bank PLC the "Security Agent"
    Transazioni
    • 09 giu 2006Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 25 gen 2007Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Deed of accession and amendment
    Creato il 28 apr 2005
    Consegnato il 10 mag 2005
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from any obligor to the security agent and/or the other security beneficiaries (or any of them) under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    A grant of security over all security interests and disposistions and are created with a full title guarantee and are continuing security for payment of all of the secured obligations. Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Barclays Bank PLC ( the Security Agent)
    Transazioni
    • 10 mag 2005Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 25 gen 2007Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Deed of accession
    Creato il 28 apr 2005
    Consegnato il 10 mag 2005
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from any obligor to the security agent and/or the other security beneficiaries (or any of them) on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    All the present and future right,title and interest of the company in and to the following assets which are at any time owned by the company the property,all licences,plant and machinery,all computers,vehicles,office equipment and other equipment. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Barclays Bank PLC (The "Security Agent")
    Transazioni
    • 10 mag 2005Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 25 gen 2007Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Deed of accession to a composite guarantee and debenture
    Creato il 28 ago 2002
    Consegnato il 10 set 2002
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from any group company to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    20A winchester street, basingstoke t/no. HP536633 and unit 1 bishops wharf, 39 and 49 parkgate road t/no. TGL104043 and 296/298 high street, berkhamsted t/no. HD351012. For details of further properties charged please refer to form 395.. fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Barclays Bank PLC
    Transazioni
    • 10 set 2002Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 17 feb 2005Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Mortgage debenture
    Creato il 25 apr 1995
    Consegnato il 28 apr 1995
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    A specific equitable charge over all freehold and leasehold properties and/or the proceeds of sale thereof fixed and floating charges over undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts and the benefits of any licences.
    Persone aventi diritto
    • National Westminster Bank PLC
    Transazioni
    • 28 apr 1995Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 22 mag 2002Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Legal mortgage
    Creato il 03 feb 1993
    Consegnato il 11 feb 1993
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    F/H property situate at 6/7 south grove, highgate, london N6 t/no. NGL525834 and the proceeds of sale thereof. Floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment.
    Persone aventi diritto
    • National Westminster Bank PLC
    Transazioni
    • 11 feb 1993Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 22 mag 2002Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Legal mortgage
    Creato il 29 gen 1993
    Consegnato il 09 feb 1993
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Property k/a restaurant unit, lancer square, 28A kensington church street, london W8 t/no. BGL2254 and the proceeds of sale thereof. Floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment.
    Persone aventi diritto
    • County Natwest Limited
    Transazioni
    • 09 feb 1993Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 31 lug 1996Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Mortgage debenture
    Creato il 22 mag 1992
    Consegnato il 03 giu 1992
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    F/H--6/7 south grove high gate,london N.6.t/no.ngl 525834 and the proceeds of sale. Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Persone aventi diritto
    • County Natwest Limited
    Transazioni
    • 03 giu 1992Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 18 feb 1994Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Deed of rectification of deed of accession to a guarantee and composite debenture
    Creato il 02 ago 1991
    Consegnato il 05 ago 1991
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee pursuant to a guarantee and composite debenture dated 2-4-90 and amended on 24-5-91
    Brevi particolari
    Floating charge over please see 395 for full details. Undertaking and all property and assets.
    Persone aventi diritto
    • British & Commonwealth Merchant Bank PLC
    Transazioni
    • 05 ago 1991Registrazione di un'ipoteca
    • 22 mag 2002Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Deed of accession registered pursuant to an order of court dated 24/6/91
    Creato il 13 mag 1991
    Consegnato il 02 lug 1991
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee under or pursuant to a guarantee and composite debenture d/d 2/4/90 as amended by an amending guarantee and composite debenture dated 24/5/91
    Brevi particolari
    By way of legal mortgage all that freehold property situate at and k/a 6 & 7 south grove, highgate, london N6 t/no ngl 525834 with all buildings & fixtures undertaking and all property and assets present and future including goodwill uncalled capital (please see form 395 for full details).
    Persone aventi diritto
    • British and Commonwealth Merchant Bank PLC
    Transazioni
    • 02 lug 1991Registrazione di un'ipoteca
    • 22 mag 2002Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Legal charge
    Creato il 20 mag 1985
    Consegnato il 28 mag 1985
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    L/H property k/a or being 16,16A,18,18A montpelier vale blackheath london SE3 title no: sgl 228637.
    Persone aventi diritto
    • Barclays Bank PLC
    Transazioni
    • 28 mag 1985Registrazione di un'ipoteca
    Legal charge
    Creato il 20 mag 1985
    Consegnato il 21 mag 1985
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    F/H - 6 & 7 south grove, highgate, london N6.
    Persone aventi diritto
    • Barclays Bank PLC
    Transazioni
    • 21 mag 1985Registrazione di un'ipoteca
    • 03 giu 1992Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)

    Fonte dati

    • Companies House del Regno Unito
      Il registro ufficiale delle imprese nel Regno Unito, che fornisce l'accesso pubblico alle informazioni sulle imprese, come nomi, indirizzi, amministratori e depositi finanziari.
    • Licenza: CC0