COUNTRY HOUSE HOMES LIMITED
Panoramica
| Nome della società | COUNTRY HOUSE HOMES LIMITED |
|---|---|
| Stato della società | Sciolta |
| Forma giuridica | Società a responsabilità limitata |
| Numero di società | 01849671 |
| Giurisdizione | Inghilterra/Galles |
| Data di costituzione | |
| Data di cessazione |
Riepilogo
| Ha PSCs super sicuri | No |
|---|---|
| Ha ipoteche | Sì |
| Ha una storia di insolvenza | Sì |
| La sede legale è in contestazione | No |
Qual è lo scopo di COUNTRY HOUSE HOMES LIMITED?
- (7499) /
Dove si trova COUNTRY HOUSE HOMES LIMITED?
| Indirizzo della sede legale | KPMG RESTRUCTURING 8 Salisbury Square EC4Y 8BB London |
|---|---|
| Indirizzo della sede legale non recapitabile | No |
Quali erano i nomi precedenti di COUNTRY HOUSE HOMES LIMITED?
| Nome della società | Da | A |
|---|---|---|
| BUPA NURSING HOMES LIMITED | 16 mar 1990 | 16 mar 1990 |
| HOMELIFE CARE LIMITED | 15 ott 1985 | 15 ott 1985 |
| HOMELIFE NURSING LIMITED | 20 set 1984 | 20 set 1984 |
Quali sono gli ultimi bilanci di COUNTRY HOUSE HOMES LIMITED?
| Ultimi bilanci | |
|---|---|
| Ultimi bilanci redatti al | 31 dic 2009 |
Quali sono le ultime deposizioni per COUNTRY HOUSE HOMES LIMITED?
| Data | Descrizione | Documento | Tipo | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gazzetta ufficiale finale sciolta a seguito di liquidazione | 1 pagine | GAZ2 | ||||||||||
Ritorno della riunione finale in una liquidazione volontaria dei membri | 3 pagine | 4.71 | ||||||||||
Dichiarazione di solvibilità | 3 pagine | 4.70 | ||||||||||
Nomina di un liquidatore volontario | 1 pagine | 600 | ||||||||||
Risoluzioni Resolutions | 1 pagine | RESOLUTIONS | ||||||||||
| ||||||||||||
Indirizzo della sede legale modificato da Bridge House Outwood Lane, Horsforth Leeds West Yorkshire LS18 4UP in data 16 giu 2010 | 2 pagine | AD01 | ||||||||||
Cessazione della carica di Simon Reiter come amministratore | 1 pagine | TM01 | ||||||||||
Cessazione della carica di Mark Ellerby come amministratore | 1 pagine | TM01 | ||||||||||
Dettagli del direttore cambiati per Fraser David Gregory il 13 mag 2010 | 2 pagine | CH01 | ||||||||||
Conto per una società dormiente redatto al 31 dic 2009 | 4 pagine | AA | ||||||||||
Dettagli del direttore cambiati per Nicholas Tetley Beazley il 01 ott 2009 | 2 pagine | CH01 | ||||||||||
I registri sono stati trasferiti al luogo di ispezione registrato | 1 pagine | AD03 | ||||||||||
I registri sono stati trasferiti al luogo di ispezione registrato | 1 pagine | AD03 | ||||||||||
I registri sono stati trasferiti al luogo di ispezione registrato | 1 pagine | AD03 | ||||||||||
I registri sono stati trasferiti al luogo di ispezione registrato | 1 pagine | AD03 | ||||||||||
Dettagli del direttore cambiati per Simon Philip Reiter il 01 ott 2009 | 2 pagine | CH01 | ||||||||||
Dettagli del direttore cambiati per Mahboob Ali Merchant il 01 ott 2009 | 2 pagine | CH01 | ||||||||||
Dettagli del direttore cambiati per Fraser David Gregory il 01 ott 2009 | 2 pagine | CH01 | ||||||||||
Dettagli del direttore cambiati per Mark Ellerby il 01 ott 2009 | 2 pagine | CH01 | ||||||||||
L'indirizzo di ispezione del registro è stato modificato | 1 pagine | AD02 | ||||||||||
Conto per una società dormiente redatto al 31 dic 2008 | 4 pagine | AA | ||||||||||
legacy | 5 pagine | 363a | ||||||||||
Risoluzioni Resolutions | 2 pagine | RESOLUTIONS | ||||||||||
| ||||||||||||
legacy | 1 pagine | 288a | ||||||||||
legacy | 1 pagine | 288b | ||||||||||
Chi sono gli amministratori di COUNTRY HOUSE HOMES LIMITED?
| Nome | Nominato il | Dimissioni il | Ruolo | Indirizzo | Identificazione della società | Paese di residenza | Nazionalità | Data di nascita | Professione | Numero |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BUPA SECRETARIES LIMITED | Segretario | Bupa House 15-19 Bloomsbury Way WC1A 2BA London | 107319700001 | |||||||
| BEAZLEY, Nicholas Tetley | Amministratore | 15-19 Bloomsbury Way WC1A 2BA London Bupa House England | United Kingdom | British | 105797560001 | |||||
| GREGORY, Fraser David | Amministratore | 9 Nightingale Shott TW20 9SU Egham Berkshire | United Kingdom | British | 107664270003 | |||||
| MERCHANT, Mahboob Ali | Amministratore | 28 Denham Road KT17 3AA Epsom Surrey | United Kingdom | British | 56732410001 | |||||
| ABRAHAM, Richard John | Segretario | Well Cottage Eggington LU7 9PD North Leighton Buzzard Bedfordshire | British | 21672630003 | ||||||
| COPELAND, Francis Charles Stuart | Segretario | 29 West House Court Broken Cross SK10 3NZ Macclesfield Cheshire | British | 15613380001 | ||||||
| FARQUHARSON, John Alan | Segretario | Oak Lodge Windmill Lane Appleton WA4 5JN Warrington Cheshire | British | 15541980001 | ||||||
| KEE, Fergus Alexander | Segretario | The Old Cottage Howe Green SG13 8LH Hertford | Irish | 26911740008 | ||||||
| WALFORD, Arthur David | Segretario | 94 London Road HA7 4NS Stanmore Middlesex | British | 6658190001 | ||||||
| ABRAHAM, Richard John | Amministratore | Well Cottage Eggington LU7 9PD North Leighton Buzzard Bedfordshire | British | 21672630003 | ||||||
| BYE, Matthew Charles | Amministratore | 22 Charleville Road W14 9JH London | British | 66248190001 | ||||||
| COPELAND, Francis Charles Stuart | Amministratore | 29 West House Court Broken Cross SK10 3NZ Macclesfield Cheshire | British | 15613380001 | ||||||
| DAVIES, Julian Peter | Amministratore | Timberlea, Warminster Road South Newton SP2 0QW Salisbury Wiltshire | United Kingdom | British | 29367700001 | |||||
| ELLEN, Susan Caroline | Amministratore | 47 Ennerdale Road Kew TW9 2DN Richmond Surrey | England | British | 51168990001 | |||||
| ELLERBY, Mark | Amministratore | Burton Grange Burton Leonard HG3 3SU Harrogate North Yorkshire | England | British | 40582650004 | |||||
| ENGLEFIELD, Edward Ashton | Amministratore | 44 Carrwood Road Pownall Park SK9 5DN Wilmslow Cheshire | British | 35176020001 | ||||||
| FARQUHARSON, John Alan | Amministratore | Oak Lodge Windmill Lane Appleton WA4 5JN Warrington Cheshire | England | British | 15541980001 | |||||
| HOW, Alistair Maxwell | Amministratore | 159 Main Road Sheepy Magna CV9 3QU Atherstone Warwickshire | British | 90593100001 | ||||||
| KEE, Fergus Alexander | Amministratore | The Old Cottage Howe Green SG13 8LH Hertford | United Kingdom | Irish | 26911740008 | |||||
| KENT, Benjamin David Jemphrey | Amministratore | Fernleigh Lodge Northchurch Common HP4 1LR Berkhamsted Hertfordshire | United Kingdom | British | 93897360003 | |||||
| KING, Raymond | Amministratore | Westlands House Cowfold Road West Grinstead RH13 8LZ Horsham West Sussex | British | 56146040001 | ||||||
| LEA, Edward William | Amministratore | 81 Castle Road AL1 5DQ St. Albans Hertfordshire | British | 28018450003 | ||||||
| LEA, Edward William | Amministratore | The Spinney Rose Lane AL4 8RD Wheathampstead Hertfordshire | British | 28018450001 | ||||||
| LUDFORD, Peter Campbell | Amministratore | 18 The Avenue Rowledge GU10 4BD Farnham Surrey | British | 41484030002 | ||||||
| MCNEE, Alasdair Russell | Amministratore | 2a Carrick Road Curzon Park CH4 8AW Chester Cheshire | England | British | 107635730002 | |||||
| REITER, Simon Philip | Amministratore | 15-19 Bloomsbury Way WC1A 2BA London Bupa House England | United Kingdom | British | 135845570001 | |||||
| SMITH, Graham | Amministratore | Moor Lane LS297AF Burley In Wharfedale Briarfield West Yorkshire United Kingdom | United Kingdom | British | 142125320001 | |||||
| SPIEGELBERG, Anthony William Assheton | Amministratore | Oulton Park House CW6 9BL Tarporley Cheshire | England | British | 24626450001 | |||||
| TAYLOR, Neil Robert | Amministratore | Highfield Church Street HG5 8NR Goldsborough Knaresborough | United Kingdom | British | 62846800003 | |||||
| WALFORD, Arthur David | Amministratore | 94 London Road HA7 4NS Stanmore Middlesex | United Kingdom | British | 6658190001 | |||||
| WALKER, Jean | Amministratore | Little Garth Lime Grove GU4 7UT West Clandon Surrey | England | British | 47670830001 | |||||
| WATSON, Robert Ian | Amministratore | Ledgewood St Johns Hill Road GU21 1RP Woking Surrey | British | 40766100001 |
COUNTRY HOUSE HOMES LIMITED ha ipoteche?
| Classificazione | Date | Stato | Dettagli | |
|---|---|---|---|---|
| Supplemental deed. | Creato il 31 ago 1989 Consegnato il 08 set 1989 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All moneys due or to become due from the company and/or all or any of the other companies named therein to the chargee under the terms of this deed and the various documents defined therein | |
Brevi particolari Floating charge over all the undertaking, property, assets & rights. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
| Debenture | Creato il 18 mar 1987 Consegnato il 20 mar 1987 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All moneys due or to become due from the company and/or all or any of the other companies named to international westminster bank PLC as agent for the banks pursuant to a facility agreement of even date | |
Brevi particolari Floating charge over and rights both present and future. Undertaking and all property and assets. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
| Legal mortgage | Creato il 07 mag 1986 Consegnato il 16 mag 1986 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Brevi particolari F/H property k/a the croft great dunmow, essex. And the proceeds of sale thereof. Floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
| Legal mortgage | Creato il 27 gen 1986 Consegnato il 30 gen 1986 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Brevi particolari F/H property k/a part of upton manor moreton road wirral and the proceeds of sale thereof.. Floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
| Legal mortgage | Creato il 05 lug 1985 Consegnato il 05 lug 1985 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Brevi particolari F/H part of upton manor moreton road wirral and proceeds of sale thereof.. Floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
| Legal mortgage | Creato il 10 gen 1985 Consegnato il 16 gen 1985 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Brevi particolari F/H being port of evans house. De la warr parade, bexhill on sea, east sussex, and the proceeds of sale thereof.. Floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
COUNTRY HOUSE HOMES LIMITED ha procedimenti di insolvenza?
| Numero di pratica | Date | Tipo | Professionisti | Altro | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
| Liquidazione volontaria dei soci |
|
Fonte dati
- Companies House del Regno Unito
Il registro ufficiale delle imprese nel Regno Unito, che fornisce l'accesso pubblico alle informazioni sulle imprese, come nomi, indirizzi, amministratori e depositi finanziari. - Licenza: CC0