COUNTRY HOUSE HOMES LIMITED

COUNTRY HOUSE HOMES LIMITED

  • Panoramica
  • Riepilogo
  • Scopo
  • Indirizzo
  • Denominazioni precedenti
  • Bilanci
  • Deposizioni
  • Amministratori
  • Ipoteche
  • Insolvenza
  • Fonte dati
  • Panoramica

    Nome della societàCOUNTRY HOUSE HOMES LIMITED
    Stato della societàSciolta
    Forma giuridicaSocietà a responsabilità limitata
    Numero di società 01849671
    GiurisdizioneInghilterra/Galles
    Data di costituzione
    Data di cessazione

    Qual è lo scopo di COUNTRY HOUSE HOMES LIMITED?

    • (7499) /

    Dove si trova COUNTRY HOUSE HOMES LIMITED?

    Indirizzo della sede legale
    KPMG RESTRUCTURING
    8 Salisbury Square
    EC4Y 8BB London
    Indirizzo della sede legale non recapitabileNo

    Quali erano i nomi precedenti di COUNTRY HOUSE HOMES LIMITED?

    Denominazioni sociali precedenti
    Nome della societàDaA
    BUPA NURSING HOMES LIMITED16 mar 199016 mar 1990
    HOMELIFE CARE LIMITED15 ott 198515 ott 1985
    HOMELIFE NURSING LIMITED20 set 198420 set 1984

    Quali sono gli ultimi bilanci di COUNTRY HOUSE HOMES LIMITED?

    Ultimi bilanci
    Ultimi bilanci redatti al31 dic 2009

    Quali sono le ultime deposizioni per COUNTRY HOUSE HOMES LIMITED?

    Deposizioni
    DataDescrizioneDocumentoTipo

    Gazzetta ufficiale finale sciolta a seguito di liquidazione

    1 pagineGAZ2

    Ritorno della riunione finale in una liquidazione volontaria dei membri

    3 pagine4.71

    Dichiarazione di solvibilità

    3 pagine4.70

    Nomina di un liquidatore volontario

    1 pagine600

    Risoluzioni

    Resolutions
    1 pagineRESOLUTIONS
    Risoluzioni
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    liquidation

    Risoluzione speciale per la liquidazione al 26 mag 2010

    LRESSP

    Indirizzo della sede legale modificato da Bridge House Outwood Lane, Horsforth Leeds West Yorkshire LS18 4UP in data 16 giu 2010

    2 pagineAD01

    Cessazione della carica di Simon Reiter come amministratore

    1 pagineTM01

    Cessazione della carica di Mark Ellerby come amministratore

    1 pagineTM01

    Dettagli del direttore cambiati per Fraser David Gregory il 13 mag 2010

    2 pagineCH01

    Conto per una società dormiente redatto al 31 dic 2009

    4 pagineAA

    Dettagli del direttore cambiati per Nicholas Tetley Beazley il 01 ott 2009

    2 pagineCH01

    I registri sono stati trasferiti al luogo di ispezione registrato

    1 pagineAD03

    I registri sono stati trasferiti al luogo di ispezione registrato

    1 pagineAD03

    I registri sono stati trasferiti al luogo di ispezione registrato

    1 pagineAD03

    I registri sono stati trasferiti al luogo di ispezione registrato

    1 pagineAD03

    Dettagli del direttore cambiati per Simon Philip Reiter il 01 ott 2009

    2 pagineCH01

    Dettagli del direttore cambiati per Mahboob Ali Merchant il 01 ott 2009

    2 pagineCH01

    Dettagli del direttore cambiati per Fraser David Gregory il 01 ott 2009

    2 pagineCH01

    Dettagli del direttore cambiati per Mark Ellerby il 01 ott 2009

    2 pagineCH01

    L'indirizzo di ispezione del registro è stato modificato

    1 pagineAD02

    Conto per una società dormiente redatto al 31 dic 2008

    4 pagineAA

    legacy

    5 pagine363a

    Risoluzioni

    Resolutions
    2 pagineRESOLUTIONS
    Risoluzioni
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    capital

    Risoluzioni

    Section 175 07/01/2009
    RES13

    legacy

    1 pagine288a

    legacy

    1 pagine288b

    Chi sono gli amministratori di COUNTRY HOUSE HOMES LIMITED?

    Amministratori
    NomeNominato ilDimissioni ilRuoloIndirizzoIdentificazione della societàPaese di residenzaNazionalitàData di nascitaProfessioneNumero
    BUPA SECRETARIES LIMITED
    Bupa House
    15-19 Bloomsbury Way
    WC1A 2BA London
    Segretario
    Bupa House
    15-19 Bloomsbury Way
    WC1A 2BA London
    107319700001
    BEAZLEY, Nicholas Tetley
    15-19 Bloomsbury Way
    WC1A 2BA London
    Bupa House
    England
    Amministratore
    15-19 Bloomsbury Way
    WC1A 2BA London
    Bupa House
    England
    United KingdomBritish105797560001
    GREGORY, Fraser David
    9 Nightingale Shott
    TW20 9SU Egham
    Berkshire
    Amministratore
    9 Nightingale Shott
    TW20 9SU Egham
    Berkshire
    United KingdomBritish107664270003
    MERCHANT, Mahboob Ali
    28 Denham Road
    KT17 3AA Epsom
    Surrey
    Amministratore
    28 Denham Road
    KT17 3AA Epsom
    Surrey
    United KingdomBritish56732410001
    ABRAHAM, Richard John
    Well Cottage
    Eggington
    LU7 9PD North Leighton Buzzard
    Bedfordshire
    Segretario
    Well Cottage
    Eggington
    LU7 9PD North Leighton Buzzard
    Bedfordshire
    British21672630003
    COPELAND, Francis Charles Stuart
    29 West House Court
    Broken Cross
    SK10 3NZ Macclesfield
    Cheshire
    Segretario
    29 West House Court
    Broken Cross
    SK10 3NZ Macclesfield
    Cheshire
    British15613380001
    FARQUHARSON, John Alan
    Oak Lodge Windmill Lane
    Appleton
    WA4 5JN Warrington
    Cheshire
    Segretario
    Oak Lodge Windmill Lane
    Appleton
    WA4 5JN Warrington
    Cheshire
    British15541980001
    KEE, Fergus Alexander
    The Old Cottage
    Howe Green
    SG13 8LH Hertford
    Segretario
    The Old Cottage
    Howe Green
    SG13 8LH Hertford
    Irish26911740008
    WALFORD, Arthur David
    94 London Road
    HA7 4NS Stanmore
    Middlesex
    Segretario
    94 London Road
    HA7 4NS Stanmore
    Middlesex
    British6658190001
    ABRAHAM, Richard John
    Well Cottage
    Eggington
    LU7 9PD North Leighton Buzzard
    Bedfordshire
    Amministratore
    Well Cottage
    Eggington
    LU7 9PD North Leighton Buzzard
    Bedfordshire
    British21672630003
    BYE, Matthew Charles
    22 Charleville Road
    W14 9JH London
    Amministratore
    22 Charleville Road
    W14 9JH London
    British66248190001
    COPELAND, Francis Charles Stuart
    29 West House Court
    Broken Cross
    SK10 3NZ Macclesfield
    Cheshire
    Amministratore
    29 West House Court
    Broken Cross
    SK10 3NZ Macclesfield
    Cheshire
    British15613380001
    DAVIES, Julian Peter
    Timberlea, Warminster Road
    South Newton
    SP2 0QW Salisbury
    Wiltshire
    Amministratore
    Timberlea, Warminster Road
    South Newton
    SP2 0QW Salisbury
    Wiltshire
    United KingdomBritish29367700001
    ELLEN, Susan Caroline
    47 Ennerdale Road
    Kew
    TW9 2DN Richmond
    Surrey
    Amministratore
    47 Ennerdale Road
    Kew
    TW9 2DN Richmond
    Surrey
    EnglandBritish51168990001
    ELLERBY, Mark
    Burton Grange
    Burton Leonard
    HG3 3SU Harrogate
    North Yorkshire
    Amministratore
    Burton Grange
    Burton Leonard
    HG3 3SU Harrogate
    North Yorkshire
    EnglandBritish40582650004
    ENGLEFIELD, Edward Ashton
    44 Carrwood Road
    Pownall Park
    SK9 5DN Wilmslow
    Cheshire
    Amministratore
    44 Carrwood Road
    Pownall Park
    SK9 5DN Wilmslow
    Cheshire
    British35176020001
    FARQUHARSON, John Alan
    Oak Lodge Windmill Lane
    Appleton
    WA4 5JN Warrington
    Cheshire
    Amministratore
    Oak Lodge Windmill Lane
    Appleton
    WA4 5JN Warrington
    Cheshire
    EnglandBritish15541980001
    HOW, Alistair Maxwell
    159 Main Road
    Sheepy Magna
    CV9 3QU Atherstone
    Warwickshire
    Amministratore
    159 Main Road
    Sheepy Magna
    CV9 3QU Atherstone
    Warwickshire
    British90593100001
    KEE, Fergus Alexander
    The Old Cottage
    Howe Green
    SG13 8LH Hertford
    Amministratore
    The Old Cottage
    Howe Green
    SG13 8LH Hertford
    United KingdomIrish26911740008
    KENT, Benjamin David Jemphrey
    Fernleigh Lodge
    Northchurch Common
    HP4 1LR Berkhamsted
    Hertfordshire
    Amministratore
    Fernleigh Lodge
    Northchurch Common
    HP4 1LR Berkhamsted
    Hertfordshire
    United KingdomBritish93897360003
    KING, Raymond
    Westlands House
    Cowfold Road West Grinstead
    RH13 8LZ Horsham
    West Sussex
    Amministratore
    Westlands House
    Cowfold Road West Grinstead
    RH13 8LZ Horsham
    West Sussex
    British56146040001
    LEA, Edward William
    81 Castle Road
    AL1 5DQ St. Albans
    Hertfordshire
    Amministratore
    81 Castle Road
    AL1 5DQ St. Albans
    Hertfordshire
    British28018450003
    LEA, Edward William
    The Spinney
    Rose Lane
    AL4 8RD Wheathampstead
    Hertfordshire
    Amministratore
    The Spinney
    Rose Lane
    AL4 8RD Wheathampstead
    Hertfordshire
    British28018450001
    LUDFORD, Peter Campbell
    18 The Avenue
    Rowledge
    GU10 4BD Farnham
    Surrey
    Amministratore
    18 The Avenue
    Rowledge
    GU10 4BD Farnham
    Surrey
    British41484030002
    MCNEE, Alasdair Russell
    2a Carrick Road
    Curzon Park
    CH4 8AW Chester
    Cheshire
    Amministratore
    2a Carrick Road
    Curzon Park
    CH4 8AW Chester
    Cheshire
    EnglandBritish107635730002
    REITER, Simon Philip
    15-19 Bloomsbury Way
    WC1A 2BA London
    Bupa House
    England
    Amministratore
    15-19 Bloomsbury Way
    WC1A 2BA London
    Bupa House
    England
    United KingdomBritish135845570001
    SMITH, Graham
    Moor Lane
    LS297AF Burley In Wharfedale
    Briarfield
    West Yorkshire
    United Kingdom
    Amministratore
    Moor Lane
    LS297AF Burley In Wharfedale
    Briarfield
    West Yorkshire
    United Kingdom
    United KingdomBritish142125320001
    SPIEGELBERG, Anthony William Assheton
    Oulton Park House
    CW6 9BL Tarporley
    Cheshire
    Amministratore
    Oulton Park House
    CW6 9BL Tarporley
    Cheshire
    EnglandBritish24626450001
    TAYLOR, Neil Robert
    Highfield
    Church Street
    HG5 8NR Goldsborough
    Knaresborough
    Amministratore
    Highfield
    Church Street
    HG5 8NR Goldsborough
    Knaresborough
    United KingdomBritish62846800003
    WALFORD, Arthur David
    94 London Road
    HA7 4NS Stanmore
    Middlesex
    Amministratore
    94 London Road
    HA7 4NS Stanmore
    Middlesex
    United KingdomBritish6658190001
    WALKER, Jean
    Little Garth Lime Grove
    GU4 7UT West Clandon
    Surrey
    Amministratore
    Little Garth Lime Grove
    GU4 7UT West Clandon
    Surrey
    EnglandBritish47670830001
    WATSON, Robert Ian
    Ledgewood
    St Johns Hill Road
    GU21 1RP Woking
    Surrey
    Amministratore
    Ledgewood
    St Johns Hill Road
    GU21 1RP Woking
    Surrey
    British40766100001

    COUNTRY HOUSE HOMES LIMITED ha ipoteche?

    Ipoteche
    ClassificazioneDateStatoDettagli
    Supplemental deed.
    Creato il 31 ago 1989
    Consegnato il 08 set 1989
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All moneys due or to become due from the company and/or all or any of the other companies named therein to the chargee under the terms of this deed and the various documents defined therein
    Brevi particolari
    Floating charge over all the undertaking, property, assets & rights.
    Persone aventi diritto
    • International Westminister Bank PLC(The "Facility Agent") on Behalf of the Underwriters and Tender Panel Members
    Transazioni
    • 08 set 1989Registrazione di un'ipoteca
    • 15 ott 1992Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Debenture
    Creato il 18 mar 1987
    Consegnato il 20 mar 1987
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All moneys due or to become due from the company and/or all or any of the other companies named to international westminster bank PLC as agent for the banks pursuant to a facility agreement of even date
    Brevi particolari
    Floating charge over and rights both present and future. Undertaking and all property and assets.
    Persone aventi diritto
    • International Westminster Bank PLC
    Transazioni
    • 20 mar 1987Registrazione di un'ipoteca
    • 03 ott 1992Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Legal mortgage
    Creato il 07 mag 1986
    Consegnato il 16 mag 1986
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    F/H property k/a the croft great dunmow, essex. And the proceeds of sale thereof. Floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment.
    Persone aventi diritto
    • National Westminster Bank PLC
    Transazioni
    • 16 mag 1986Registrazione di un'ipoteca
    Legal mortgage
    Creato il 27 gen 1986
    Consegnato il 30 gen 1986
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    F/H property k/a part of upton manor moreton road wirral and the proceeds of sale thereof.. Floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment.
    Persone aventi diritto
    • National Westminster Bank PLC
    Transazioni
    • 30 gen 1986Registrazione di un'ipoteca
    Legal mortgage
    Creato il 05 lug 1985
    Consegnato il 05 lug 1985
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    F/H part of upton manor moreton road wirral and proceeds of sale thereof.. Floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment.
    Persone aventi diritto
    • National Westminster Bank PLC
    Transazioni
    • 05 lug 1985Registrazione di un'ipoteca
    Legal mortgage
    Creato il 10 gen 1985
    Consegnato il 16 gen 1985
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    F/H being port of evans house. De la warr parade, bexhill on sea, east sussex, and the proceeds of sale thereof.. Floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment.
    Persone aventi diritto
    • National Westminster Bank PLC
    Transazioni
    • 16 gen 1985Registrazione di un'ipoteca

    COUNTRY HOUSE HOMES LIMITED ha procedimenti di insolvenza?

    Numero di praticaDateTipoProfessionistiAltro
    1
    DataTipo
    01 gen 2011Data di scioglimento
    26 mag 2010Inizio della liquidazione
    Liquidazione volontaria dei soci
    NomeRuoloIndirizzoNominato ilCessato il
    Jeremy Simon Spratt
    Kpmg
    8 Salisbury Square
    EC4Y 8BB London
    Praticante
    Kpmg
    8 Salisbury Square
    EC4Y 8BB London
    John David Thomas Milsom
    Kpmg Llp
    8 Salisbury Square
    EC4Y 8BB London
    Praticante
    Kpmg Llp
    8 Salisbury Square
    EC4Y 8BB London

    Fonte dati

    • Companies House del Regno Unito
      Il registro ufficiale delle imprese nel Regno Unito, che fornisce l'accesso pubblico alle informazioni sulle imprese, come nomi, indirizzi, amministratori e depositi finanziari.
    • Licenza: CC0