HARPER GROUP PLC

  • Panoramica
  • Riepilogo
  • Scopo
  • Indirizzo
  • Denominazioni precedenti
  • Bilanci
  • Dichiarazione di conferma
  • Deposizioni
  • Amministratori
  • Persone con controllo significativo
  • Ipoteche
  • Fonte dati
  • Panoramica

    Nome della societàHARPER GROUP PLC
    Stato della societàAttiva
    Forma giuridicaSocietà per azioni
    Numero di società 01854872
    GiurisdizioneInghilterra/Galles
    Data di costituzione

    Qual è lo scopo di HARPER GROUP PLC?

    • Sviluppo di progetti di costruzione (41100) / Costruzioni
    • Costruzione di edifici commerciali (41201) / Costruzioni
    • Costruzione di edifici residenziali (41202) / Costruzioni

    Dove si trova HARPER GROUP PLC?

    Indirizzo della sede legale
    Units 1 & 2 Bevan Industrial Estate
    DY5 3TF Brierley Hill
    West Midlands
    England
    Indirizzo della sede legale non recapitabileNo

    Quali erano i nomi precedenti di HARPER GROUP PLC?

    Denominazioni sociali precedenti
    Nome della societàDaA
    ELVATON LIMITED12 ott 198412 ott 1984

    Quali sono gli ultimi bilanci di HARPER GROUP PLC?

    ScadutoNo
    Prossimi bilanci
    Fine del prossimo esercizio al31 dic 2024
    Scadenza dei prossimi bilanci il30 giu 2025
    Ultimi bilanci
    Ultimi bilanci redatti al31 dic 2023

    Qual è lo stato dell'ultima dichiarazione di conferma per HARPER GROUP PLC?

    Ultima dichiarazione di conferma redatta al04 giu 2025
    Scadenza della prossima dichiarazione di conferma18 giu 2025
    Ultima dichiarazione di conferma
    Prossima dichiarazione di conferma redatta al04 giu 2024
    ScadutoNo

    Quali sono le ultime deposizioni per HARPER GROUP PLC?

    Deposizioni
    DataDescrizioneDocumentoTipo

    Dichiarazione di conformità presentata il 04 giu 2024 senza aggiornamenti

    3 pagineCS01
    XD4J48U9

    Bilancio redatto al 31 dic 2023

    21 pagineAA
    XD48H16G

    Dettagli del direttore cambiati per Mr Anthony Paul Rees il 29 feb 2024

    2 pagineCH01
    XCYQVGXM

    Bilancio redatto al 31 dic 2022

    22 pagineAA
    XC6L57TF

    Dichiarazione di conformità presentata il 04 giu 2023 senza aggiornamenti

    3 pagineCS01
    XC568O4Q

    Bilancio redatto al 31 dic 2021

    22 pagineAA
    XB73OEU3

    Dichiarazione di conformità presentata il 04 giu 2022 senza aggiornamenti

    3 pagineCS01
    XB5J0GG2

    Dichiarazione di conformità presentata il 04 giu 2021 senza aggiornamenti

    3 pagineCS01
    XA5Y5KHC

    Bilancio redatto al 31 dic 2020

    23 pagineAA
    XA480X68

    Dichiarazione di conformità presentata il 04 giu 2020 senza aggiornamenti

    3 pagineCS01
    X96LHO0H

    Bilancio redatto al 31 dic 2019

    23 pagineAA
    X95XGP8Z

    Cessazione della carica di Peter Nigel Mondon come amministratore in data 28 feb 2020

    1 pagineTM01
    X8ZRBIF6

    Cessazione della carica di Peter Nigel Mondon come segretario in data 28 feb 2020

    1 pagineTM02
    X8ZRBIGQ

    Dichiarazione di conformità presentata il 04 giu 2019 senza aggiornamenti

    3 pagineCS01
    X86XFB7L

    Bilancio redatto al 31 dic 2018

    23 pagineAA
    X8428JBH

    Dichiarazione di conformità presentata il 04 giu 2018 senza aggiornamenti

    3 pagineCS01
    X77H54SR

    Bilancio redatto al 31 dic 2017

    23 pagineAA
    X75ZCCLN

    Indirizzo della sede legale modificato da Beeches Road Rowley Regis Warley West Midlands B65 0BB a Units 1 & 2 Bevan Industrial Estate Brierley Hill West Midlands DY5 3TF in data 18 ago 2017

    1 pagineAD01
    X6D3FSMZ

    Dichiarazione di conformità presentata il 04 giu 2017 con aggiornamenti

    5 pagineCS01
    X68QHEY3

    Bilancio redatto al 31 dic 2016

    24 pagineAA
    A65BZBUH

    Bilancio annuale redatto al 04 giu 2016 con elenco completo degli azionisti

    6 pagineAR01
    Deposizioni associate
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    capital06 giu 2016

    Stato del capitale al 06 giu 2016

    • Capitale: GBP 599,508
    SH01
    X58LOOWW

    Bilancio redatto al 31 dic 2015

    22 pagineAA
    A56SBU43

    Bilancio annuale redatto al 04 giu 2015 con elenco completo degli azionisti

    6 pagineAR01
    Deposizioni associate
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    capital10 giu 2015

    Stato del capitale al 10 giu 2015

    • Capitale: GBP 599,508
    SH01
    X49AGJS0

    Bilancio redatto al 31 dic 2014

    20 pagineAA
    A45K9HLK

    Bilancio annuale redatto al 04 giu 2014 con elenco completo degli azionisti

    6 pagineAR01
    Deposizioni associate
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    capital25 giu 2014

    Stato del capitale al 25 giu 2014

    • Capitale: GBP 599,508
    SH01
    X3AT3NOZ

    Chi sono gli amministratori di HARPER GROUP PLC?

    Amministratori
    NomeNominato ilDimissioni ilRuoloIndirizzoIdentificazione della societàPaese di residenzaNazionalitàData di nascitaProfessioneNumero
    OVERTON, Victoria Jane
    Bevan Industrial Estate
    DY5 3TF Brierley Hill
    Units 1 & 2
    West Midlands
    England
    Segretario
    Bevan Industrial Estate
    DY5 3TF Brierley Hill
    Units 1 & 2
    West Midlands
    England
    British97258880003
    HARVEY, Michael
    Bevan Industrial Estate
    DY5 3TF Brierley Hill
    Units 1 & 2
    West Midlands
    England
    Amministratore
    Bevan Industrial Estate
    DY5 3TF Brierley Hill
    Units 1 & 2
    West Midlands
    England
    United KingdomBritishDirector70216940003
    OVERTON, Victoria Jane
    Bevan Industrial Estate
    DY5 3TF Brierley Hill
    Units 1 & 2
    West Midlands
    England
    Amministratore
    Bevan Industrial Estate
    DY5 3TF Brierley Hill
    Units 1 & 2
    West Midlands
    England
    United KingdomBritishDirector97258880003
    REES, Anthony Paul
    Bevan Industrial Estate
    DY5 3TF Brierley Hill
    Units 1 & 2
    West Midlands
    England
    Amministratore
    Bevan Industrial Estate
    DY5 3TF Brierley Hill
    Units 1 & 2
    West Midlands
    England
    EnglandBritishDirector95309560006
    LENNOCK, Mark William
    4 Cedar Grove
    Hagley
    DY9 0DR Stourbridge
    West Midlands
    Segretario
    4 Cedar Grove
    Hagley
    DY9 0DR Stourbridge
    West Midlands
    BritishInvestment Manager2069680006
    MONDON, Peter Nigel
    Bevan Industrial Estate
    DY5 3TF Brierley Hill
    Units 1 & 2
    West Midlands
    England
    Segretario
    Bevan Industrial Estate
    DY5 3TF Brierley Hill
    Units 1 & 2
    West Midlands
    England
    BritishCo Director Construction51801010002
    ROBINSON, Michael Albert
    5 Oak Drive
    Seisdon
    WV5 7ET Wolverhampton
    West Midlands
    Segretario
    5 Oak Drive
    Seisdon
    WV5 7ET Wolverhampton
    West Midlands
    British11309240001
    TAYLOR, Kevin Trevor
    107 Fallowfield Road
    B63 1BY Halesowen
    West Midlands
    Segretario
    107 Fallowfield Road
    B63 1BY Halesowen
    West Midlands
    British63465950001
    AMOS, Raymond Leslie
    Tall Pines Barons Cross Road
    HR6 8QX Leominster
    Herefordshire
    Amministratore
    Tall Pines Barons Cross Road
    HR6 8QX Leominster
    Herefordshire
    BritishManaging Director12219390001
    HARPER, Joseph Donald
    Fulhams Mews
    Kyre
    WR15 8RN Tenbury Wells
    Worcestershire
    Amministratore
    Fulhams Mews
    Kyre
    WR15 8RN Tenbury Wells
    Worcestershire
    BritishBuilder12219400001
    HARPER, Joseph Stuart
    218 Bromsgrove Road
    Hunnington
    B62 0JS Halesowen
    West Midlands
    Amministratore
    218 Bromsgrove Road
    Hunnington
    B62 0JS Halesowen
    West Midlands
    United KingdomBritishSurveyor11309270001
    HARPER, Leonard Frank
    Brackens
    Mucklow Hill
    B62 8NX Halesowen
    West Midlands
    Amministratore
    Brackens
    Mucklow Hill
    B62 8NX Halesowen
    West Midlands
    BritishBuilder11318970001
    LENNOCK, Mark William
    4 Cedar Grove
    Hagley
    DY9 0DR Stourbridge
    West Midlands
    Amministratore
    4 Cedar Grove
    Hagley
    DY9 0DR Stourbridge
    West Midlands
    EnglandBritishInvestment Manager2069680006
    MONDON, Peter Nigel
    Bevan Industrial Estate
    DY5 3TF Brierley Hill
    Units 1 & 2
    West Midlands
    England
    Amministratore
    Bevan Industrial Estate
    DY5 3TF Brierley Hill
    Units 1 & 2
    West Midlands
    England
    EnglandBritishCo Director Construction51801010002
    MONDON, Peter Nigel
    13 Huntsmans Close
    WV16 5BE Bridgnorth
    Salop
    Amministratore
    13 Huntsmans Close
    WV16 5BE Bridgnorth
    Salop
    BritishCompany Director51801010001
    REES, Walter Paul
    Buckfield House Barons Cross Road
    HR6 8QX Leominster
    Herefordshire
    Amministratore
    Buckfield House Barons Cross Road
    HR6 8QX Leominster
    Herefordshire
    BritishQuantity Surveyor11309290001
    ROBINSON, Michael Albert
    5 Oak Drive
    Seisdon
    WV5 7ET Wolverhampton
    West Midlands
    Amministratore
    5 Oak Drive
    Seisdon
    WV5 7ET Wolverhampton
    West Midlands
    BritishChartered Accountant11309240001
    UNDERHILL, Peter John
    Maes Court
    Knighton On Teme
    WR15 8LY Tenbury Wells
    Worcestershire
    Amministratore
    Maes Court
    Knighton On Teme
    WR15 8LY Tenbury Wells
    Worcestershire
    BritishCompany Director17203000001

    Chi sono le persone con controllo significativo di HARPER GROUP PLC?

    Persone con controllo significativo
    NomeNotificato ilIndirizzoCessato
    Beeches Road
    B65 0BB Rowley Regis
    101
    England
    06 apr 2016
    Beeches Road
    B65 0BB Rowley Regis
    101
    England
    No
    Forma giuridicaPrivate Limited Company
    Paese di registrazioneEngland
    Autorità legaleCompanies Act
    Luogo di registrazioneCompanies House
    Numero di registrazione06892284
    Natura del controllo
    • La persona possiede, direttamente o indirettamente, più del 75% delle azioni della società.
    • La persona detiene, direttamente o indirettamente, più del 75% dei diritti di voto nella società.
    • La persona ha il diritto di esercitare, o esercita effettivamente, un'influenza significativa o un controllo sulle attività di una società che, secondo la legge che la regola, non è una persona giuridica; e i membri di quella società (nella loro qualità di tali) hanno il diritto, direttamente o indirettamente, di nominare o rimuovere la maggioranza del consiglio di amministrazione della società.
    • La persona ha il diritto di esercitare, o esercita effettivamente, un'influenza significativa o un controllo sulle attività di una società che, secondo la legge che la regola, non è una persona giuridica; e i membri di quella società (nella loro qualità di tali) hanno il diritto di esercitare, o effettivamente esercitano, un'influenza significativa o un controllo sulla società.

    HARPER GROUP PLC ha ipoteche?

    Ipoteche
    ClassificazioneDateStatoDettagli
    Debenture
    Creato il 18 ott 2007
    Consegnato il 24 ott 2007
    In corso
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Mrs Susan Ingrid Underhill
    Transazioni
    • 24 ott 2007Registrazione di un'ipoteca (395)
    Debenture
    Creato il 27 mar 2006
    Consegnato il 30 mar 2006
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    The principal su of £2,691,497.00 and all other monies due or to become due
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Persone aventi diritto
    • Old Mill Construction Limited
    Transazioni
    • 30 mar 2006Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 07 feb 2007Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Debenture
    Creato il 12 lug 2004
    Consegnato il 16 lug 2004
    In corso
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Persone aventi diritto
    • Hsbc Bank PLC
    Transazioni
    • 16 lug 2004Registrazione di un'ipoteca (395)
    Debenture
    Creato il 02 feb 1999
    Consegnato il 12 feb 1999
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee pursuant to a loan agreement of even date
    Brevi particolari
    .. fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Alvin Joseph Harper
    Transazioni
    • 12 feb 1999Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 19 nov 2005Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Debenture
    Creato il 02 feb 1999
    Consegnato il 12 feb 1999
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee pursuant to the loan agreement dated 2 february 1999
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Persone aventi diritto
    • Godfrey Charles Harper
    Transazioni
    • 12 feb 1999Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 19 nov 2005Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Debenture
    Creato il 02 feb 1999
    Consegnato il 12 feb 1999
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee pursuant to the loan agreement dated 2 february 1999
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Persone aventi diritto
    • Rowland William Harper
    Transazioni
    • 12 feb 1999Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 19 nov 2005Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Debenture
    Creato il 02 feb 1999
    Consegnato il 12 feb 1999
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee pursuant to the loan agreement dated 2 february 1999
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Persone aventi diritto
    • Clive Dean Harper
    Transazioni
    • 12 feb 1999Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 19 nov 2005Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Debenture
    Creato il 02 feb 1999
    Consegnato il 12 feb 1999
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee pursuant to a loan agreement dated 2 february 1999
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Persone aventi diritto
    • Leonard Frank Harper
    Transazioni
    • 12 feb 1999Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 19 nov 2005Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Debenture
    Creato il 02 feb 1999
    Consegnato il 12 feb 1999
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee pursuant to a loan agreement of even date
    Brevi particolari
    .. fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Joseph Donald Harper
    Transazioni
    • 12 feb 1999Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 19 nov 2005Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Debenture
    Creato il 02 feb 1999
    Consegnato il 12 feb 1999
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee pursuant to a loan agreement of even date
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Fiona Jane Burton
    Transazioni
    • 12 feb 1999Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 19 nov 2005Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Mortgage debenture
    Creato il 23 ago 1994
    Consegnato il 07 set 1994
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Peter John Underhill
    Transazioni
    • 07 set 1994Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 19 nov 2005Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Mortgage debenture
    Creato il 23 ago 1994
    Consegnato il 07 set 1994
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Mark William Lennock
    Transazioni
    • 07 set 1994Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 19 nov 2005Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Legal charge
    Creato il 02 dic 1993
    Consegnato il 17 dic 1993
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Wyncote beeches road rowley regis warley west midlands t/n WR12352.
    Persone aventi diritto
    • Barclays Bank PLC
    Transazioni
    • 17 dic 1993Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 19 nov 2005Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Legal charge
    Creato il 02 dic 1993
    Consegnato il 17 dic 1993
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    100 beeches road rowley regis west midlands t/n WR10328.
    Persone aventi diritto
    • Barclays Bank PLC
    Transazioni
    • 17 dic 1993Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 19 nov 2005Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Legal charge
    Creato il 02 dic 1993
    Consegnato il 17 dic 1993
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    99 beeches road rowley regis warley west midlands t/n WM38310.
    Persone aventi diritto
    • Barclays Bank PLC
    Transazioni
    • 17 dic 1993Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 19 nov 2005Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Deed of charge over credit balances
    Creato il 02 set 1993
    Consegnato il 13 set 1993
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Fixed charge over all the deposits together with all interest (account no 70147230). see the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Barclays Bank PLC
    Transazioni
    • 13 set 1993Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 19 nov 2005Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Further guarantee & debenture
    Creato il 07 giu 1985
    Consegnato il 14 giu 1985
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company and/or all or any of the other companies named therein to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Persone aventi diritto
    • Barclays Bank PLC
    Transazioni
    • 14 giu 1985Registrazione di un'ipoteca
    • 19 nov 2005Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)

    Fonte dati

    • Companies House del Regno Unito
      Il registro ufficiale delle imprese nel Regno Unito, che fornisce l'accesso pubblico alle informazioni sulle imprese, come nomi, indirizzi, amministratori e depositi finanziari.
    • Licenza: CC0