MHP COMMUNICATIONS LIMITED

MHP COMMUNICATIONS LIMITED

  • Panoramica
  • Riepilogo
  • Scopo
  • Indirizzo
  • Denominazioni precedenti
  • Bilanci
  • Deposizioni
  • Amministratori
  • Persone con controllo significativo
  • Ipoteche
  • Fonte dati
  • Panoramica

    Nome della societàMHP COMMUNICATIONS LIMITED
    Stato della societàSciolta
    Forma giuridicaSocietà a responsabilità limitata
    Numero di società 01855944
    GiurisdizioneInghilterra/Galles
    Data di costituzione
    Data di cessazione

    Qual è lo scopo di MHP COMMUNICATIONS LIMITED?

    • Società inattiva (99999) / Attività di organizzazioni ed organismi extraterritoriali

    Dove si trova MHP COMMUNICATIONS LIMITED?

    Indirizzo della sede legale
    60w Great Portland Street
    W1W 7RT London
    England
    Indirizzo della sede legale non recapitabileNo

    Quali erano i nomi precedenti di MHP COMMUNICATIONS LIMITED?

    Denominazioni sociali precedenti
    Nome della societàDaA
    MANDATE COMMUNICATIONS LIMITED21 nov 200721 nov 2007
    A S BISS AND COMPANY LIMITED01 apr 200401 apr 2004
    EMBOROUGH LIMITED19 ago 198819 ago 1988
    EMBOROUGH LEASING LIMITED16 ott 198416 ott 1984

    Quali sono gli ultimi bilanci di MHP COMMUNICATIONS LIMITED?

    Ultimi bilanci
    Ultimi bilanci redatti al31 dic 2022

    Quali sono le ultime deposizioni per MHP COMMUNICATIONS LIMITED?

    Deposizioni
    DataDescrizioneDocumentoTipo

    Gazzetta Ufficiale finale sciolta per scioglimento volontario

    1 pagineGAZ2(A)

    Prima Gazzetta Ufficiale per lo scioglimento volontario

    1 pagineGAZ1(A)

    Richiesta di cancellazione della società dal registro

    1 pagineDS01
    XCIMM71M

    Bilancio di società controllata esente da revisione redatto al 31 dic 2022

    12 pagineAA
    ACCN4GQP

    legacy

    214 paginePARENT_ACC
    ACCN4GZN

    legacy

    3 pagineGUARANTEE2
    ACCN4GZC

    legacy

    1 pagineAGREEMENT2
    ACCN4H1B

    Dichiarazione di conformità presentata il 01 giu 2023 senza aggiornamenti

    3 pagineCS01
    XC5BP9UA

    Conto per una società dormiente redatto al 31 dic 2021

    8 pagineAA
    ABWW7VY1

    legacy

    53 paginePARENT_ACC
    RBWY9OC2

    legacy

    3 pagineGUARANTEE2
    ABWW7VXD

    legacy

    1 pagineAGREEMENT2
    ABWW7VXT

    Dichiarazione di conformità presentata il 31 dic 2022 senza aggiornamenti

    3 pagineCS01
    XBVJ9BYW

    Nomina di Mr Mark John Sanford come segretario in data 30 apr 2022

    2 pagineAP03
    XB3DMNWR

    Cessazione della carica di Emma Louise Wood come segretario in data 30 apr 2022

    1 pagineTM02
    XB3DMNUB

    Indirizzo della sede legale modificato da 75 Bermondsey Street London SE1 3XF England a 60W Great Portland Street London W1W 7RT in data 05 mag 2022

    1 pagineAD01
    XB3DMNIX

    Ritiro della richiesta di cancellazione della società

    1 pagineDS02
    XAZY1EAH

    Nomina di Mr Jonathan Andrew Peachey come amministratore in data 08 mar 2022

    2 pagineAP01
    XAZCH2WJ

    Nomina di Mr Peter Jonathan Harris come amministratore in data 08 mar 2022

    2 pagineAP01
    XAZCH2PV

    Cessazione della carica di William Michael Thompson come amministratore in data 08 mar 2022

    1 pagineTM01
    XAZCH282

    Nomina di Emma Louise Wood come segretario in data 08 mar 2022

    2 pagineAP03
    XAZCH2E1

    Cessazione della carica di Lawrence Jeffrey Diamond come amministratore in data 08 mar 2022

    1 pagineTM01
    XAZCH25U

    Cessazione della carica di Paul Jason Caine come amministratore in data 08 mar 2022

    1 pagineTM01
    XAZCH27U

    Cessazione della carica di Collin Roy Abert come amministratore in data 08 mar 2022

    1 pagineTM01
    XAZCH25E

    Indirizzo della sede legale modificato da 60 Great Portland Street London W1W 7RT a 75 Bermondsey Street London SE1 3XF in data 08 mar 2022

    1 pagineAD01
    XAZCH25A

    Chi sono gli amministratori di MHP COMMUNICATIONS LIMITED?

    Amministratori
    NomeNominato ilDimissioni ilRuoloIndirizzoIdentificazione della societàPaese di residenzaNazionalitàData di nascitaProfessioneNumero
    SANFORD, Mark John
    Great Portland Street
    W1W 7RT London
    60w
    England
    Segretario
    Great Portland Street
    W1W 7RT London
    60w
    England
    295499510001
    HARRIS, Peter Jonathan
    Great Portland Street
    W1W 7RT London
    60w
    England
    Amministratore
    Great Portland Street
    W1W 7RT London
    60w
    England
    EnglandBritishChief Financial Officer40917640001
    PEACHEY, Jonathan Andrew
    Great Portland Street
    W1W 7RT London
    60w
    England
    Amministratore
    Great Portland Street
    W1W 7RT London
    60w
    England
    EnglandBritishChief Operating Officer141274820001
    COLE, Mary Louise
    Great Portland Street
    W1W 7RT London
    60
    Segretario
    Great Portland Street
    W1W 7RT London
    60
    177903200001
    EWING, Susanna
    Great Portland Street
    W1W 7RT London
    60
    Segretario
    Great Portland Street
    W1W 7RT London
    60
    156508470001
    HARRIS, Peter
    Great Portland Street
    W1W 7RT London
    60
    Segretario
    Great Portland Street
    W1W 7RT London
    60
    151524540001
    RUBEN, Stephen Michael
    16 Pickhurst Green
    BR2 7QT Bromley
    Segretario
    16 Pickhurst Green
    BR2 7QT Bromley
    British73290610004
    VAUGHAN, Mervyn John
    The Old Mill
    Park Road
    BA4 5BS Shepton Mallet
    Somerset
    Segretario
    The Old Mill
    Park Road
    BA4 5BS Shepton Mallet
    Somerset
    British4830930001
    WOOD, Emma Louise
    Great Portland Street
    W1W 7RT London
    60w
    England
    Segretario
    Great Portland Street
    W1W 7RT London
    60w
    England
    293364200001
    ABERT, Collin Roy
    N Michigan Ave
    Ste 3900
    60611 Chicago
    676
    United States
    Amministratore
    N Michigan Ave
    Ste 3900
    60611 Chicago
    676
    United States
    United StatesAmericanPrivate Equity246023210001
    BENDER, Brian Geoffrey, Sir
    Rosendale Road
    SE21 8HE London
    137
    Uk
    Amministratore
    Rosendale Road
    SE21 8HE London
    137
    Uk
    United KingdomBritishNone67196140001
    BIRTWISTLE, Michael David John
    Great Portland Street
    W1D 7RT London
    60
    Amministratore
    Great Portland Street
    W1D 7RT London
    60
    United KingdomBritishConsultant140365820001
    BISS, Adele
    7 Elsworthy Road
    NW3 3DS London
    Amministratore
    7 Elsworthy Road
    NW3 3DS London
    EnglandBritishDirector4429990001
    CAINE, Paul Jason
    West 43rd Street
    Floor 8
    10036 New York
    229
    Ny
    United States
    Amministratore
    West 43rd Street
    Floor 8
    10036 New York
    229
    Ny
    United States
    United StatesAmericanCompany Director246023770001
    COLLINS, Antonia Gay
    South Cadbury
    BA22 7HA Yeovil
    South Cadbury House
    Somerset
    Amministratore
    South Cadbury
    BA22 7HA Yeovil
    South Cadbury House
    Somerset
    UkBritishFinancial Pr165151170001
    COWARD, Nicholas Ian
    340 Old Ford Road
    E3 5TA London
    Amministratore
    340 Old Ford Road
    E3 5TA London
    United KingdomBritishDirector60192140002
    DAVIES, Roger Oliver
    7 Elsworthy Road
    NW3 3DS London
    Amministratore
    7 Elsworthy Road
    NW3 3DS London
    United KingdomBritishDirector13540001
    DAY, Ian Philip
    5b Bury Lane
    Codicote
    SG4 8XX Hitchin
    Hertfordshire
    Amministratore
    5b Bury Lane
    Codicote
    SG4 8XX Hitchin
    Hertfordshire
    EnglandBritishDirector74800310002
    DESHMUKH, Sacha Shisheer
    262d Finchley Road
    NW3 7AA London
    Amministratore
    262d Finchley Road
    NW3 7AA London
    EnglandBritishDirector72077120001
    DEVINE, Gavin Richard
    Grosvenor Road
    W4 4EG London
    44
    Amministratore
    Grosvenor Road
    W4 4EG London
    44
    United KingdomBritishDirector105528610002
    DIAMOND, Lawrence Jeffrey
    West 43rd Street
    Floor 8
    10036 New York
    229
    Ny
    United States
    Amministratore
    West 43rd Street
    Floor 8
    10036 New York
    229
    Ny
    United States
    United StatesAmericanChief Financial Officer246641140001
    HARRIS, Peter Jonathan
    Great Portland Street
    W1W 7RT London
    60
    Amministratore
    Great Portland Street
    W1W 7RT London
    60
    EnglandBritishDirector40917640001
    HOWARD, Jane Alison
    121 Ridgway
    Wimbledon Village
    SW19 4RE London
    Amministratore
    121 Ridgway
    Wimbledon Village
    SW19 4RE London
    EnglandBritishChairman51904570002
    JAQUES, Andrew Gavin
    Langthorne Street
    SW6 6JT London
    15
    Amministratore
    Langthorne Street
    SW6 6JT London
    15
    EnglandBritishPr Consultant157090310001
    KLEIN, Deborah
    Great Portland Street
    W1W 7RT London
    60
    Amministratore
    Great Portland Street
    W1W 7RT London
    60
    United KingdomBritishChief Executive104574070001
    LEVER, Christopher John
    Flat 504
    25 Dorset Square
    NW1 6QG London
    Amministratore
    Flat 504
    25 Dorset Square
    NW1 6QG London
    BritishFinance Director108850600001
    LEWIS, Deborah Jane
    27 Elthiron Road
    SW6 4BP London
    Amministratore
    27 Elthiron Road
    SW6 4BP London
    United KingdomBritishManaging Director51904510003
    MARTIN, Ashley Graham
    Great Portland Street
    W1W 7RT London
    60
    Amministratore
    Great Portland Street
    W1W 7RT London
    60
    United KingdomBritishFinance Director169305720001
    MATTHEWS, Christopher Wynne
    Hawksfold Stables
    Hawksfold Lane West
    GU27 3NT Fernhurst
    West Sussex
    Amministratore
    Hawksfold Stables
    Hawksfold Lane West
    GU27 3NT Fernhurst
    West Sussex
    United KingdomBritishCompany Director35887470006
    MOFFATT, James Nicholas Peter
    Great Portland Street
    W1W 7RT London
    60
    United Kingdom
    Amministratore
    Great Portland Street
    W1W 7RT London
    60
    United Kingdom
    United KingdomBritishCeo158034000001
    NICOLLS, Andrew Darsie
    The Common
    W5 3TR London
    16
    United Kingdom
    Amministratore
    The Common
    W5 3TR London
    16
    United Kingdom
    United KingdomBritishPr Consultant54787500004
    PAYTON, Tim
    Harringay Road
    N15 3HP London
    181
    Amministratore
    Harringay Road
    N15 3HP London
    181
    EnglandBritishDirector130747940001
    ROJAS, James Kenneth, Mr.
    60 Great Portland Street
    W1W 7RT London
    Engine
    England
    Amministratore
    60 Great Portland Street
    W1W 7RT London
    Engine
    England
    United StatesAmericanCfo208189170001
    RUBEN, Stephen Michael
    16 Pickhurst Green
    BR2 7QT Bromley
    Amministratore
    16 Pickhurst Green
    BR2 7QT Bromley
    United KingdomBritishDirector73290610004
    SCOTT, Peter John
    9 Pelham Crescent
    South Kensington
    SW7 2NP London
    Middlesex
    Amministratore
    9 Pelham Crescent
    South Kensington
    SW7 2NP London
    Middlesex
    EnglandBritishDirector97249440006

    Chi sono le persone con controllo significativo di MHP COMMUNICATIONS LIMITED?

    Persone con controllo significativo
    NomeNotificato ilIndirizzoCessato
    Great Portland Street
    W1W 7RT London
    60
    United Kingdom
    06 apr 2016
    Great Portland Street
    W1W 7RT London
    60
    United Kingdom
    No
    Forma giuridicaLimited By Shares
    Paese di registrazioneEngland And Wales
    Autorità legaleUnited Kingdom (England And Wales)
    Luogo di registrazioneCompanies House
    Numero di registrazione05015446
    Natura del controllo
    • La persona possiede, direttamente o indirettamente, più del 75% delle azioni della società.
    • La persona detiene, direttamente o indirettamente, più del 75% dei diritti di voto nella società.
    • La persona ha il diritto, direttamente o indirettamente, di nominare o rimuovere la maggioranza del consiglio di amministrazione della società.

    MHP COMMUNICATIONS LIMITED ha ipoteche?

    Ipoteche
    ClassificazioneDateStatoDettagli
    A registered charge
    Creato il 26 lug 2013
    Consegnato il 31 lug 2013
    Soddisfatta integralmente
    Breve descrizione
    Notification of addition to or amendment of charge.
    L'ipoteca flottante copre tutto:
    Contiene un'ipoteca flottante:
    Contiene un'ipoteca fissa:
    Persone aventi diritto
    • Incap Finance B.V.
    Transazioni
    • 31 lug 2013Registrazione di un'ipoteca (MR01)
    • 09 set 2014Soddisfazione di un'ipoteca (MR04)
    A registered charge
    Creato il 22 apr 2013
    Consegnato il 29 apr 2013
    Soddisfatta integralmente
    Contiene un'ipoteca fissa:
    Persone aventi diritto
    • Barclays Bank PLC
    Transazioni
    • 29 apr 2013Registrazione di un'ipoteca (MR01)
    • 09 set 2014Soddisfazione di un'ipoteca (MR04)
    Debenture
    Creato il 20 mag 2011
    Consegnato il 04 giu 2011
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from each chargor to the finance parties (or any of them) on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery see image for full details.
    Persone aventi diritto
    • The Governor & Company of the Bank of Ireland
    Transazioni
    • 04 giu 2011Registrazione di un'ipoteca (MG01)
    • 09 set 2014Soddisfazione di un'ipoteca (MR04)
    Deed of accession
    Creato il 05 mar 2008
    Consegnato il 07 mar 2008
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from each chargor to the finance parties (or any of them) on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery see image for full details.
    Persone aventi diritto
    • Governor and Company of the Bank of Ireland (The Security Trustee)
    Transazioni
    • 07 mar 2008Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 24 mag 2011Dichiarazione che parte o tutta la proprietà gravata è stata liberata (MG04)
    • 09 set 2014Soddisfazione di un'ipoteca (MR04)
    Debenture
    Creato il 11 nov 2005
    Consegnato il 25 nov 2005
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill, book debts, uncalled capital, fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • The Governor and Company of the Bank of Ireland
    Transazioni
    • 25 nov 2005Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 11 mar 2008Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Lease security assignemnt & charge
    Creato il 29 mar 1985
    Consegnato il 19 apr 1985
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of a loan agreement & a lease agreement both dated 29.3.85
    Brevi particolari
    All rights title benefit and interest of the company in & to a lease agreement dated 29.3.85. all the equipment & goods and the proceeds thereof (see doc M9).
    Persone aventi diritto
    • Adele Sophie Biss
    Transazioni
    • 19 apr 1985Registrazione di un'ipoteca
    • 16 nov 2005Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Lease security assignment & charge
    Creato il 29 mar 1985
    Consegnato il 19 apr 1985
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of a loan agreement & a lease agreement both dated 29.3.85
    Brevi particolari
    All rights title benefit and interest of the company in & to a lease agreement dated 29.3.85. all the equipment & goods and the proceeds thereof (see doc M8).
    Persone aventi diritto
    • Adele Sophie Biss
    Transazioni
    • 19 apr 1985Registrazione di un'ipoteca
    • 16 nov 2005Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Lease security assignment & charge
    Creato il 29 mar 1985
    Consegnato il 19 apr 1985
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of a loan agreement & a lease agreement both dated 29.03.85
    Brevi particolari
    All rights title benefit and interest of the company in & to a lease agreement dated 29.3.85. all the equipment & goods and the proceeds thereof (see doc M7).
    Persone aventi diritto
    • Adele Sophie Biss
    Transazioni
    • 19 apr 1985Registrazione di un'ipoteca
    • 16 nov 2005Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)

    Fonte dati

    • Companies House del Regno Unito
      Il registro ufficiale delle imprese nel Regno Unito, che fornisce l'accesso pubblico alle informazioni sulle imprese, come nomi, indirizzi, amministratori e depositi finanziari.
    • Licenza: CC0