MHP COMMUNICATIONS LIMITED
Panoramica
Nome della società | MHP COMMUNICATIONS LIMITED |
---|---|
Stato della società | Sciolta |
Forma giuridica | Società a responsabilità limitata |
Numero di società | 01855944 |
Giurisdizione | Inghilterra/Galles |
Data di costituzione | |
Data di cessazione |
Riepilogo
Ha PSCs super sicuri | No |
---|---|
Ha ipoteche | Sì |
Ha una storia di insolvenza | No |
La sede legale è in contestazione | No |
Qual è lo scopo di MHP COMMUNICATIONS LIMITED?
- Società inattiva (99999) / Attività di organizzazioni ed organismi extraterritoriali
Dove si trova MHP COMMUNICATIONS LIMITED?
Indirizzo della sede legale | 60w Great Portland Street W1W 7RT London England |
---|---|
Indirizzo della sede legale non recapitabile | No |
Quali erano i nomi precedenti di MHP COMMUNICATIONS LIMITED?
Nome della società | Da | A |
---|---|---|
MANDATE COMMUNICATIONS LIMITED | 21 nov 2007 | 21 nov 2007 |
A S BISS AND COMPANY LIMITED | 01 apr 2004 | 01 apr 2004 |
EMBOROUGH LIMITED | 19 ago 1988 | 19 ago 1988 |
EMBOROUGH LEASING LIMITED | 16 ott 1984 | 16 ott 1984 |
Quali sono gli ultimi bilanci di MHP COMMUNICATIONS LIMITED?
Ultimi bilanci | |
---|---|
Ultimi bilanci redatti al | 31 dic 2022 |
Quali sono le ultime deposizioni per MHP COMMUNICATIONS LIMITED?
Data | Descrizione | Documento | Tipo | |
---|---|---|---|---|
Gazzetta Ufficiale finale sciolta per scioglimento volontario | 1 pagine | GAZ2(A) | ||
Prima Gazzetta Ufficiale per lo scioglimento volontario | 1 pagine | GAZ1(A) | ||
Richiesta di cancellazione della società dal registro | 1 pagine | DS01 | ||
Bilancio di società controllata esente da revisione redatto al 31 dic 2022 | 12 pagine | AA | ||
legacy | 214 pagine | PARENT_ACC | ||
legacy | 3 pagine | GUARANTEE2 | ||
legacy | 1 pagine | AGREEMENT2 | ||
Dichiarazione di conformità presentata il 01 giu 2023 senza aggiornamenti | 3 pagine | CS01 | ||
Conto per una società dormiente redatto al 31 dic 2021 | 8 pagine | AA | ||
legacy | 53 pagine | PARENT_ACC | ||
legacy | 3 pagine | GUARANTEE2 | ||
legacy | 1 pagine | AGREEMENT2 | ||
Dichiarazione di conformità presentata il 31 dic 2022 senza aggiornamenti | 3 pagine | CS01 | ||
Nomina di Mr Mark John Sanford come segretario in data 30 apr 2022 | 2 pagine | AP03 | ||
Cessazione della carica di Emma Louise Wood come segretario in data 30 apr 2022 | 1 pagine | TM02 | ||
Indirizzo della sede legale modificato da 75 Bermondsey Street London SE1 3XF England a 60W Great Portland Street London W1W 7RT in data 05 mag 2022 | 1 pagine | AD01 | ||
Ritiro della richiesta di cancellazione della società | 1 pagine | DS02 | ||
Nomina di Mr Jonathan Andrew Peachey come amministratore in data 08 mar 2022 | 2 pagine | AP01 | ||
Nomina di Mr Peter Jonathan Harris come amministratore in data 08 mar 2022 | 2 pagine | AP01 | ||
Cessazione della carica di William Michael Thompson come amministratore in data 08 mar 2022 | 1 pagine | TM01 | ||
Nomina di Emma Louise Wood come segretario in data 08 mar 2022 | 2 pagine | AP03 | ||
Cessazione della carica di Lawrence Jeffrey Diamond come amministratore in data 08 mar 2022 | 1 pagine | TM01 | ||
Cessazione della carica di Paul Jason Caine come amministratore in data 08 mar 2022 | 1 pagine | TM01 | ||
Cessazione della carica di Collin Roy Abert come amministratore in data 08 mar 2022 | 1 pagine | TM01 | ||
Indirizzo della sede legale modificato da 60 Great Portland Street London W1W 7RT a 75 Bermondsey Street London SE1 3XF in data 08 mar 2022 | 1 pagine | AD01 | ||
Chi sono gli amministratori di MHP COMMUNICATIONS LIMITED?
Nome | Nominato il | Dimissioni il | Ruolo | Indirizzo | Identificazione della società | Paese di residenza | Nazionalità | Data di nascita | Professione | Numero |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SANFORD, Mark John | Segretario | Great Portland Street W1W 7RT London 60w England | 295499510001 | |||||||
HARRIS, Peter Jonathan | Amministratore | Great Portland Street W1W 7RT London 60w England | England | British | Chief Financial Officer | 40917640001 | ||||
PEACHEY, Jonathan Andrew | Amministratore | Great Portland Street W1W 7RT London 60w England | England | British | Chief Operating Officer | 141274820001 | ||||
COLE, Mary Louise | Segretario | Great Portland Street W1W 7RT London 60 | 177903200001 | |||||||
EWING, Susanna | Segretario | Great Portland Street W1W 7RT London 60 | 156508470001 | |||||||
HARRIS, Peter | Segretario | Great Portland Street W1W 7RT London 60 | 151524540001 | |||||||
RUBEN, Stephen Michael | Segretario | 16 Pickhurst Green BR2 7QT Bromley | British | 73290610004 | ||||||
VAUGHAN, Mervyn John | Segretario | The Old Mill Park Road BA4 5BS Shepton Mallet Somerset | British | 4830930001 | ||||||
WOOD, Emma Louise | Segretario | Great Portland Street W1W 7RT London 60w England | 293364200001 | |||||||
ABERT, Collin Roy | Amministratore | N Michigan Ave Ste 3900 60611 Chicago 676 United States | United States | American | Private Equity | 246023210001 | ||||
BENDER, Brian Geoffrey, Sir | Amministratore | Rosendale Road SE21 8HE London 137 Uk | United Kingdom | British | None | 67196140001 | ||||
BIRTWISTLE, Michael David John | Amministratore | Great Portland Street W1D 7RT London 60 | United Kingdom | British | Consultant | 140365820001 | ||||
BISS, Adele | Amministratore | 7 Elsworthy Road NW3 3DS London | England | British | Director | 4429990001 | ||||
CAINE, Paul Jason | Amministratore | West 43rd Street Floor 8 10036 New York 229 Ny United States | United States | American | Company Director | 246023770001 | ||||
COLLINS, Antonia Gay | Amministratore | South Cadbury BA22 7HA Yeovil South Cadbury House Somerset | Uk | British | Financial Pr | 165151170001 | ||||
COWARD, Nicholas Ian | Amministratore | 340 Old Ford Road E3 5TA London | United Kingdom | British | Director | 60192140002 | ||||
DAVIES, Roger Oliver | Amministratore | 7 Elsworthy Road NW3 3DS London | United Kingdom | British | Director | 13540001 | ||||
DAY, Ian Philip | Amministratore | 5b Bury Lane Codicote SG4 8XX Hitchin Hertfordshire | England | British | Director | 74800310002 | ||||
DESHMUKH, Sacha Shisheer | Amministratore | 262d Finchley Road NW3 7AA London | England | British | Director | 72077120001 | ||||
DEVINE, Gavin Richard | Amministratore | Grosvenor Road W4 4EG London 44 | United Kingdom | British | Director | 105528610002 | ||||
DIAMOND, Lawrence Jeffrey | Amministratore | West 43rd Street Floor 8 10036 New York 229 Ny United States | United States | American | Chief Financial Officer | 246641140001 | ||||
HARRIS, Peter Jonathan | Amministratore | Great Portland Street W1W 7RT London 60 | England | British | Director | 40917640001 | ||||
HOWARD, Jane Alison | Amministratore | 121 Ridgway Wimbledon Village SW19 4RE London | England | British | Chairman | 51904570002 | ||||
JAQUES, Andrew Gavin | Amministratore | Langthorne Street SW6 6JT London 15 | England | British | Pr Consultant | 157090310001 | ||||
KLEIN, Deborah | Amministratore | Great Portland Street W1W 7RT London 60 | United Kingdom | British | Chief Executive | 104574070001 | ||||
LEVER, Christopher John | Amministratore | Flat 504 25 Dorset Square NW1 6QG London | British | Finance Director | 108850600001 | |||||
LEWIS, Deborah Jane | Amministratore | 27 Elthiron Road SW6 4BP London | United Kingdom | British | Managing Director | 51904510003 | ||||
MARTIN, Ashley Graham | Amministratore | Great Portland Street W1W 7RT London 60 | United Kingdom | British | Finance Director | 169305720001 | ||||
MATTHEWS, Christopher Wynne | Amministratore | Hawksfold Stables Hawksfold Lane West GU27 3NT Fernhurst West Sussex | United Kingdom | British | Company Director | 35887470006 | ||||
MOFFATT, James Nicholas Peter | Amministratore | Great Portland Street W1W 7RT London 60 United Kingdom | United Kingdom | British | Ceo | 158034000001 | ||||
NICOLLS, Andrew Darsie | Amministratore | The Common W5 3TR London 16 United Kingdom | United Kingdom | British | Pr Consultant | 54787500004 | ||||
PAYTON, Tim | Amministratore | Harringay Road N15 3HP London 181 | England | British | Director | 130747940001 | ||||
ROJAS, James Kenneth, Mr. | Amministratore | 60 Great Portland Street W1W 7RT London Engine England | United States | American | Cfo | 208189170001 | ||||
RUBEN, Stephen Michael | Amministratore | 16 Pickhurst Green BR2 7QT Bromley | United Kingdom | British | Director | 73290610004 | ||||
SCOTT, Peter John | Amministratore | 9 Pelham Crescent South Kensington SW7 2NP London Middlesex | England | British | Director | 97249440006 |
Chi sono le persone con controllo significativo di MHP COMMUNICATIONS LIMITED?
Nome | Notificato il | Indirizzo | Cessato | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
The Engine Group Limited | 06 apr 2016 | Great Portland Street W1W 7RT London 60 United Kingdom | No | ||||||||||
| |||||||||||||
Natura del controllo
|
MHP COMMUNICATIONS LIMITED ha ipoteche?
Classificazione | Date | Stato | Dettagli | |
---|---|---|---|---|
A registered charge | Creato il 26 lug 2013 Consegnato il 31 lug 2013 | Soddisfatta integralmente | ||
Breve descrizione Notification of addition to or amendment of charge. L'ipoteca flottante copre tutto: Sì Contiene un'ipoteca flottante: Sì Contiene un'ipoteca fissa: Sì | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
A registered charge | Creato il 22 apr 2013 Consegnato il 29 apr 2013 | Soddisfatta integralmente | ||
Contiene un'ipoteca fissa: Sì | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
Debenture | Creato il 20 mag 2011 Consegnato il 04 giu 2011 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due or to become due from each chargor to the finance parties (or any of them) on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Brevi particolari Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery see image for full details. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
Deed of accession | Creato il 05 mar 2008 Consegnato il 07 mar 2008 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due or to become due from each chargor to the finance parties (or any of them) on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Brevi particolari Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery see image for full details. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
Debenture | Creato il 11 nov 2005 Consegnato il 25 nov 2005 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Brevi particolari Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill, book debts, uncalled capital, fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
Lease security assignemnt & charge | Creato il 29 mar 1985 Consegnato il 19 apr 1985 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of a loan agreement & a lease agreement both dated 29.3.85 | |
Brevi particolari All rights title benefit and interest of the company in & to a lease agreement dated 29.3.85. all the equipment & goods and the proceeds thereof (see doc M9). | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
Lease security assignment & charge | Creato il 29 mar 1985 Consegnato il 19 apr 1985 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of a loan agreement & a lease agreement both dated 29.3.85 | |
Brevi particolari All rights title benefit and interest of the company in & to a lease agreement dated 29.3.85. all the equipment & goods and the proceeds thereof (see doc M8). | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
Lease security assignment & charge | Creato il 29 mar 1985 Consegnato il 19 apr 1985 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of a loan agreement & a lease agreement both dated 29.03.85 | |
Brevi particolari All rights title benefit and interest of the company in & to a lease agreement dated 29.3.85. all the equipment & goods and the proceeds thereof (see doc M7). | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
|
Fonte dati
- Companies House del Regno Unito
Il registro ufficiale delle imprese nel Regno Unito, che fornisce l'accesso pubblico alle informazioni sulle imprese, come nomi, indirizzi, amministratori e depositi finanziari. - Licenza: CC0