ABERDEEN EXHIBITION AND CONFERENCE CENTRE LIMITED

ABERDEEN EXHIBITION AND CONFERENCE CENTRE LIMITED

  • Panoramica
  • Riepilogo
  • Scopo
  • Indirizzo
  • Denominazioni precedenti
  • Bilanci
  • Deposizioni
  • Amministratori
  • Persone con controllo significativo
  • Ipoteche
  • Fonte dati
  • Panoramica

    Nome della societàABERDEEN EXHIBITION AND CONFERENCE CENTRE LIMITED
    Stato della societàSciolta
    Forma giuridicaSocietà a responsabilità limitata
    Numero di società 01858349
    GiurisdizioneInghilterra/Galles
    Data di costituzione
    Data di cessazione

    Qual è lo scopo di ABERDEEN EXHIBITION AND CONFERENCE CENTRE LIMITED?

    • Altre attività di servizi n.c.a. (96090) / Altre attività di servizi

    Dove si trova ABERDEEN EXHIBITION AND CONFERENCE CENTRE LIMITED?

    Indirizzo della sede legale
    City Point
    One Ropemaker Street
    EC2Y 9SS London
    Indirizzo della sede legale non recapitabileNo

    Quali erano i nomi precedenti di ABERDEEN EXHIBITION AND CONFERENCE CENTRE LIMITED?

    Denominazioni sociali precedenti
    Nome della societàDaA
    ZONEFLEET LIMITED25 ott 198425 ott 1984

    Quali sono gli ultimi bilanci di ABERDEEN EXHIBITION AND CONFERENCE CENTRE LIMITED?

    Ultimi bilanci
    Ultimi bilanci redatti al31 mar 2017

    Quali sono le ultime deposizioni per ABERDEEN EXHIBITION AND CONFERENCE CENTRE LIMITED?

    Deposizioni
    DataDescrizioneDocumentoTipo

    Gazzetta Ufficiale finale sciolta per scioglimento volontario

    1 pagineGAZ2(A)

    Prima Gazzetta Ufficiale per lo scioglimento volontario

    1 pagineGAZ1(A)

    Richiesta di cancellazione della società dal registro

    3 pagineDS01

    Dichiarazione di conformità presentata il 12 feb 2018 senza aggiornamenti

    3 pagineCS01

    Bilancio redatto al 31 mar 2017

    28 pagineAA

    Cessazione della carica di Graeme Alexander Cumming come amministratore in data 30 giu 2017

    1 pagineTM01

    Nomina di Mr Alan James Donnelly come amministratore in data 13 giu 2017

    2 pagineAP01

    Nomina di Mr John Michael Reynolds come amministratore in data 17 mag 2017

    2 pagineAP01

    Cessazione della carica di John Michael Reynolds come amministratore in data 04 mag 2017

    1 pagineTM01

    Cessazione della carica di Aileen Jacqueline Malone come amministratore in data 04 mag 2017

    1 pagineTM01

    Cessazione della carica di Barney Crockett come amministratore in data 04 mag 2017

    1 pagineTM01

    Cessazione della carica di Alan James Donnelly come amministratore in data 04 mag 2017

    1 pagineTM01

    Cessazione della carica di Louise Lonie come amministratore in data 31 mar 2017

    1 pagineTM01

    Cessazione della carica di Geoffrey David Runcie come amministratore in data 31 mar 2017

    1 pagineTM01

    Cessazione della carica di John Watson come amministratore in data 31 mar 2017

    1 pagineTM01

    Cessazione della carica di Fiona Elaine Mann come amministratore in data 31 mar 2017

    1 pagineTM01

    Cessazione della carica di Edwin Andrew Gillespie come amministratore in data 01 apr 2017

    1 pagineTM01

    Cessazione della carica di Elaine Hulse come amministratore in data 31 mar 2017

    1 pagineTM01

    Dichiarazione di conformità presentata il 12 feb 2017 con aggiornamenti

    5 pagineCS01

    Bilancio redatto al 31 mar 2016

    32 pagineAA

    Dettagli del direttore cambiati per Mr James Alan Donnelly il 02 mar 2016

    2 pagineCH01

    Cessazione della carica di Carol Margaret Benzie come amministratore in data 07 ott 2016

    1 pagineTM01

    Soddisfazione dell'onere 5 in pieno

    4 pagineMR04

    Soddisfazione dell'onere 8 in pieno

    4 pagineMR04

    Bilancio annuale redatto al 12 feb 2016 con elenco completo degli azionisti

    16 pagineAR01
    Deposizioni associate
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    capital16 feb 2016

    Stato del capitale al 16 feb 2016

    • Capitale: GBP 30,064,999
    SH01

    Chi sono gli amministratori di ABERDEEN EXHIBITION AND CONFERENCE CENTRE LIMITED?

    Amministratori
    NomeNominato ilDimissioni ilRuoloIndirizzoIdentificazione della societàPaese di residenzaNazionalitàData di nascitaProfessioneNumero
    STRONACHS SECRETARIES LIMITED
    Albyn Place
    AB10 1FW Aberdeen
    34
    Aberdeenshire
    Segretario
    Albyn Place
    AB10 1FW Aberdeen
    34
    Aberdeenshire
    129592570001
    DONNELLY, Alan James
    Town House
    Broad Street
    AB10 1FY Aberdeen
    Aberdeen City Council
    United Kingdom
    Amministratore
    Town House
    Broad Street
    AB10 1FY Aberdeen
    Aberdeen City Council
    United Kingdom
    ScotlandBritish56793050002
    REYNOLDS, John Michael
    Newburgh Circle
    Bridge Of Don
    AB22 8XB Aberdeen
    100
    Grampian
    United Kingdom
    Amministratore
    Newburgh Circle
    Bridge Of Don
    AB22 8XB Aberdeen
    100
    Grampian
    United Kingdom
    ScotlandBritish39568820001
    ALLAN, David Martin
    Millfield
    Inchbare
    DD9 7QJ Edzell
    Angus
    Segretario
    Millfield
    Inchbare
    DD9 7QJ Edzell
    Angus
    British41797230003
    STRONACHS
    34 Albyn Place
    AB10 1FW Aberdeen
    Aberdeenshire
    Segretario
    34 Albyn Place
    AB10 1FW Aberdeen
    Aberdeenshire
    50482710001
    BENZIE, Carol Margaret
    Swailend
    Newmachar
    AB21 7UU Aberdeen
    Lilac Cottage
    Aberdeenshire
    United Kingdom
    Amministratore
    Swailend
    Newmachar
    AB21 7UU Aberdeen
    Lilac Cottage
    Aberdeenshire
    United Kingdom
    ScotlandBritish161586490001
    BISSET, Raymond George
    The Schoolhouse
    Keith Hall
    AB51 0LX Inverurie
    Aberdeenshire
    Amministratore
    The Schoolhouse
    Keith Hall
    AB51 0LX Inverurie
    Aberdeenshire
    British49635290001
    BLACKMAN, Kirsty
    Laurelwood Avenue
    AB25 3SL Aberdeen
    28
    Aberdeenshire
    Scotland
    Amministratore
    Laurelwood Avenue
    AB25 3SL Aberdeen
    28
    Aberdeenshire
    Scotland
    British138446130002
    CAMERON, David John, Lord Provost
    Town House
    Broad Street
    AB10 1FY Aberdeen
    Aberdeen City Council
    United Kingdom
    Amministratore
    Town House
    Broad Street
    AB10 1FY Aberdeen
    Aberdeen City Council
    United Kingdom
    ScotlandBritish1374270003
    CASSIE, George Scott
    70 Garthdee Road
    AB1 7AR Aberdeen
    Aberdeenshire
    Amministratore
    70 Garthdee Road
    AB1 7AR Aberdeen
    Aberdeenshire
    ScotlandBritish1116550001
    CLARK, Ronald
    134 Victoria Street
    Dyce
    AB21 7BE Aberdeen
    Aberdeenshire
    Amministratore
    134 Victoria Street
    Dyce
    AB21 7BE Aberdeen
    Aberdeenshire
    British65220090001
    CLARK, Ronald
    134 Victoria Street
    Dyce
    AB21 7BE Aberdeen
    Aberdeenshire
    Amministratore
    134 Victoria Street
    Dyce
    AB21 7BE Aberdeen
    Aberdeenshire
    British65220090001
    CLYNE, David Elmslie, Councillor
    164 Gardner Drive
    AB12 5SA Aberdeen
    Amministratore
    164 Gardner Drive
    AB12 5SA Aberdeen
    British93547050001
    CLYNE, David Elmslie, Councillor
    164 Gardner Drive
    AB12 5SA Aberdeen
    Amministratore
    164 Gardner Drive
    AB12 5SA Aberdeen
    British93547050001
    CROCKETT, Barney, Councillor
    Bankhead Avenue
    Bucksburn
    AB21 9ET Aberdeen
    Woodville
    Aberdeenshire
    Amministratore
    Bankhead Avenue
    Bucksburn
    AB21 9ET Aberdeen
    Woodville
    Aberdeenshire
    ScotlandBritish125037060001
    CUMMING, Graeme Alexander
    Logie Coldstone
    AB34 5PR Aboyne
    Corblelack
    United Kingdom
    Amministratore
    Logie Coldstone
    AB34 5PR Aboyne
    Corblelack
    United Kingdom
    ScotlandBritish121595860002
    DEAN, Katharine Mary, Councillor
    48 Dunlin Road
    Cove Bay
    AB12 3WD Aberdeen
    Amministratore
    48 Dunlin Road
    Cove Bay
    AB12 3WD Aberdeen
    United KingdomBritish92457090001
    DONNELLY, Alan James
    Town House
    Broad Street
    AB10 1FY Aberdeen
    Aberdeen City Council
    United Kingdom
    Amministratore
    Town House
    Broad Street
    AB10 1FY Aberdeen
    Aberdeen City Council
    United Kingdom
    ScotlandBritish56793050002
    DUNCAN, Matthew Robert
    2 Beaconhill Road
    Milltimber
    AB13 0JR Aberdeen
    Amministratore
    2 Beaconhill Road
    Milltimber
    AB13 0JR Aberdeen
    British93547140001
    EDWARDS, Gordon Normandale
    44 Hammerfield Avenue
    AB10 7FJ Aberdeen
    Amministratore
    44 Hammerfield Avenue
    AB10 7FJ Aberdeen
    ScotlandBritish77338910001
    FINDLAY, Audrey Margaret
    26 Kinmundy Green
    Westhill
    AB32 6SF Aberdeen
    Amministratore
    26 Kinmundy Green
    Westhill
    AB32 6SF Aberdeen
    UkBritish102892980001
    FLETCHER, Neil Derek
    14 Cairncry Terrace
    AB16 5JZ Aberdeen
    Grampian
    Amministratore
    14 Cairncry Terrace
    AB16 5JZ Aberdeen
    Grampian
    ScotlandBritish92456990001
    GILLESPIE, Edwin Andrew
    Muiryfold
    Newmachar
    AB21 7UU Aberdeen
    Amministratore
    Muiryfold
    Newmachar
    AB21 7UU Aberdeen
    ScotlandBritish63626350001
    HORSBURGH, Brian William
    Urquhart Road
    AB24 5AU Aberdeen
    130
    United Kingdom
    Amministratore
    Urquhart Road
    AB24 5AU Aberdeen
    130
    United Kingdom
    United KingdomBritish149682660003
    HULSE, Elaine
    Fairfield Road
    RH19 4HG East Grinstead
    6 Aspen Court
    W Sussex
    Amministratore
    Fairfield Road
    RH19 4HG East Grinstead
    6 Aspen Court
    W Sussex
    EnglandBritish86453120002
    HUTCHEON, Raymond William
    Corsehill Croft
    Parkhill Newmachar
    AB21 7XA Aberdeen
    Amministratore
    Corsehill Croft
    Parkhill Newmachar
    AB21 7XA Aberdeen
    ScotlandBritish538670001
    IRONSIDE, Leonard, Cllr
    239 North Anderson Drive
    AB16 7GR Aberdeen
    Aberdeenshire
    Amministratore
    239 North Anderson Drive
    AB16 7GR Aberdeen
    Aberdeenshire
    British122608160001
    IRONSIDE, Leonard
    42 Hillside Terrace
    Portlethen
    AB1 4QG Aberdeen
    Aberdeenshire
    Uk
    Amministratore
    42 Hillside Terrace
    Portlethen
    AB1 4QG Aberdeen
    Aberdeenshire
    Uk
    ScotlandBritish191955550001
    KEMP, Rhona
    9 Lomond Crescent
    AB41 9GE Ellon
    Aberdeenshire
    Amministratore
    9 Lomond Crescent
    AB41 9GE Ellon
    Aberdeenshire
    ScotlandBritish24375300001
    LAMOND, James Alexander
    15 Belvidere Street
    AB25 2QS Aberdeen
    Aberdeenshire
    Amministratore
    15 Belvidere Street
    AB25 2QS Aberdeen
    Aberdeenshire
    British53875770001
    LIDDELL, John Chalmers
    189 Westburn Road
    AB2 4QE Aberdeen
    Aberdeenshire
    Amministratore
    189 Westburn Road
    AB2 4QE Aberdeen
    Aberdeenshire
    British48725970001
    LONIE, Louise
    Conference Way
    Bridge Of Don
    AB23 8BL Aberdeen
    Aecc
    United Kingdom
    Amministratore
    Conference Way
    Bridge Of Don
    AB23 8BL Aberdeen
    Aecc
    United Kingdom
    ScotlandBritish196917240001
    MALONE, Aileen Jacqueline
    45 Hillview Road
    Cults
    AB15 9HA Aberdeen
    Amministratore
    45 Hillview Road
    Cults
    AB15 9HA Aberdeen
    British94403180001
    MANN, Fiona Elaine
    Bridge Of Don
    AB23 8LG Aberdeen
    Aberdeen Exhibition & Conference Centre
    United Kingdom
    Amministratore
    Bridge Of Don
    AB23 8LG Aberdeen
    Aberdeen Exhibition & Conference Centre
    United Kingdom
    United KingdomBritish176055810001
    MARKE, Christopher Philip Levelis
    71 Holmesdale Road
    TW11 9LQ Teddington
    Middlesex
    Amministratore
    71 Holmesdale Road
    TW11 9LQ Teddington
    Middlesex
    British524330001

    Chi sono le persone con controllo significativo di ABERDEEN EXHIBITION AND CONFERENCE CENTRE LIMITED?

    Persone con controllo significativo
    NomeNotificato ilIndirizzoCessato
    Aberdeen City Council
    Broad Street
    AB10 1AB Aberdeen
    Marischall College
    Scotland
    06 apr 2016
    Broad Street
    AB10 1AB Aberdeen
    Marischall College
    Scotland
    No
    Forma giuridicaA Local Authority Constituted And Incorporated Under The Local Government Etc. (Scotland) Act 1994
    Autorità legaleScots Law
    Natura del controllo
    • La persona possiede, direttamente o indirettamente, più del 75% delle azioni della società.
    • La persona detiene, direttamente o indirettamente, più del 75% dei diritti di voto nella società.
    • La persona ha il diritto, direttamente o indirettamente, di nominare o rimuovere la maggioranza del consiglio di amministrazione della società.

    ABERDEEN EXHIBITION AND CONFERENCE CENTRE LIMITED ha ipoteche?

    Ipoteche
    ClassificazioneDateStatoDettagli
    Standard security which was presented for registration in scotland on 25 may 2006 and
    Creato il 17 mag 2006
    Consegnato il 27 mag 2006
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    All and whole the chargor's interest in the ground lease of the subjects k/a and forming aberdeen exhibition and conference centre,bridge of don in the city and county of aberdeen. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Aberdeen City Council
    Transazioni
    • 27 mag 2006Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 07 giu 2016Soddisfazione di un'ipoteca (MR04)
    Debenture
    Creato il 17 mag 2006
    Consegnato il 23 mag 2006
    In corso
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    All the company's undertaking property assets and rights present and future of whatever mature and wherever situated.
    Persone aventi diritto
    • Aberdeen City Council
    Transazioni
    • 23 mag 2006Registrazione di un'ipoteca (395)
    Rental assignation
    Creato il 20 giu 2003
    Consegnato il 11 lug 2003
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee
    Brevi particolari
    The company's whole entitlement to receive from the tenants for the time being under the head-lease entered into by aberdeen exhibition and conference centre limited and aberdeen city council dated 11 april and 1 may 2003 as varied, supplemented and/or amended from time to time all rents and other sums payable now and in the future in terms of the headlease and all interest or payments on late payment and the whole amount of any future increase in rent and/or any other sums whether or not resulting from the provisions of the head lease or review thereof.. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • The Royal Bank of Scotland PLC
    Transazioni
    • 11 lug 2003Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 25 ott 2005Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    A standard security which was presented for registration in scotland on 28 august 2001 and
    Creato il 24 lug 2001
    Consegnato il 08 set 2001
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Ground lease of subjects at aberdeen exhibition and conference centre, bridge of don, aberdeen extending to 16.476 hectares or thereby.
    Persone aventi diritto
    • The Royal Bank of Scotland PLC
    Transazioni
    • 08 set 2001Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 07 giu 2005Dichiarazione che parte o tutta la proprietà di un onere fluttuante è stata liberata (403b)
    • 23 mag 2006Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    • 07 giu 2016Soddisfazione di un'ipoteca (MR04)
    Scottish assignation
    Creato il 15 mar 1995
    Consegnato il 29 mar 1995
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever under the assignation and under the agreement and/or any deed or document supplemental thereto
    Brevi particolari
    All right title interest & benefit in & to the letter of indemnity, any agreements or instruments etc. see the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Clydesdale Bank PLC
    Transazioni
    • 29 mar 1995Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 09 ago 2001Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Standard security
    Creato il 07 ott 1992
    Consegnato il 16 ott 1992
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee
    Brevi particolari
    Lease for 3 areas of ground extending to 10.40 acres,1.60 Acres and 1.30 acres respectivelely lying on or towards the east of the A9 public rd in the parish of old machar and county of aberdeen see form 395 for full details.
    Persone aventi diritto
    • The Royal Bank of Scotland PLC
    Transazioni
    • 16 ott 1992Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 09 ago 2001Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Standard security
    Creato il 18 lug 1985
    Consegnato il 30 lug 1985
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee
    Brevi particolari
    A lease between grampian regional council & aberdeen exhibition conference centre limited recorded grs aberdeen 23.7.85.(for full details see doc M12).
    Persone aventi diritto
    • The Royal Bank of Scotland PLC.
    Transazioni
    • 30 lug 1985Registrazione di un'ipoteca
    • 09 ago 2001Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Charge
    Creato il 18 dic 1984
    Consegnato il 22 dic 1984
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Fixed charge over all book debts and other debts now and from time to time due or owing to the company and all the goodwill and uncalled capital. Floating charge over all the undertaking and other property.
    Persone aventi diritto
    • The Royal Bank of Scotland PLC.
    Transazioni
    • 22 dic 1984Registrazione di un'ipoteca
    • 23 mag 2006Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)

    Fonte dati

    • Companies House del Regno Unito
      Il registro ufficiale delle imprese nel Regno Unito, che fornisce l'accesso pubblico alle informazioni sulle imprese, come nomi, indirizzi, amministratori e depositi finanziari.
    • Licenza: CC0