ABERDEEN EXHIBITION AND CONFERENCE CENTRE LIMITED
Panoramica
| Nome della società | ABERDEEN EXHIBITION AND CONFERENCE CENTRE LIMITED |
|---|---|
| Stato della società | Sciolta |
| Forma giuridica | Società a responsabilità limitata |
| Numero di società | 01858349 |
| Giurisdizione | Inghilterra/Galles |
| Data di costituzione | |
| Data di cessazione |
Riepilogo
| Ha PSCs super sicuri | No |
|---|---|
| Ha ipoteche | Sì |
| Ha una storia di insolvenza | No |
| La sede legale è in contestazione | No |
Qual è lo scopo di ABERDEEN EXHIBITION AND CONFERENCE CENTRE LIMITED?
- Altre attività di servizi n.c.a. (96090) / Altre attività di servizi
Dove si trova ABERDEEN EXHIBITION AND CONFERENCE CENTRE LIMITED?
| Indirizzo della sede legale | City Point One Ropemaker Street EC2Y 9SS London |
|---|---|
| Indirizzo della sede legale non recapitabile | No |
Quali erano i nomi precedenti di ABERDEEN EXHIBITION AND CONFERENCE CENTRE LIMITED?
| Nome della società | Da | A |
|---|---|---|
| ZONEFLEET LIMITED | 25 ott 1984 | 25 ott 1984 |
Quali sono gli ultimi bilanci di ABERDEEN EXHIBITION AND CONFERENCE CENTRE LIMITED?
| Ultimi bilanci | |
|---|---|
| Ultimi bilanci redatti al | 31 mar 2017 |
Quali sono le ultime deposizioni per ABERDEEN EXHIBITION AND CONFERENCE CENTRE LIMITED?
| Data | Descrizione | Documento | Tipo | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gazzetta Ufficiale finale sciolta per scioglimento volontario | 1 pagine | GAZ2(A) | ||||||||||
Prima Gazzetta Ufficiale per lo scioglimento volontario | 1 pagine | GAZ1(A) | ||||||||||
Richiesta di cancellazione della società dal registro | 3 pagine | DS01 | ||||||||||
Dichiarazione di conformità presentata il 12 feb 2018 senza aggiornamenti | 3 pagine | CS01 | ||||||||||
Bilancio redatto al 31 mar 2017 | 28 pagine | AA | ||||||||||
Cessazione della carica di Graeme Alexander Cumming come amministratore in data 30 giu 2017 | 1 pagine | TM01 | ||||||||||
Nomina di Mr Alan James Donnelly come amministratore in data 13 giu 2017 | 2 pagine | AP01 | ||||||||||
Nomina di Mr John Michael Reynolds come amministratore in data 17 mag 2017 | 2 pagine | AP01 | ||||||||||
Cessazione della carica di John Michael Reynolds come amministratore in data 04 mag 2017 | 1 pagine | TM01 | ||||||||||
Cessazione della carica di Aileen Jacqueline Malone come amministratore in data 04 mag 2017 | 1 pagine | TM01 | ||||||||||
Cessazione della carica di Barney Crockett come amministratore in data 04 mag 2017 | 1 pagine | TM01 | ||||||||||
Cessazione della carica di Alan James Donnelly come amministratore in data 04 mag 2017 | 1 pagine | TM01 | ||||||||||
Cessazione della carica di Louise Lonie come amministratore in data 31 mar 2017 | 1 pagine | TM01 | ||||||||||
Cessazione della carica di Geoffrey David Runcie come amministratore in data 31 mar 2017 | 1 pagine | TM01 | ||||||||||
Cessazione della carica di John Watson come amministratore in data 31 mar 2017 | 1 pagine | TM01 | ||||||||||
Cessazione della carica di Fiona Elaine Mann come amministratore in data 31 mar 2017 | 1 pagine | TM01 | ||||||||||
Cessazione della carica di Edwin Andrew Gillespie come amministratore in data 01 apr 2017 | 1 pagine | TM01 | ||||||||||
Cessazione della carica di Elaine Hulse come amministratore in data 31 mar 2017 | 1 pagine | TM01 | ||||||||||
Dichiarazione di conformità presentata il 12 feb 2017 con aggiornamenti | 5 pagine | CS01 | ||||||||||
Bilancio redatto al 31 mar 2016 | 32 pagine | AA | ||||||||||
Dettagli del direttore cambiati per Mr James Alan Donnelly il 02 mar 2016 | 2 pagine | CH01 | ||||||||||
Cessazione della carica di Carol Margaret Benzie come amministratore in data 07 ott 2016 | 1 pagine | TM01 | ||||||||||
Soddisfazione dell'onere 5 in pieno | 4 pagine | MR04 | ||||||||||
Soddisfazione dell'onere 8 in pieno | 4 pagine | MR04 | ||||||||||
Bilancio annuale redatto al 12 feb 2016 con elenco completo degli azionisti | 16 pagine | AR01 | ||||||||||
| ||||||||||||
Chi sono gli amministratori di ABERDEEN EXHIBITION AND CONFERENCE CENTRE LIMITED?
| Nome | Nominato il | Dimissioni il | Ruolo | Indirizzo | Identificazione della società | Paese di residenza | Nazionalità | Data di nascita | Professione | Numero |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| STRONACHS SECRETARIES LIMITED | Segretario | Albyn Place AB10 1FW Aberdeen 34 Aberdeenshire | 129592570001 | |||||||
| DONNELLY, Alan James | Amministratore | Town House Broad Street AB10 1FY Aberdeen Aberdeen City Council United Kingdom | Scotland | British | 56793050002 | |||||
| REYNOLDS, John Michael | Amministratore | Newburgh Circle Bridge Of Don AB22 8XB Aberdeen 100 Grampian United Kingdom | Scotland | British | 39568820001 | |||||
| ALLAN, David Martin | Segretario | Millfield Inchbare DD9 7QJ Edzell Angus | British | 41797230003 | ||||||
| STRONACHS | Segretario | 34 Albyn Place AB10 1FW Aberdeen Aberdeenshire | 50482710001 | |||||||
| BENZIE, Carol Margaret | Amministratore | Swailend Newmachar AB21 7UU Aberdeen Lilac Cottage Aberdeenshire United Kingdom | Scotland | British | 161586490001 | |||||
| BISSET, Raymond George | Amministratore | The Schoolhouse Keith Hall AB51 0LX Inverurie Aberdeenshire | British | 49635290001 | ||||||
| BLACKMAN, Kirsty | Amministratore | Laurelwood Avenue AB25 3SL Aberdeen 28 Aberdeenshire Scotland | British | 138446130002 | ||||||
| CAMERON, David John, Lord Provost | Amministratore | Town House Broad Street AB10 1FY Aberdeen Aberdeen City Council United Kingdom | Scotland | British | 1374270003 | |||||
| CASSIE, George Scott | Amministratore | 70 Garthdee Road AB1 7AR Aberdeen Aberdeenshire | Scotland | British | 1116550001 | |||||
| CLARK, Ronald | Amministratore | 134 Victoria Street Dyce AB21 7BE Aberdeen Aberdeenshire | British | 65220090001 | ||||||
| CLARK, Ronald | Amministratore | 134 Victoria Street Dyce AB21 7BE Aberdeen Aberdeenshire | British | 65220090001 | ||||||
| CLYNE, David Elmslie, Councillor | Amministratore | 164 Gardner Drive AB12 5SA Aberdeen | British | 93547050001 | ||||||
| CLYNE, David Elmslie, Councillor | Amministratore | 164 Gardner Drive AB12 5SA Aberdeen | British | 93547050001 | ||||||
| CROCKETT, Barney, Councillor | Amministratore | Bankhead Avenue Bucksburn AB21 9ET Aberdeen Woodville Aberdeenshire | Scotland | British | 125037060001 | |||||
| CUMMING, Graeme Alexander | Amministratore | Logie Coldstone AB34 5PR Aboyne Corblelack United Kingdom | Scotland | British | 121595860002 | |||||
| DEAN, Katharine Mary, Councillor | Amministratore | 48 Dunlin Road Cove Bay AB12 3WD Aberdeen | United Kingdom | British | 92457090001 | |||||
| DONNELLY, Alan James | Amministratore | Town House Broad Street AB10 1FY Aberdeen Aberdeen City Council United Kingdom | Scotland | British | 56793050002 | |||||
| DUNCAN, Matthew Robert | Amministratore | 2 Beaconhill Road Milltimber AB13 0JR Aberdeen | British | 93547140001 | ||||||
| EDWARDS, Gordon Normandale | Amministratore | 44 Hammerfield Avenue AB10 7FJ Aberdeen | Scotland | British | 77338910001 | |||||
| FINDLAY, Audrey Margaret | Amministratore | 26 Kinmundy Green Westhill AB32 6SF Aberdeen | Uk | British | 102892980001 | |||||
| FLETCHER, Neil Derek | Amministratore | 14 Cairncry Terrace AB16 5JZ Aberdeen Grampian | Scotland | British | 92456990001 | |||||
| GILLESPIE, Edwin Andrew | Amministratore | Muiryfold Newmachar AB21 7UU Aberdeen | Scotland | British | 63626350001 | |||||
| HORSBURGH, Brian William | Amministratore | Urquhart Road AB24 5AU Aberdeen 130 United Kingdom | United Kingdom | British | 149682660003 | |||||
| HULSE, Elaine | Amministratore | Fairfield Road RH19 4HG East Grinstead 6 Aspen Court W Sussex | England | British | 86453120002 | |||||
| HUTCHEON, Raymond William | Amministratore | Corsehill Croft Parkhill Newmachar AB21 7XA Aberdeen | Scotland | British | 538670001 | |||||
| IRONSIDE, Leonard, Cllr | Amministratore | 239 North Anderson Drive AB16 7GR Aberdeen Aberdeenshire | British | 122608160001 | ||||||
| IRONSIDE, Leonard | Amministratore | 42 Hillside Terrace Portlethen AB1 4QG Aberdeen Aberdeenshire Uk | Scotland | British | 191955550001 | |||||
| KEMP, Rhona | Amministratore | 9 Lomond Crescent AB41 9GE Ellon Aberdeenshire | Scotland | British | 24375300001 | |||||
| LAMOND, James Alexander | Amministratore | 15 Belvidere Street AB25 2QS Aberdeen Aberdeenshire | British | 53875770001 | ||||||
| LIDDELL, John Chalmers | Amministratore | 189 Westburn Road AB2 4QE Aberdeen Aberdeenshire | British | 48725970001 | ||||||
| LONIE, Louise | Amministratore | Conference Way Bridge Of Don AB23 8BL Aberdeen Aecc United Kingdom | Scotland | British | 196917240001 | |||||
| MALONE, Aileen Jacqueline | Amministratore | 45 Hillview Road Cults AB15 9HA Aberdeen | British | 94403180001 | ||||||
| MANN, Fiona Elaine | Amministratore | Bridge Of Don AB23 8LG Aberdeen Aberdeen Exhibition & Conference Centre United Kingdom | United Kingdom | British | 176055810001 | |||||
| MARKE, Christopher Philip Levelis | Amministratore | 71 Holmesdale Road TW11 9LQ Teddington Middlesex | British | 524330001 |
Chi sono le persone con controllo significativo di ABERDEEN EXHIBITION AND CONFERENCE CENTRE LIMITED?
| Nome | Notificato il | Indirizzo | Cessato | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aberdeen City Council | 06 apr 2016 | Broad Street AB10 1AB Aberdeen Marischall College Scotland | No | ||||
| |||||||
Natura del controllo
| |||||||
ABERDEEN EXHIBITION AND CONFERENCE CENTRE LIMITED ha ipoteche?
| Classificazione | Date | Stato | Dettagli | |
|---|---|---|---|---|
| Standard security which was presented for registration in scotland on 25 may 2006 and | Creato il 17 mag 2006 Consegnato il 27 mag 2006 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Brevi particolari All and whole the chargor's interest in the ground lease of the subjects k/a and forming aberdeen exhibition and conference centre,bridge of don in the city and county of aberdeen. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
| Debenture | Creato il 17 mag 2006 Consegnato il 23 mag 2006 | In corso | Importo garantito All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Brevi particolari All the company's undertaking property assets and rights present and future of whatever mature and wherever situated. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
| Rental assignation | Creato il 20 giu 2003 Consegnato il 11 lug 2003 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due or to become due from the company to the chargee | |
Brevi particolari The company's whole entitlement to receive from the tenants for the time being under the head-lease entered into by aberdeen exhibition and conference centre limited and aberdeen city council dated 11 april and 1 may 2003 as varied, supplemented and/or amended from time to time all rents and other sums payable now and in the future in terms of the headlease and all interest or payments on late payment and the whole amount of any future increase in rent and/or any other sums whether or not resulting from the provisions of the head lease or review thereof.. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
| A standard security which was presented for registration in scotland on 28 august 2001 and | Creato il 24 lug 2001 Consegnato il 08 set 2001 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Brevi particolari Ground lease of subjects at aberdeen exhibition and conference centre, bridge of don, aberdeen extending to 16.476 hectares or thereby. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
| Scottish assignation | Creato il 15 mar 1995 Consegnato il 29 mar 1995 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever under the assignation and under the agreement and/or any deed or document supplemental thereto | |
Brevi particolari All right title interest & benefit in & to the letter of indemnity, any agreements or instruments etc. see the mortgage charge document for full details. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
| Standard security | Creato il 07 ott 1992 Consegnato il 16 ott 1992 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due or to become due from the company to the chargee | |
Brevi particolari Lease for 3 areas of ground extending to 10.40 acres,1.60 Acres and 1.30 acres respectivelely lying on or towards the east of the A9 public rd in the parish of old machar and county of aberdeen see form 395 for full details. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
| Standard security | Creato il 18 lug 1985 Consegnato il 30 lug 1985 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due or to become due from the company to the chargee | |
Brevi particolari A lease between grampian regional council & aberdeen exhibition conference centre limited recorded grs aberdeen 23.7.85.(for full details see doc M12). | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
| Charge | Creato il 18 dic 1984 Consegnato il 22 dic 1984 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Brevi particolari Fixed charge over all book debts and other debts now and from time to time due or owing to the company and all the goodwill and uncalled capital. Floating charge over all the undertaking and other property. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
Fonte dati
- Companies House del Regno Unito
Il registro ufficiale delle imprese nel Regno Unito, che fornisce l'accesso pubblico alle informazioni sulle imprese, come nomi, indirizzi, amministratori e depositi finanziari. - Licenza: CC0