MRX DORMANT COMPANY FIVE LIMITED
Panoramica
Nome della società | MRX DORMANT COMPANY FIVE LIMITED |
---|---|
Stato della società | Sciolta |
Forma giuridica | Società a responsabilità limitata |
Numero di società | 01861125 |
Giurisdizione | Inghilterra/Galles |
Data di costituzione | |
Data di cessazione |
Riepilogo
Ha PSCs super sicuri | No |
---|---|
Ha ipoteche | Sì |
Ha una storia di insolvenza | No |
La sede legale è in contestazione | No |
Qual è lo scopo di MRX DORMANT COMPANY FIVE LIMITED?
- Società inattiva (99999) / Attività di organizzazioni ed organismi extraterritoriali
Dove si trova MRX DORMANT COMPANY FIVE LIMITED?
Indirizzo della sede legale | Rectory Court Old Rectory Lane Alvechurch B48 7SX Birmingham West Midlands England |
---|---|
Indirizzo della sede legale non recapitabile | No |
Quali erano i nomi precedenti di MRX DORMANT COMPANY FIVE LIMITED?
Nome della società | Da | A |
---|---|---|
MICROWISE COOKWARE LIMITED | 29 nov 1984 | 29 nov 1984 |
MALTNEON LIMITED | 05 nov 1984 | 05 nov 1984 |
Quali sono gli ultimi bilanci di MRX DORMANT COMPANY FIVE LIMITED?
Ultimi bilanci | |
---|---|
Ultimi bilanci redatti al | 31 dic 2011 |
Quali sono le ultime deposizioni per MRX DORMANT COMPANY FIVE LIMITED?
Data | Descrizione | Documento | Tipo | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gazzetta Ufficiale finale sciolta per scioglimento volontario | 1 pagine | GAZ2(A) | ||||||||||
Prima Gazzetta Ufficiale per lo scioglimento volontario | 1 pagine | GAZ1(A) | ||||||||||
Richiesta di cancellazione della società dal registro | 3 pagine | DS01 | ||||||||||
Certificato di cambio di nome Company name changed microwise cookware LIMITED\certificate issued on 11/04/13 | 5 pagine | CERTNM | ||||||||||
| ||||||||||||
Avviso di cambio di nome" | 2 pagine | CONNOT | ||||||||||
Dettagli del direttore cambiati per Andrew John Richardson il 17 ago 2012 | 2 pagine | CH01 | ||||||||||
Dettagli del direttore cambiati per Andrew John Richardson il 14 nov 2011 | 2 pagine | CH01 | ||||||||||
Nomina di Mrs Caroline Inez Green come amministratore in data 13 gen 2012 | 2 pagine | AP01 | ||||||||||
Cessazione della carica di Nicholas Longley come amministratore in data 28 set 2012 | 1 pagine | TM01 | ||||||||||
Cessazione della carica di Nicholas Longley come segretario in data 28 set 2012 | 1 pagine | TM02 | ||||||||||
Dettagli del direttore cambiati per Andrew John Richardson il 17 ago 2012 | 2 pagine | CH01 | ||||||||||
Bilancio redatto al 31 dic 2011 | 8 pagine | AA | ||||||||||
Bilancio annuale redatto al 07 giu 2012 con elenco completo degli azionisti | 4 pagine | AR01 | ||||||||||
| ||||||||||||
legacy | 3 pagine | MG02 | ||||||||||
legacy | 3 pagine | MG02 | ||||||||||
Indirizzo della sede legale modificato da C/O Metalrax Group Plc, Ardath Road, Kings Norton Birmingham B38 9PN in data 30 nov 2011 | 1 pagine | AD01 | ||||||||||
Bilancio redatto al 31 dic 2010 | 9 pagine | AA | ||||||||||
Bilancio annuale redatto al 07 giu 2011 con elenco completo degli azionisti | 5 pagine | AR01 | ||||||||||
Stato del capitale al 07 gen 2011
| 4 pagine | SH19 | ||||||||||
legacy | 1 pagine | SH20 | ||||||||||
legacy | 1 pagine | CAP-SS | ||||||||||
Risoluzioni Resolutions | 1 pagine | RESOLUTIONS | ||||||||||
| ||||||||||||
Conto per una società dormiente redatto al 31 dic 2009 | 8 pagine | AA | ||||||||||
Bilancio annuale redatto al 07 giu 2010 con elenco completo degli azionisti | 6 pagine | AR01 | ||||||||||
Cessazione della carica di Peter Marshall come amministratore | 1 pagine | TM01 | ||||||||||
Chi sono gli amministratori di MRX DORMANT COMPANY FIVE LIMITED?
Nome | Nominato il | Dimissioni il | Ruolo | Indirizzo | Identificazione della società | Paese di residenza | Nazionalità | Data di nascita | Professione | Numero |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GREEN, Caroline Inez | Amministratore | Old Rectory Lane Alvechurch B48 7SX Birmingham Rectory Court West Midlands England | United Kingdom | British | Finance Director | 174414810001 | ||||
RICHARDSON, Andrew John | Amministratore | Old Rectory Lane Alvechurch B48 7SX Birmingham Rectory Court West Midlands England | England | British | Director | 132142760002 | ||||
FARRIMOND, Darren James | Segretario | 5 Marsh Way Catshill B61 0JD Bromsgrove | British | 96411190001 | ||||||
JONES, Terry Ryan | Segretario | 5 Dodford Court Fockbury Lane Dodford B61 9AP Bromsgrove Worcestershire | British | 12676600001 | ||||||
LONGLEY, Nicholas | Segretario | Ardath Road Kings Norton B38 9PN Birmingham Ardath Road England | 147393120001 | |||||||
STOCK, Michael John | Segretario | WR9 7NH Tibberton Foredraught House Worcs | British | 129726080001 | ||||||
STRINGER, Vivien Shirley | Segretario | Upper Laurels Farm Station Road Launton OX26 5EH Bicester Oxfordshire | British | 115891890001 | ||||||
ARBUTHNOT, Richard | Amministratore | 101 Dorridge Road Dorridge B93 8BS Solihull West Midlands | British | Director | 67470540001 | |||||
CAMPION, William Ian | Amministratore | 11 Shireburn Road Formby L37 1LR Liverpool Merseyside | England | British | Director | 1672810001 | ||||
GRESHAM, Garry Howard | Amministratore | 34 Grange Park Avenue SK9 4AJ Wilmslow Cheshire | United Kingdom | British | Director | 21825330002 | ||||
HARRISON, Charles Brinley Ledlie | Amministratore | 10 Castle Street OX10 8DL Wallingford Oxfordshire | United Kingdom | British | Company Director | 4780020001 | ||||
LONGLEY, Nicholas | Amministratore | Ardath Road Kings Norton B38 9PN Birmingham Ardath Road England | England | British | Group Financial Controller | 147396410001 | ||||
MACKENZIE, Alan James | Amministratore | 2 Newton Square Great Barr B43 6DY Birmingham West Midlands | British | Director | 1672820001 | |||||
MARSHALL, Peter Arthur | Amministratore | 267 Four Ashes Road Dorridge B93 8NR Solihull West Midlands | British | Company Director | 12743030001 | |||||
MOORE, Eric Stanley | Amministratore | 18 Grove Vale Avenue Great Barr B43 6BZ Birmingham West Midlands | England | British | Director | 1672830001 | ||||
STRINGER, Dennis Robert | Amministratore | Upper Laurels Farm Station Road Launton OX6 0EH Bicester Oxfordshire | British | Director | 19468210002 | |||||
STRINGER, Vivien Shirley | Amministratore | Upper Laurels Farm Station Road Launton OX26 5EH Bicester Oxfordshire | British | Director | 115891890001 |
MRX DORMANT COMPANY FIVE LIMITED ha ipoteche?
Classificazione | Date | Stato | Dettagli | |
---|---|---|---|---|
Composite guarantee and debenture | Creato il 12 ott 2009 Consegnato il 21 ott 2009 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due or to become due from any present or future group company to the security trustee and/or the other secured parties (or any of them) under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Brevi particolari Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery see image for full details. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
A composite guarantee and debenture | Creato il 12 ott 2009 Consegnato il 19 ott 2009 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due or to become due from the company and/or all or any of the companies named therein to the chargee on any account whatsoever | |
Brevi particolari Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery see image for full details. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
Debenture | Creato il 15 nov 1988 Consegnato il 28 nov 1988 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Brevi particolari Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
Debenture | Creato il 11 feb 1985 Consegnato il 20 feb 1985 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Brevi particolari Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
|
Fonte dati
- Companies House del Regno Unito
Il registro ufficiale delle imprese nel Regno Unito, che fornisce l'accesso pubblico alle informazioni sulle imprese, come nomi, indirizzi, amministratori e depositi finanziari. - Licenza: CC0