TUSCARORA (SCOTLAND) LIMITED

TUSCARORA (SCOTLAND) LIMITED

  • Panoramica
  • Riepilogo
  • Scopo
  • Indirizzo
  • Denominazioni precedenti
  • Bilanci
  • Deposizioni
  • Amministratori
  • Ipoteche
  • Insolvenza
  • Fonte dati
  • Panoramica

    Nome della societàTUSCARORA (SCOTLAND) LIMITED
    Stato della societàSciolta
    Forma giuridicaSocietà a responsabilità limitata
    Numero di società 01863110
    GiurisdizioneInghilterra/Galles
    Data di costituzione
    Data di cessazione

    Qual è lo scopo di TUSCARORA (SCOTLAND) LIMITED?

    • Società non commerciali (74990) / Attività professionali, scientifiche e tecniche

    Dove si trova TUSCARORA (SCOTLAND) LIMITED?

    Indirizzo della sede legale
    c/o SCA
    1 Southfields Road
    LU6 3EJ Dunstable
    Bedfordshire
    England
    Indirizzo della sede legale non recapitabileNo

    Quali erano i nomi precedenti di TUSCARORA (SCOTLAND) LIMITED?

    Denominazioni sociali precedenti
    Nome della societàDaA
    EPS (MOULDERS) LIMITED05 giu 198505 giu 1985
    TRUESTAR LIMITED13 nov 198413 nov 1984

    Quali sono gli ultimi bilanci di TUSCARORA (SCOTLAND) LIMITED?

    Ultimi bilanci
    Ultimi bilanci redatti al31 dic 2010

    Quali sono le ultime deposizioni per TUSCARORA (SCOTLAND) LIMITED?

    Deposizioni
    DataDescrizioneDocumentoTipo

    Gazzetta ufficiale finale sciolta a seguito di liquidazione

    1 pagineGAZ2

    Ritorno della riunione finale in una liquidazione volontaria dei membri

    6 pagine4.71

    Nomina di un liquidatore volontario

    1 pagine600

    Dichiarazione di solvibilità

    4 pagine4.70

    Risoluzioni

    Resolutions
    1 pagineRESOLUTIONS
    Risoluzioni
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    liquidation

    Risoluzione speciale per la liquidazione al 31 ott 2012

    LRESSP

    Bilancio annuale redatto al 16 lug 2012 con elenco completo degli azionisti

    4 pagineAR01
    Deposizioni associate
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    capital27 lug 2012

    Stato del capitale al 27 lug 2012

    • Capitale: GBP 253,551
    SH01

    Nomina di Mrs Sally Anne Barker come amministratore in data 30 giu 2012

    2 pagineAP01

    Nomina di Mr Paul Andrew Bailey come amministratore in data 30 giu 2012

    2 pagineAP01

    Nomina di Mr Paul Andrew Bailey come segretario in data 30 giu 2012

    1 pagineAP03

    Cessazione della carica di Victoria Sykes come segretario in data 30 giu 2012

    1 pagineTM02

    Cessazione della carica di Thomas David Heys come amministratore in data 30 giu 2012

    1 pagineTM01

    Indirizzo della sede legale modificato da Sca Packaging Limited Faverdale Industrial Estate Darlington DL3 0PE in data 27 lug 2012

    1 pagineAD01

    Cessazione della carica di Stephen Paul Hovington come amministratore in data 30 giu 2012

    1 pagineTM01

    Conto per una società dormiente redatto al 31 dic 2010

    4 pagineAA

    Bilancio annuale redatto al 16 lug 2011 con elenco completo degli azionisti

    5 pagineAR01

    Conto per una società dormiente redatto al 31 dic 2009

    4 pagineAA

    Bilancio annuale redatto al 16 lug 2010 con elenco completo degli azionisti

    14 pagineAR01

    legacy

    3 pagineMG02

    legacy

    5 pagine363a

    Bilancio redatto al 31 dic 2008

    4 pagineAA

    legacy

    1 pagine287

    legacy

    1 pagine288b

    legacy

    2 pagine288a

    Bilancio redatto al 31 dic 2007

    4 pagineAA

    legacy

    1 pagine288b

    Chi sono gli amministratori di TUSCARORA (SCOTLAND) LIMITED?

    Amministratori
    NomeNominato ilDimissioni ilRuoloIndirizzoIdentificazione della societàPaese di residenzaNazionalitàData di nascitaProfessioneNumero
    BAILEY, Paul Andrew
    c/o Sca
    Southfields Road
    LU6 3EJ Dunstable
    1
    Bedfordshire
    England
    Segretario
    c/o Sca
    Southfields Road
    LU6 3EJ Dunstable
    1
    Bedfordshire
    England
    170967330001
    BAILEY, Paul Andrew
    c/o Sca
    Southfields Road
    LU6 3EJ Dunstable
    1
    Bedfordshire
    England
    Amministratore
    c/o Sca
    Southfields Road
    LU6 3EJ Dunstable
    1
    Bedfordshire
    England
    EnglandBritish75085210004
    BARKER, Sally Anne
    c/o Sca
    Southfields Road
    LU6 3EJ Dunstable
    1
    Bedfordshire
    England
    Amministratore
    c/o Sca
    Southfields Road
    LU6 3EJ Dunstable
    1
    Bedfordshire
    England
    United KingdomBritish136081340002
    EYLES, Melanie
    North Otterington
    DL7 9JG Northallerton
    Grange Farm
    North Yorkshire
    Segretario
    North Otterington
    DL7 9JG Northallerton
    Grange Farm
    North Yorkshire
    British130563500001
    MILLER, Charles
    91 Springfield Road
    EH49 7JP Linlithgow
    West Lothian
    Segretario
    91 Springfield Road
    EH49 7JP Linlithgow
    West Lothian
    British15424600001
    STAPLES, Anthony John
    Park Cottage
    Frittenden
    TN17 2AU Cranbrook
    Kent
    Segretario
    Park Cottage
    Frittenden
    TN17 2AU Cranbrook
    Kent
    British45838190001
    SYKES, Victoria
    Brancepeth View
    DH7 8TU Brandon
    61
    Durham
    Segretario
    Brancepeth View
    DH7 8TU Brandon
    61
    Durham
    British138121210001
    TILLSON, Andrew John
    19 Colonial Drive
    Collingtree
    NN4 0BL Northampton
    Segretario
    19 Colonial Drive
    Collingtree
    NN4 0BL Northampton
    British54524940001
    BIDDINGER, Scott
    4 Seagrave Court
    Walton
    MK7 7HA Milton Keynes
    Bucks
    Amministratore
    4 Seagrave Court
    Walton
    MK7 7HA Milton Keynes
    Bucks
    American49882470001
    HEYS, Thomas David
    Mickleton
    DL12 0JR Near Barnard Castle
    Low Green
    County Durham
    Amministratore
    Mickleton
    DL12 0JR Near Barnard Castle
    Low Green
    County Durham
    EnglandBritish133589280001
    HOVINGTON, Stephen Paul
    9 Hillgarth Court
    Elvington
    YO41 4BD York
    North Yorkshire
    Amministratore
    9 Hillgarth Court
    Elvington
    YO41 4BD York
    North Yorkshire
    EnglandBritish60781190001
    HUNTER, Martin
    79 Drum Brae South
    EH12 8TD Edinburgh
    Midlothian
    Amministratore
    79 Drum Brae South
    EH12 8TD Edinburgh
    Midlothian
    British15424610001
    MILLER, Brian Joseph
    1 Sycamore Place
    Torbex
    FK8 2PH Stirling
    Stirlingshire
    Amministratore
    1 Sycamore Place
    Torbex
    FK8 2PH Stirling
    Stirlingshire
    British28463460001
    MILLER, Charles
    91 Springfield Road
    EH49 7JP Linlithgow
    West Lothian
    Amministratore
    91 Springfield Road
    EH49 7JP Linlithgow
    West Lothian
    British15424600001
    MULLINS, Brian Christopher
    5421 Kipling Road
    Pittsburg 15217
    Pennsylvania
    Usa
    Amministratore
    5421 Kipling Road
    Pittsburg 15217
    Pennsylvania
    Usa
    Us Citizen49882440001
    O'LEARY JR, John Patrick
    13 Davidson Drive
    15010 Beaver Falls
    Pennsylvania
    Usa
    Amministratore
    13 Davidson Drive
    15010 Beaver Falls
    Pennsylvania
    Usa
    Us Citizen41699650001
    O`LEARY, David Carl
    360 River Road
    15009 Beaver
    Pennsylvania
    Usa
    Amministratore
    360 River Road
    15009 Beaver
    Pennsylvania
    Usa
    Us Citizen49992870001
    RICE, Thomas Anthony
    Pump Cottage
    6 Wells Cottages Egglescliffe
    TS16 9DA Stockton On Tees
    Cleveland
    Amministratore
    Pump Cottage
    6 Wells Cottages Egglescliffe
    TS16 9DA Stockton On Tees
    Cleveland
    Irish108501020001
    STEAD, David Richard
    1 The Orchard
    Yeoman Lane, Bearsted
    ME14 4QL Maidstone
    Kent
    Amministratore
    1 The Orchard
    Yeoman Lane, Bearsted
    ME14 4QL Maidstone
    Kent
    EnglandBritish72400470001
    STOTT, Alan
    12 Balmoral Drive
    Denton
    M34 2JU Manchester
    Lancashire
    Amministratore
    12 Balmoral Drive
    Denton
    M34 2JU Manchester
    Lancashire
    British15424630001
    THYNE, William
    The Yair
    TD1 3PW Galashiels
    Amministratore
    The Yair
    TD1 3PW Galashiels
    ScotlandBritish285450001
    WHYTE, Frederick Gordon
    1 Sycamore Gardens
    EH12 7JJ Edinburgh
    Midlothian
    Amministratore
    1 Sycamore Gardens
    EH12 7JJ Edinburgh
    Midlothian
    British577600001
    WILLIAMS, John David
    Redstone House
    Crouch Lane, Borough Green
    TN15 8LU Sevenoaks
    Kent
    Amministratore
    Redstone House
    Crouch Lane, Borough Green
    TN15 8LU Sevenoaks
    Kent
    British74014480001

    TUSCARORA (SCOTLAND) LIMITED ha ipoteche?

    Ipoteche
    ClassificazioneDateStatoDettagli
    Standard security registered in scotland 26/11/90
    Creato il 26 nov 1990
    Consegnato il 06 dic 1990
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of a personal bond dated 26/11/90
    Brevi particolari
    All and whole the dominium utile of that area or piece of ground lying on the south east side of firth road, houstoun industrial estate, livingston in the parish of mid-calder and county of midlothian extending to 4 acres or thereby together with the factory k/a 15 firth road, and the whole other buildings erected thereon.
    Persone aventi diritto
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transazioni
    • 06 dic 1990Registrazione di un'ipoteca
    • 27 apr 2010Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (MG02)
    Standard security presented for registration in scotland
    Creato il 22 mag 1990
    Consegnato il 01 giu 1990
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    All and whole the dominion utile of piece of ground lying to the south of grange road houstoun industrial estate west lothian k/a standard factory five "a" and the building erected thereon.
    Persone aventi diritto
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland.
    Transazioni
    • 01 giu 1990Registrazione di un'ipoteca
    • 26 gen 1999Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Standard security
    Creato il 15 mag 1985
    Consegnato il 20 mag 1985
    In corso
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee in terms of personal bond dated 13 may 1985 was registered pursuant to section 95 of the companies act 1948, on 20 may 1985.
    Brevi particolari
    All right, title & interest incorporated in the lease dated 28 august. (See doc M11 for full details).
    Persone aventi diritto
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transazioni
    • 20 mag 1985Registrazione di un'ipoteca
    Debenture
    Creato il 03 apr 1985
    Consegnato il 23 apr 1985
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    The whole property and undertaking of the company including uncalled capital.
    Persone aventi diritto
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transazioni
    • 23 apr 1985Registrazione di un'ipoteca
    • 26 gen 1999Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)

    TUSCARORA (SCOTLAND) LIMITED ha procedimenti di insolvenza?

    Numero di praticaDateTipoProfessionistiAltro
    1
    DataTipo
    15 mag 2013Data di scioglimento
    31 ott 2012Inizio della liquidazione
    Liquidazione volontaria dei soci
    NomeRuoloIndirizzoNominato ilCessato il
    Peter James Greaves
    7 More London Riverside
    SE1 2RT London
    Praticante
    7 More London Riverside
    SE1 2RT London
    Timothy Gerard Walsh
    Pricewaterhousecoopers Llp
    Benson House
    LS1 4JP 33 Wellington Street
    Leeds
    Praticante
    Pricewaterhousecoopers Llp
    Benson House
    LS1 4JP 33 Wellington Street
    Leeds

    Fonte dati

    • Companies House del Regno Unito
      Il registro ufficiale delle imprese nel Regno Unito, che fornisce l'accesso pubblico alle informazioni sulle imprese, come nomi, indirizzi, amministratori e depositi finanziari.
    • Licenza: CC0