EXACT MACHINING UK LIMITED
Panoramica
| Nome della società | EXACT MACHINING UK LIMITED |
|---|---|
| Stato della società | Sciolta |
| Forma giuridica | Società a responsabilità limitata |
| Numero di società | 01863369 |
| Giurisdizione | Inghilterra/Galles |
| Data di costituzione | |
| Data di cessazione |
Riepilogo
| Ha PSCs super sicuri | No |
|---|---|
| Ha ipoteche | Sì |
| Ha una storia di insolvenza | No |
| La sede legale è in contestazione | No |
Qual è lo scopo di EXACT MACHINING UK LIMITED?
- lavorazioni meccaniche (25620) / Industrie manifatturiere
Dove si trova EXACT MACHINING UK LIMITED?
| Indirizzo della sede legale | Armstrong Works Scotswood Road NE15 6UX Newcastle Upon Tyne United Kingdom |
|---|---|
| Indirizzo della sede legale non recapitabile | No |
Quali erano i nomi precedenti di EXACT MACHINING UK LIMITED?
| Nome della società | Da | A |
|---|---|---|
| EXACT ENGINEERING (THOMPSON) LIMITED | 14 nov 1984 | 14 nov 1984 |
Quali sono gli ultimi bilanci di EXACT MACHINING UK LIMITED?
| Ultimi bilanci | |
|---|---|
| Ultimi bilanci redatti al | 31 dic 2018 |
Quali sono le ultime deposizioni per EXACT MACHINING UK LIMITED?
| Data | Descrizione | Documento | Tipo | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gazzetta Ufficiale finale sciolta per scioglimento volontario | 1 pagine | GAZ2(A) | ||||||||||||||
Prima Gazzetta Ufficiale per lo scioglimento volontario | 1 pagine | GAZ1(A) | ||||||||||||||
Richiesta di cancellazione della società dal registro | 3 pagine | DS01 | ||||||||||||||
Conto per una società dormiente redatto al 31 dic 2018 | 8 pagine | AA | ||||||||||||||
legacy | 1 pagine | SH20 | ||||||||||||||
Stato del capitale al 26 set 2019
| 3 pagine | SH19 | ||||||||||||||
legacy | 1 pagine | CAP-SS | ||||||||||||||
Risoluzioni Resolutions | 2 pagine | RESOLUTIONS | ||||||||||||||
| ||||||||||||||||
Cessazione della carica di Graeme Cook come amministratore in data 05 apr 2019 | 1 pagine | TM01 | ||||||||||||||
Dichiarazione di conformità presentata il 07 feb 2019 senza aggiornamenti | 3 pagine | CS01 | ||||||||||||||
Conto per una società dormiente redatto al 31 dic 2017 | 8 pagine | AA | ||||||||||||||
Dichiarazione di conformità presentata il 07 feb 2018 senza aggiornamenti | 3 pagine | CS01 | ||||||||||||||
L'indirizzo di ispezione del registro è stato modificato da C/O Bond Dickinson Llp St Ann's Wharf 112 Quayside Newcastle upon Tyne NE1 3DX England a C/O Womble Bond Dickinson (Uk) Llp St Ann's Wharf 112 Quayside Newcastle upon Tyne NE1 3DX | 1 pagine | AD02 | ||||||||||||||
I registri sono stati trasferiti al luogo di ispezione registrato C/O Bond Dickinson Llp St Ann's Wharf 112 Quayside Newcastle upon Tyne NE1 3DX | 1 pagine | AD03 | ||||||||||||||
Conto per una società dormiente redatto al 31 dic 2016 | 8 pagine | AA | ||||||||||||||
Cessazione della carica di Philip John Kite come segretario in data 28 mar 2017 | 1 pagine | TM02 | ||||||||||||||
Cessazione della carica di Philip John Kite come amministratore in data 28 mar 2017 | 1 pagine | TM01 | ||||||||||||||
Cessazione della carica di Roger David Anderton come amministratore in data 28 feb 2017 | 1 pagine | TM01 | ||||||||||||||
Dichiarazione di conformità presentata il 07 feb 2017 con aggiornamenti | 5 pagine | CS01 | ||||||||||||||
Conto per una società dormiente redatto al 31 dic 2015 | 9 pagine | AA | ||||||||||||||
Nomina di Graeme Cook come amministratore in data 24 ago 2015 | 2 pagine | AP01 | ||||||||||||||
Cessazione della carica di Steven Norman Simpson come amministratore in data 29 feb 2016 | 1 pagine | TM01 | ||||||||||||||
Bilancio annuale redatto al 07 feb 2016 con elenco completo degli azionisti | 5 pagine | AR01 | ||||||||||||||
| ||||||||||||||||
Conto per una società dormiente redatto al 31 dic 2014 | 8 pagine | AA | ||||||||||||||
Indirizzo della sede legale modificato da Wincomblee Road Walker Newcastle upon Tyne NE6 3QS a Armstrong Works Scotswood Road Newcastle upon Tyne NE15 6UX in data 31 lug 2015 | 1 pagine | AD01 | ||||||||||||||
Chi sono gli amministratori di EXACT MACHINING UK LIMITED?
| Nome | Nominato il | Dimissioni il | Ruolo | Indirizzo | Identificazione della società | Paese di residenza | Nazionalità | Data di nascita | Professione | Numero |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| REECE, John Peter | Amministratore | Scotswood Road NE15 6UX Newcastle Upon Tyne Armstrong Works United Kingdom | United Kingdom | British | Director | 10546590006 | ||||
| BORRELL, Arthur James Peter | Segretario | Pinedale Wallace Avenue NE16 4SX Whickham County Durham | British | 47328860003 | ||||||
| KITE, Philip John | Segretario | Scotswood Road NE15 6UX Newcastle Upon Tyne Armstrong Works United Kingdom | 174187170001 | |||||||
| MYHILL, John Robert | Segretario | Greenfield Place NE40 3LY Ryton 5 Tyne And Wear United Kingdom | British | Managing Director | 101317280002 | |||||
| SIMPSON, Steven Norman | Segretario | Garesfield Lodge Lintzford Grange NE39 1HL Rowlands Gill Tyne And Wear | British | Director | 49838890001 | |||||
| THOMPSON, Christopher Scott | Segretario | Highfield House Woodhill Farm NE20 0JA Ponteland Newcastle Upon Tyne | British | 42840520001 | ||||||
| ANDERTON, Roger David | Amministratore | Scotswood Road NE15 6UX Newcastle Upon Tyne Armstrong Works United Kingdom | United Kingdom | British | Director | 99166030001 | ||||
| BERNARD, Peter Barry | Amministratore | Washing Well House 3 Front Street Whickham NE16 4HF Newcastle Upon Tyne Tyne & Wear | United Kingdom | British | Director | 19362840002 | ||||
| BLAKEY, Michael Vincent | Amministratore | The Hayloft 3 Newton Red House NE61 3QW Mitford Morpeth Northumberland | United Kingdom | British | Director | 98034890002 | ||||
| BURGESS, Stanley | Amministratore | 11 Cleadon Lea Cleadon SR6 7TQ Sunderland Tyne & Wear | United Kingdom | British | Engineer | 5778820001 | ||||
| COOK, Graeme | Amministratore | Scotswood Road NE15 6UX Newcastle Upon Tyne Armstrong Works United Kingdom | United Kingdom | British | Managing Director | 208180310001 | ||||
| KITE, Philip John | Amministratore | Scotswood Road NE15 6UX Newcastle Upon Tyne Armstrong Works United Kingdom | United Kingdom | British | Director | 166586060001 | ||||
| MACKIE, Robin James Dermot | Amministratore | 72 Reid Park Road Jesmond NE2 2ES Newcastle Upon Tyne | United Kingdom | British | Director | 9502380001 | ||||
| MARTIN, John | Amministratore | 22 Wellfield Court Westburn NE40 4HA Crawcrook Tyne & Wear | British | Director | 107956790001 | |||||
| MYHILL, John Robert | Amministratore | Greenfield Place NE40 3LY Ryton 5 Tyne And Wear United Kingdom | United Kingdom | British | Engineer | 101317280002 | ||||
| PATTISON, Steven | Amministratore | 8 Chandlers Ford Mount Pleasant DH4 7SB Washington Tyne & Wear | British | Precision Engineer | 61145440001 | |||||
| REED, Robert | Amministratore | 26 St Andrews Drive NE9 6JT Low Fell Tyne & Wear | United Kingdom | British | Company Director | 112010820001 | ||||
| SIMPSON, Steven Norman | Amministratore | Garesfield Lodge Lintzford Grange NE39 1HL Rowlands Gill Tyne And Wear | England | British | Director | 49838890001 | ||||
| THOMPSON, Christopher Scott | Amministratore | 98 Elmfield Road NE3 4BD Newcastle Upon Tyne | United Kingdom | British | Engineer | 42840520008 | ||||
| THOMPSON, Keith Fulton Scott | Amministratore | 22 Linden Way Ponteland NE20 9DP Newcastle Upon Tyne Tyne & Wear | British | Engineer | 11845980001 |
Chi sono le persone con controllo significativo di EXACT MACHINING UK LIMITED?
| Nome | Notificato il | Indirizzo | Cessato | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Exact Machining (Holdings) Limited | 06 apr 2016 | Scotswood Road NE15 6UX Newcastle Upon Tyne Armstrong Works United Kingdom | No | ||||||||||
| |||||||||||||
Natura del controllo
| |||||||||||||
EXACT MACHINING UK LIMITED ha ipoteche?
| Classificazione | Date | Stato | Dettagli | |
|---|---|---|---|---|
| Deed of admission to an omnibus guarantee and set-off agreement | Creato il 05 giu 2009 Consegnato il 06 giu 2009 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due or to become due from the company and/or all or any of the companies named therein to the chargee on any account whatsoever | |
Brevi particolari Any sum standing to the credit of any one or more of any present or future accounts of the companies or any of them with the bank (including any accounts held in the bank's name with any designation which includes the name(s) of the companies or any of them) whether such accounts be denominated in sterling or in a currency or currencies other than sterling. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
| An omnibus guarantee and set-off agreement | Creato il 07 mar 2003 Consegnato il 14 mar 2003 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due or to become due from the company and/or all or any of the other companies named therein to the chargee on any account whatsoever | |
Brevi particolari Any sums or sums for the time being standing to the credit of any present or future account of the company with the bank. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
| Omnibus guarantee and set-off agreement | Creato il 16 set 2002 Consegnato il 20 set 2002 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due or to become due from the company and/or all or any of the other companies named therein to the chargee on any account whatsoever | |
Brevi particolari Any sum or sums for the time being standing to the credit of any present or future account of the company with the bank. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
| Fixed charge | Creato il 01 lug 1997 Consegnato il 02 lug 1997 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Brevi particolari A first fixed charge over the goods listed in the schedule. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
| Fixed charge | Creato il 24 mar 1994 Consegnato il 25 mar 1994 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito £99,000.00 and all other monies due or to become due from the company to the chargee | |
Brevi particolari Fixed charge over robofil 510 wire edm machining centre serial no. 550-052 built in generator serial no. 420-12 with cooling model no. Mc WD0055 and autotransformer model no. Ma CA5503. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
| Letter of set-off | Creato il 16 mar 1987 Consegnato il 27 mar 1987 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due or to become due from the company and/or all or any of the other companies named therein to the chargee | |
Brevi particolari Any sum or sums standing to the credit of any present or future account of the company with the bank. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
| Single debenture | Creato il 03 feb 1987 Consegnato il 06 feb 1987 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Brevi particolari Stocks shares & securities.. Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
Fonte dati
- Companies House del Regno Unito
Il registro ufficiale delle imprese nel Regno Unito, che fornisce l'accesso pubblico alle informazioni sulle imprese, come nomi, indirizzi, amministratori e depositi finanziari. - Licenza: CC0