EXACT MACHINING UK LIMITED

EXACT MACHINING UK LIMITED

  • Panoramica
  • Riepilogo
  • Scopo
  • Indirizzo
  • Denominazioni precedenti
  • Bilanci
  • Deposizioni
  • Amministratori
  • Persone con controllo significativo
  • Ipoteche
  • Fonte dati
  • Panoramica

    Nome della societàEXACT MACHINING UK LIMITED
    Stato della societàSciolta
    Forma giuridicaSocietà a responsabilità limitata
    Numero di società 01863369
    GiurisdizioneInghilterra/Galles
    Data di costituzione
    Data di cessazione

    Qual è lo scopo di EXACT MACHINING UK LIMITED?

    • lavorazioni meccaniche (25620) / Industrie manifatturiere

    Dove si trova EXACT MACHINING UK LIMITED?

    Indirizzo della sede legale
    Armstrong Works
    Scotswood Road
    NE15 6UX Newcastle Upon Tyne
    United Kingdom
    Indirizzo della sede legale non recapitabileNo

    Quali erano i nomi precedenti di EXACT MACHINING UK LIMITED?

    Denominazioni sociali precedenti
    Nome della societàDaA
    EXACT ENGINEERING (THOMPSON) LIMITED14 nov 198414 nov 1984

    Quali sono gli ultimi bilanci di EXACT MACHINING UK LIMITED?

    Ultimi bilanci
    Ultimi bilanci redatti al31 dic 2018

    Quali sono le ultime deposizioni per EXACT MACHINING UK LIMITED?

    Deposizioni
    DataDescrizioneDocumentoTipo

    Gazzetta Ufficiale finale sciolta per scioglimento volontario

    1 pagineGAZ2(A)

    Prima Gazzetta Ufficiale per lo scioglimento volontario

    1 pagineGAZ1(A)

    Richiesta di cancellazione della società dal registro

    3 pagineDS01

    Conto per una società dormiente redatto al 31 dic 2018

    8 pagineAA

    legacy

    1 pagineSH20

    Stato del capitale al 26 set 2019

    • Capitale: GBP 1.00
    3 pagineSH19

    legacy

    1 pagineCAP-SS

    Risoluzioni

    Resolutions
    2 pagineRESOLUTIONS
    Risoluzioni
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    capital

    Risoluzioni

    Cancelling extinguishing of orinding shares 11/09/2019
    RES13
    capital

    Risoluzione di riduzione del capitale sociale emesso

    RES06

    Cessazione della carica di Graeme Cook come amministratore in data 05 apr 2019

    1 pagineTM01

    Dichiarazione di conformità presentata il 07 feb 2019 senza aggiornamenti

    3 pagineCS01

    Conto per una società dormiente redatto al 31 dic 2017

    8 pagineAA

    Dichiarazione di conformità presentata il 07 feb 2018 senza aggiornamenti

    3 pagineCS01

    L'indirizzo di ispezione del registro è stato modificato da C/O Bond Dickinson Llp St Ann's Wharf 112 Quayside Newcastle upon Tyne NE1 3DX England a C/O Womble Bond Dickinson (Uk) Llp St Ann's Wharf 112 Quayside Newcastle upon Tyne NE1 3DX

    1 pagineAD02

    I registri sono stati trasferiti al luogo di ispezione registrato C/O Bond Dickinson Llp St Ann's Wharf 112 Quayside Newcastle upon Tyne NE1 3DX

    1 pagineAD03

    Conto per una società dormiente redatto al 31 dic 2016

    8 pagineAA

    Cessazione della carica di Philip John Kite come segretario in data 28 mar 2017

    1 pagineTM02

    Cessazione della carica di Philip John Kite come amministratore in data 28 mar 2017

    1 pagineTM01

    Cessazione della carica di Roger David Anderton come amministratore in data 28 feb 2017

    1 pagineTM01

    Dichiarazione di conformità presentata il 07 feb 2017 con aggiornamenti

    5 pagineCS01

    Conto per una società dormiente redatto al 31 dic 2015

    9 pagineAA

    Nomina di Graeme Cook come amministratore in data 24 ago 2015

    2 pagineAP01

    Cessazione della carica di Steven Norman Simpson come amministratore in data 29 feb 2016

    1 pagineTM01

    Bilancio annuale redatto al 07 feb 2016 con elenco completo degli azionisti

    5 pagineAR01
    Deposizioni associate
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    capital10 feb 2016

    Stato del capitale al 10 feb 2016

    • Capitale: GBP 18,000
    SH01

    Conto per una società dormiente redatto al 31 dic 2014

    8 pagineAA

    Indirizzo della sede legale modificato da Wincomblee Road Walker Newcastle upon Tyne NE6 3QS a Armstrong Works Scotswood Road Newcastle upon Tyne NE15 6UX in data 31 lug 2015

    1 pagineAD01

    Chi sono gli amministratori di EXACT MACHINING UK LIMITED?

    Amministratori
    NomeNominato ilDimissioni ilRuoloIndirizzoIdentificazione della societàPaese di residenzaNazionalitàData di nascitaProfessioneNumero
    REECE, John Peter
    Scotswood Road
    NE15 6UX Newcastle Upon Tyne
    Armstrong Works
    United Kingdom
    Amministratore
    Scotswood Road
    NE15 6UX Newcastle Upon Tyne
    Armstrong Works
    United Kingdom
    United KingdomBritishDirector10546590006
    BORRELL, Arthur James Peter
    Pinedale
    Wallace Avenue
    NE16 4SX Whickham
    County Durham
    Segretario
    Pinedale
    Wallace Avenue
    NE16 4SX Whickham
    County Durham
    British47328860003
    KITE, Philip John
    Scotswood Road
    NE15 6UX Newcastle Upon Tyne
    Armstrong Works
    United Kingdom
    Segretario
    Scotswood Road
    NE15 6UX Newcastle Upon Tyne
    Armstrong Works
    United Kingdom
    174187170001
    MYHILL, John Robert
    Greenfield Place
    NE40 3LY Ryton
    5
    Tyne And Wear
    United Kingdom
    Segretario
    Greenfield Place
    NE40 3LY Ryton
    5
    Tyne And Wear
    United Kingdom
    BritishManaging Director101317280002
    SIMPSON, Steven Norman
    Garesfield Lodge
    Lintzford Grange
    NE39 1HL Rowlands Gill
    Tyne And Wear
    Segretario
    Garesfield Lodge
    Lintzford Grange
    NE39 1HL Rowlands Gill
    Tyne And Wear
    BritishDirector49838890001
    THOMPSON, Christopher Scott
    Highfield House
    Woodhill Farm
    NE20 0JA Ponteland
    Newcastle Upon Tyne
    Segretario
    Highfield House
    Woodhill Farm
    NE20 0JA Ponteland
    Newcastle Upon Tyne
    British42840520001
    ANDERTON, Roger David
    Scotswood Road
    NE15 6UX Newcastle Upon Tyne
    Armstrong Works
    United Kingdom
    Amministratore
    Scotswood Road
    NE15 6UX Newcastle Upon Tyne
    Armstrong Works
    United Kingdom
    United KingdomBritishDirector99166030001
    BERNARD, Peter Barry
    Washing Well House 3 Front Street
    Whickham
    NE16 4HF Newcastle Upon Tyne
    Tyne & Wear
    Amministratore
    Washing Well House 3 Front Street
    Whickham
    NE16 4HF Newcastle Upon Tyne
    Tyne & Wear
    United KingdomBritishDirector19362840002
    BLAKEY, Michael Vincent
    The Hayloft
    3 Newton Red House
    NE61 3QW Mitford Morpeth
    Northumberland
    Amministratore
    The Hayloft
    3 Newton Red House
    NE61 3QW Mitford Morpeth
    Northumberland
    United KingdomBritishDirector98034890002
    BURGESS, Stanley
    11 Cleadon Lea
    Cleadon
    SR6 7TQ Sunderland
    Tyne & Wear
    Amministratore
    11 Cleadon Lea
    Cleadon
    SR6 7TQ Sunderland
    Tyne & Wear
    United KingdomBritishEngineer5778820001
    COOK, Graeme
    Scotswood Road
    NE15 6UX Newcastle Upon Tyne
    Armstrong Works
    United Kingdom
    Amministratore
    Scotswood Road
    NE15 6UX Newcastle Upon Tyne
    Armstrong Works
    United Kingdom
    United KingdomBritishManaging Director208180310001
    KITE, Philip John
    Scotswood Road
    NE15 6UX Newcastle Upon Tyne
    Armstrong Works
    United Kingdom
    Amministratore
    Scotswood Road
    NE15 6UX Newcastle Upon Tyne
    Armstrong Works
    United Kingdom
    United KingdomBritishDirector166586060001
    MACKIE, Robin James Dermot
    72 Reid Park Road
    Jesmond
    NE2 2ES Newcastle Upon Tyne
    Amministratore
    72 Reid Park Road
    Jesmond
    NE2 2ES Newcastle Upon Tyne
    United KingdomBritishDirector9502380001
    MARTIN, John
    22 Wellfield Court
    Westburn
    NE40 4HA Crawcrook
    Tyne & Wear
    Amministratore
    22 Wellfield Court
    Westburn
    NE40 4HA Crawcrook
    Tyne & Wear
    BritishDirector107956790001
    MYHILL, John Robert
    Greenfield Place
    NE40 3LY Ryton
    5
    Tyne And Wear
    United Kingdom
    Amministratore
    Greenfield Place
    NE40 3LY Ryton
    5
    Tyne And Wear
    United Kingdom
    United KingdomBritishEngineer101317280002
    PATTISON, Steven
    8 Chandlers Ford
    Mount Pleasant
    DH4 7SB Washington
    Tyne & Wear
    Amministratore
    8 Chandlers Ford
    Mount Pleasant
    DH4 7SB Washington
    Tyne & Wear
    BritishPrecision Engineer61145440001
    REED, Robert
    26 St Andrews Drive
    NE9 6JT Low Fell
    Tyne & Wear
    Amministratore
    26 St Andrews Drive
    NE9 6JT Low Fell
    Tyne & Wear
    United KingdomBritishCompany Director112010820001
    SIMPSON, Steven Norman
    Garesfield Lodge
    Lintzford Grange
    NE39 1HL Rowlands Gill
    Tyne And Wear
    Amministratore
    Garesfield Lodge
    Lintzford Grange
    NE39 1HL Rowlands Gill
    Tyne And Wear
    EnglandBritishDirector49838890001
    THOMPSON, Christopher Scott
    98 Elmfield Road
    NE3 4BD Newcastle Upon Tyne
    Amministratore
    98 Elmfield Road
    NE3 4BD Newcastle Upon Tyne
    United KingdomBritishEngineer42840520008
    THOMPSON, Keith Fulton Scott
    22 Linden Way
    Ponteland
    NE20 9DP Newcastle Upon Tyne
    Tyne & Wear
    Amministratore
    22 Linden Way
    Ponteland
    NE20 9DP Newcastle Upon Tyne
    Tyne & Wear
    BritishEngineer11845980001

    Chi sono le persone con controllo significativo di EXACT MACHINING UK LIMITED?

    Persone con controllo significativo
    NomeNotificato ilIndirizzoCessato
    Scotswood Road
    NE15 6UX Newcastle Upon Tyne
    Armstrong Works
    United Kingdom
    06 apr 2016
    Scotswood Road
    NE15 6UX Newcastle Upon Tyne
    Armstrong Works
    United Kingdom
    No
    Forma giuridicaLimited By Shares
    Paese di registrazioneEngland And Wales
    Autorità legaleUnited Kingdom (England And Wales)
    Luogo di registrazioneCompanies House
    Numero di registrazione04616726
    Natura del controllo
    • La persona possiede, direttamente o indirettamente, più del 75% delle azioni della società.
    • La persona detiene, direttamente o indirettamente, più del 75% dei diritti di voto nella società.
    • La persona ha il diritto, direttamente o indirettamente, di nominare o rimuovere la maggioranza del consiglio di amministrazione della società.

    EXACT MACHINING UK LIMITED ha ipoteche?

    Ipoteche
    ClassificazioneDateStatoDettagli
    Deed of admission to an omnibus guarantee and set-off agreement
    Creato il 05 giu 2009
    Consegnato il 06 giu 2009
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company and/or all or any of the companies named therein to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Any sum standing to the credit of any one or more of any present or future accounts of the companies or any of them with the bank (including any accounts held in the bank's name with any designation which includes the name(s) of the companies or any of them) whether such accounts be denominated in sterling or in a currency or currencies other than sterling.
    Persone aventi diritto
    • Lloyds Tsb Bank PLC
    Transazioni
    • 06 giu 2009Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 08 ago 2009Dichiarazione che parte o tutta la proprietà di un onere fluttuante è stata liberata (403b)
    • 07 dic 2012Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (MG02)
    An omnibus guarantee and set-off agreement
    Creato il 07 mar 2003
    Consegnato il 14 mar 2003
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company and/or all or any of the other companies named therein to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Any sums or sums for the time being standing to the credit of any present or future account of the company with the bank.
    Persone aventi diritto
    • Lloyds Tsb Bank PLC
    Transazioni
    • 14 mar 2003Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 27 lug 2007Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Omnibus guarantee and set-off agreement
    Creato il 16 set 2002
    Consegnato il 20 set 2002
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company and/or all or any of the other companies named therein to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Any sum or sums for the time being standing to the credit of any present or future account of the company with the bank.
    Persone aventi diritto
    • Lloyds Tsb Bank PLC
    Transazioni
    • 20 set 2002Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 27 lug 2007Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Fixed charge
    Creato il 01 lug 1997
    Consegnato il 02 lug 1997
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    A first fixed charge over the goods listed in the schedule. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Lloyds Bowmaker Limited
    Transazioni
    • 02 lug 1997Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 27 lug 2007Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Fixed charge
    Creato il 24 mar 1994
    Consegnato il 25 mar 1994
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    £99,000.00 and all other monies due or to become due from the company to the chargee
    Brevi particolari
    Fixed charge over robofil 510 wire edm machining centre serial no. 550-052 built in generator serial no. 420-12 with cooling model no. Mc WD0055 and autotransformer model no. Ma CA5503.
    Persone aventi diritto
    • Lloyds Bowmaker Limited
    Transazioni
    • 25 mar 1994Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 27 lug 2007Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Letter of set-off
    Creato il 16 mar 1987
    Consegnato il 27 mar 1987
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company and/or all or any of the other companies named therein to the chargee
    Brevi particolari
    Any sum or sums standing to the credit of any present or future account of the company with the bank.
    Persone aventi diritto
    • Lloyds Bank PLC
    Transazioni
    • 27 mar 1987Registrazione di un'ipoteca
    • 27 lug 2007Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Single debenture
    Creato il 03 feb 1987
    Consegnato il 06 feb 1987
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Stocks shares & securities.. Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Persone aventi diritto
    • Lloyds Bank PLC
    Transazioni
    • 06 feb 1987Registrazione di un'ipoteca
    • 08 ago 2009Dichiarazione che parte o tutta la proprietà di un onere fluttuante è stata liberata (403b)
    • 07 dic 2012Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (MG02)

    Fonte dati

    • Companies House del Regno Unito
      Il registro ufficiale delle imprese nel Regno Unito, che fornisce l'accesso pubblico alle informazioni sulle imprese, come nomi, indirizzi, amministratori e depositi finanziari.
    • Licenza: CC0