REALMOAK DEVELOPMENTS LIMITED

REALMOAK DEVELOPMENTS LIMITED

  • Panoramica
  • Riepilogo
  • Scopo
  • Indirizzo
  • Denominazioni precedenti
  • Bilanci
  • Deposizioni
  • Amministratori
  • Persone con controllo significativo
  • Ipoteche
  • Fonte dati
  • Panoramica

    Nome della societàREALMOAK DEVELOPMENTS LIMITED
    Stato della societàSciolta
    Forma giuridicaSocietà a responsabilità limitata
    Numero di società 01863478
    GiurisdizioneInghilterra/Galles
    Data di costituzione
    Data di cessazione

    Qual è lo scopo di REALMOAK DEVELOPMENTS LIMITED?

    • Società non commerciali (74990) / Attività professionali, scientifiche e tecniche

    Dove si trova REALMOAK DEVELOPMENTS LIMITED?

    Indirizzo della sede legale
    Ivy Cottage
    Lodge Road
    MK43 0BQ Cranfield
    Indirizzo della sede legale non recapitabileNo

    Quali erano i nomi precedenti di REALMOAK DEVELOPMENTS LIMITED?

    Denominazioni sociali precedenti
    Nome della societàDaA
    MALTWOOD LIMITED14 nov 198414 nov 1984

    Quali sono gli ultimi bilanci di REALMOAK DEVELOPMENTS LIMITED?

    Ultimi bilanci
    Ultimi bilanci redatti al31 dic 2017

    Quali sono le ultime deposizioni per REALMOAK DEVELOPMENTS LIMITED?

    Deposizioni
    DataDescrizioneDocumentoTipo

    Gazzetta Ufficiale finale sciolta per scioglimento volontario

    1 pagineGAZ2(A)

    Prima Gazzetta Ufficiale per lo scioglimento volontario

    1 pagineGAZ1(A)

    Richiesta di cancellazione della società dal registro

    3 pagineDS01

    Conto per una società dormiente redatto al 31 dic 2017

    2 pagineAA

    Dichiarazione di conformità presentata il 20 nov 2017 senza aggiornamenti

    3 pagineCS01

    Conto per una società dormiente redatto al 31 dic 2016

    3 pagineAA

    Dichiarazione di conformità presentata il 20 nov 2016 con aggiornamenti

    5 pagineCS01

    Conto per una società dormiente redatto al 31 dic 2015

    3 pagineAA

    Bilancio annuale redatto al 20 nov 2015 con elenco completo degli azionisti

    4 pagineAR01
    Deposizioni associate
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    capital23 nov 2015

    Stato del capitale al 23 nov 2015

    • Capitale: GBP 2
    SH01

    Conto per una società dormiente redatto al 31 dic 2014

    3 pagineAA

    Nomina di Mrs Anne Elizabeth Dimmock come segretario in data 03 dic 2014

    2 pagineAP03

    Nomina di Mr Trevor Thomas Dimmock come amministratore in data 03 dic 2014

    2 pagineAP01

    Cessazione della carica di Colin Deryk Grant come amministratore in data 03 dic 2014

    1 pagineTM01

    Cessazione della carica di Diane Patricia Duff come amministratore in data 03 dic 2014

    1 pagineTM01

    Cessazione della carica di Allen Jack Duff come amministratore in data 03 dic 2014

    1 pagineTM01

    Cessazione della carica di Diane Patricia Duff come segretario in data 03 dic 2014

    1 pagineTM02

    Bilancio annuale redatto al 20 nov 2014 con elenco completo degli azionisti

    6 pagineAR01
    Deposizioni associate
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    capital23 nov 2014

    Stato del capitale al 23 nov 2014

    • Capitale: GBP 2
    SH01

    Conto per una società dormiente redatto al 31 dic 2013

    2 pagineAA

    Bilancio annuale redatto al 20 nov 2013 con elenco completo degli azionisti

    6 pagineAR01
    Deposizioni associate
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    capital27 dic 2013

    Stato del capitale al 27 dic 2013

    • Capitale: GBP 2
    SH01

    Dettagli del direttore cambiati per Allen Jack Duff il 24 dic 2013

    2 pagineCH01

    Dettagli del direttore cambiati per Colin Deryk Grant il 24 dic 2013

    2 pagineCH01

    Dettagli del direttore cambiati per Mrs Diane Patricia Duff il 24 dic 2013

    2 pagineCH01

    Indirizzo della sede legale modificato da * Sovereign Court 230 Upper Fifth Street Central Milton Keynes MK9 2HR* in data 04 mar 2013

    1 pagineAD01

    Bilancio annuale redatto al 20 nov 2012 con elenco completo degli azionisti

    16 pagineAR01

    Bilancio annuale redatto al 20 nov 2011 con elenco completo degli azionisti

    16 pagineAR01

    Chi sono gli amministratori di REALMOAK DEVELOPMENTS LIMITED?

    Amministratori
    NomeNominato ilDimissioni ilRuoloIndirizzoIdentificazione della societàPaese di residenzaNazionalitàData di nascitaProfessioneNumero
    DIMMOCK, Anne Elizabeth
    Lodge Road
    Cranfield
    MK43 0BQ Bedford
    Ivy House
    England
    Segretario
    Lodge Road
    Cranfield
    MK43 0BQ Bedford
    Ivy House
    England
    193507400001
    DIMMOCK, Trevor Thomas
    Lodge Road
    Cranfield
    MK43 0BQ Bedford
    Ivy House
    England
    Amministratore
    Lodge Road
    Cranfield
    MK43 0BQ Bedford
    Ivy House
    England
    EnglandBritish18308590001
    DUFF, Diane Patricia
    1 Cottisford Crescent
    Great Linford
    MK14 5HH Milton Keynes
    Buckinghamshire
    Segretario
    1 Cottisford Crescent
    Great Linford
    MK14 5HH Milton Keynes
    Buckinghamshire
    British20054150001
    FALLA, Rudiger Michael
    Le Repere
    Les Echelons, St. Peter Port
    GY1 1AT Guernsey
    Channel Islands
    Segretario
    Le Repere
    Les Echelons, St. Peter Port
    GY1 1AT Guernsey
    Channel Islands
    British66055180001
    INTERNATIONAL SECRETARIES INC
    Calle 50
    No 102 Edificio Universal
    FOREIGN Panama
    Republic Of Panama
    Segretario
    Calle 50
    No 102 Edificio Universal
    FOREIGN Panama
    Republic Of Panama
    72532700001
    JB SECRETARIES (GUERNSEY) LIMITED
    Lefebvre Court Lefebvre Street
    St Peters Port
    GY1 3BS Guernsey
    Channelislands
    Segretario
    Lefebvre Court Lefebvre Street
    St Peters Port
    GY1 3BS Guernsey
    Channelislands
    64208720001
    ARKLIE, James Lushington
    Anson Court
    La Routes Des Camps St Martins
    GY1 3UG Guernsey
    Amministratore
    Anson Court
    La Routes Des Camps St Martins
    GY1 3UG Guernsey
    British106433510001
    BACHMANN, Peter John
    Sir William Place
    GY1 4HQ St Peter Port
    Frances House
    Guernsey
    Amministratore
    Sir William Place
    GY1 4HQ St Peter Port
    Frances House
    Guernsey
    GuernseyBritish132272610001
    BROWN, Michael James
    Les Rosiers Les Tracheries
    L'Islet St Sampsons
    GY2 4SW Guernsey
    Channel Islands
    Amministratore
    Les Rosiers Les Tracheries
    L'Islet St Sampsons
    GY2 4SW Guernsey
    Channel Islands
    GuernseyBritish43814930001
    BURNS, Ian Michael
    La Maison Godaine
    La Viliette
    St Martins
    Guernsey
    Amministratore
    La Maison Godaine
    La Viliette
    St Martins
    Guernsey
    GuernseyBritish164296290001
    DOGGART, James Graham
    Delamere House
    Les Canus St Sampson
    GY2 4UJ Guernsey
    Channel Islands
    Amministratore
    Delamere House
    Les Canus St Sampson
    GY2 4UJ Guernsey
    Channel Islands
    British60816780001
    DUFF, Allen Jack
    1 Cottisford Crescent
    Great Linford
    MK14 5HH Milton Keynes
    Buckinghamshire
    Amministratore
    1 Cottisford Crescent
    Great Linford
    MK14 5HH Milton Keynes
    Buckinghamshire
    EnglandBritish12565450001
    DUFF, Diane Patricia
    1 Cottisford Crescent
    Great Linford
    MK14 5HH Milton Keynes
    Buckinghamshire
    Amministratore
    1 Cottisford Crescent
    Great Linford
    MK14 5HH Milton Keynes
    Buckinghamshire
    EnglandBritish20054150001
    FALLA, Rudiger Michael
    Le Repere
    Les Echelons, St. Peter Port
    GY1 1AT Guernsey
    Channel Islands
    Amministratore
    Le Repere
    Les Echelons, St. Peter Port
    GY1 1AT Guernsey
    Channel Islands
    GuernseyBritish66055180001
    GRANT, Colin Deryk
    5 Wharf Terrace
    Deodar Road
    SW15 2JZ London
    Amministratore
    5 Wharf Terrace
    Deodar Road
    SW15 2JZ London
    EnglandBritish87100840002
    GRANT, Colin Deryck
    Frances House
    Sir William Place
    CHANNEL St Peter Port
    Guernsey
    Amministratore
    Frances House
    Sir William Place
    CHANNEL St Peter Port
    Guernsey
    British8869520001
    HILTON, Leslie
    Frances House Sir William Place
    St Peter Port
    CHANNEL Guernsey
    Channel Islands
    Amministratore
    Frances House Sir William Place
    St Peter Port
    CHANNEL Guernsey
    Channel Islands
    British58853560001
    MACLEAN, Robert Anthony
    10 Rue Blavignac
    1227 Carouge
    Geneva
    Switzerland
    Amministratore
    10 Rue Blavignac
    1227 Carouge
    Geneva
    Switzerland
    British18200780001
    MARGETTS SMITH, Nicola Jane
    Lefebvre Court
    Lefebvre Street, St. Peter Port
    GY1 2JP Guernsey
    Channel Islands
    Amministratore
    Lefebvre Court
    Lefebvre Street, St. Peter Port
    GY1 2JP Guernsey
    Channel Islands
    British67490310001
    SHAW, Christopher Henry
    15 La Reserve
    Les Amballes
    GY1 1WT St Peter Port
    Channel Islands
    Amministratore
    15 La Reserve
    Les Amballes
    GY1 1WT St Peter Port
    Channel Islands
    GuernseyBritish79395470001
    SMITH, David Brian
    6 Les Cherfs Rue Des Corneilles
    Castel
    GY5 7HG Guernsey
    Channel Island
    Amministratore
    6 Les Cherfs Rue Des Corneilles
    Castel
    GY5 7HG Guernsey
    Channel Island
    British60816680001
    VINE, John William
    Lefebvre Court
    Lefebvre Street, St. Peter Port
    GY1 2JP Guernsey
    Channel Islands
    Amministratore
    Lefebvre Court
    Lefebvre Street, St. Peter Port
    GY1 2JP Guernsey
    Channel Islands
    British67490300002
    INTERNATIONAL DIRECTORS INC
    Calle 50
    FOREIGN 102 Edificio Universal 5
    Panama
    Amministratore
    Calle 50
    FOREIGN 102 Edificio Universal 5
    Panama
    25229290001

    Chi sono le persone con controllo significativo di REALMOAK DEVELOPMENTS LIMITED?

    Persone con controllo significativo
    NomeNotificato ilIndirizzoCessato
    Mr Trevor Thomas Dimmock
    Lodge Road
    Cranfield
    MK43 0BQ Bedford
    Ivy House, Lodge Road
    England
    30 giu 2016
    Lodge Road
    Cranfield
    MK43 0BQ Bedford
    Ivy House, Lodge Road
    England
    No
    Nazionalità: British
    Paese di residenza: United Kingdom
    Natura del controllo
    • La persona ha il diritto di esercitare, o esercita effettivamente, un'influenza significativa o un controllo sulla società.

    REALMOAK DEVELOPMENTS LIMITED ha ipoteche?

    Ipoteche
    ClassificazioneDateStatoDettagli
    Standard security
    Creato il 26 nov 1986
    Consegnato il 01 dic 1986
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee
    Brevi particolari
    12.6 hectares at north side of gallowgate, parkhead, glasgow t/n gla 487.
    Persone aventi diritto
    • Buckfield Properties Limited
    Transazioni
    • 01 dic 1986Registrazione di un'ipoteca
    • 14 gen 1987Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Standard security presented in scotland for registration on the 24TH april 1986
    Creato il 24 apr 1986
    Consegnato il 02 mag 1986
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee in terms of a personal bond dated 21ST february 1986
    Brevi particolari
    1304 duke street, parkhead, glasgow t/n gla 7779.
    Persone aventi diritto
    • National Commercial & Glyns Limited
    Transazioni
    • 02 mag 1986Registrazione di un'ipoteca
    • 14 gen 1987Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Standard security presented in scotland for registration on 24TH april 1986
    Creato il 24 apr 1986
    Consegnato il 02 mag 1986
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee in terms of a personal bond dated 29TH november 1985
    Brevi particolari
    1304 duke street, parkhead, glasgow t/n gla 7779.
    Persone aventi diritto
    • The Royal Bank of Scotland PLC
    Transazioni
    • 02 mag 1986Registrazione di un'ipoteca
    • 14 gen 1987Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Standard security presented in scotland for registration 9TH april 1986
    Creato il 09 apr 1986
    Consegnato il 16 apr 1986
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee in terms of a personal bond dated 29TH november 1985
    Brevi particolari
    1310/1322 duke street, 31 dunbar street and 16 ewing place, parkhead, glasgow t/n gla 7032.
    Persone aventi diritto
    • The Royal Bank of Scotland PLC
    Transazioni
    • 16 apr 1986Registrazione di un'ipoteca
    • 14 gen 1987Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Standard security presented in scotland for registration
    Creato il 09 apr 1986
    Consegnato il 16 apr 1986
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee in terms of personal bond dated 21ST february 1986
    Brevi particolari
    1310/1322 duke street, 31 dunbar street and 16 ewing place, parkhead, glasgow t/n gla 7032.
    Persone aventi diritto
    • National Commercial & Glyns Limited
    Transazioni
    • 16 apr 1986Registrazione di un'ipoteca
    • 14 gen 1987Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Standard security presented in scotland for registration on the 26TH february 1986
    Creato il 26 feb 1986
    Consegnato il 04 mar 1986
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee in terms of a personal bond dated 21/02/86
    Brevi particolari
    A) "site 2" parkhead forge and 1250/1256 duke street and 1291 gallowgate and 1271/1279 gallowgate t/n gla 487 b) sites 1 & 6 parkhead forge t/n gla 488 c) sites 3, 4 & 5 parkhead forge t/n gla 489 d) 46 to 96 & 37 to 67 dunbar street parkhead t/n gla 1154 e) 17 croydon street parkhead t/n gla 2484 f) 17/19 ewing place, parkhead t/n gla 3416 g) 1262-1272 duke street & 3-15 croydon street and 1286/1288 duke street t/n gla 3697.
    Persone aventi diritto
    • National Commercial & Glyns Limited
    Transazioni
    • 04 mar 1986Registrazione di un'ipoteca
    • 14 gen 1987Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Standard security presented for registration in scotland 26TH februrary 1986
    Creato il 26 feb 1986
    Consegnato il 04 mar 1986
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee
    Brevi particolari
    1271/1279 gallogate t/n gla 487 sites 1 & 6 parkhead forge t/n gla 488. sites 3,4 & 5 parkhead forge t/n gla 489. 46 to 96 and 37 to 67 dunbar street parkhead t/n gla 1154. 17 croydon street, parkhead t/n gla 2484. 17/19 ewing place parkhead t/n gla 3416. 1262-1272 duke street and 3/15 croydon street and 1286/1288 duke street all above properties leased t/n gla 3697 in glasgow scotland.
    Persone aventi diritto
    • The Royal Bank of Scotland PLC
    Transazioni
    • 04 mar 1986Registrazione di un'ipoteca
    • 14 gen 1987Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Mortgage debenture
    Creato il 21 feb 1986
    Consegnato il 26 feb 1986
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Undertaking and all other property.
    Persone aventi diritto
    • National Commercial & Glyns Limited
    Transazioni
    • 26 feb 1986Registrazione di un'ipoteca
    • 14 gen 1987Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Standard security presented for registration in scotland on 4TH december 1985
    Creato il 04 dic 1985
    Consegnato il 11 dic 1985
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee in terms of a personal bond dated 29/11/85
    Brevi particolari
    Parkhead forge lying on the south, south west and west side of duke street, glasgow following the curve thereof title no gla 487, 1250/1256 duke street, 1291 gallowgate, glasgow and title no gla 798.
    Persone aventi diritto
    • The Royal Bank of Scotland PLC
    Transazioni
    • 11 dic 1985Registrazione di un'ipoteca
    • 14 gen 1987Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Mortgage debenture
    Creato il 29 nov 1985
    Consegnato il 04 dic 1985
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Persone aventi diritto
    • The Royal Bank of Scotland PLC
    Transazioni
    • 04 dic 1985Registrazione di un'ipoteca
    • 14 gen 1987Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Standard security presented for registration in scotland 31.10.85
    Creato il 23 ott 1985
    Consegnato il 13 nov 1985
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee
    Brevi particolari
    46/96 dunbar street and 37/67 dunbar street glasgow. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • The British Linen Bank Limited
    Transazioni
    • 13 nov 1985Registrazione di un'ipoteca
    • 09 gen 1986Registrazione di un'ipoteca
    Standard security presented for registration in scotland on the 31ST october 1985
    Creato il 03 set 1985
    Consegnato il 13 nov 1985
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee
    Brevi particolari
    17 croydon street, glasgow. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • The British Linen Bank Limited
    Transazioni
    • 13 nov 1985Registrazione di un'ipoteca
    • 09 gen 1986Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Standard security
    Creato il 25 feb 1985
    Consegnato il 07 mar 1985
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee
    Brevi particolari
    The subject lying in the city of glasgow. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • The British Linen Bank Limited
    Transazioni
    • 07 mar 1985Registrazione di un'ipoteca
    • 09 gen 1986Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Debenture
    Creato il 25 feb 1985
    Consegnato il 06 mar 1985
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Persone aventi diritto
    • The British Linen Bank Limited
    Transazioni
    • 06 mar 1985Registrazione di un'ipoteca
    • 09 gen 1986Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)

    Fonte dati

    • Companies House del Regno Unito
      Il registro ufficiale delle imprese nel Regno Unito, che fornisce l'accesso pubblico alle informazioni sulle imprese, come nomi, indirizzi, amministratori e depositi finanziari.
    • Licenza: CC0